Actos BORME de Geonet Territorial Sa
31 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. D. Gerente: ROMERO GARCIA MARIOLA. Revocaciones. Apo.Manc.: ROMERO GARCIA MARIOLA. Apo.Sol.:ROMERO GARCIA MARIOLA. Nombramientos. D. Gerente: EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIAMARIA. Apo.Sol.: EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO. Apo.Manc.: EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO. Datos registrales. T
18 de Abril de 2022Ceses/Dimisiones. D. Gerente: BARBER PONT PEDRO JUAN. Revocaciones. Apo.Manc.: BARBER PONT PEDRO. Apo.Sol.:BARBER PONT PEDRO. Datos registrales. T 4314 , F 184, S 8, H A 74440, I/A 34 ( 6.04.22).
26 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: BALLESTER ESPINOSA ADRIAN. Nombramientos. Consejero: NAVARRO CABALLERO JUAN DEDIOS. Datos registrales. T 4314 , F 184, S 8, H A 74440, I/A 33 (18.01.22).
29 de Diciembre de 2021Nombramientos. D. Gerente: ROMERO GARCIA MARIOLA. Apo.Sol.: ROMERO GARCIA MARIOLA. Apo.Manc.: GOMEZ GARCIAMARIA;ROMERO GARCIA MARIOLA. Datos registrales. T 4314 , F 182, S 8, H A 74440, I/A 32 (22.12.21).
28 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES. Vicesecret.: SANCHEZ SALA ENCARNACIONDOLORES. Nombramientos. Consejero: BELSO MARTINEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4314 , F 182, S 8, H A 74440,I/A 31 (21.12.21).
14 de Octubre de 2020Fe de erratas: Rectificada la escritura que motivó la inscripción 29ª en cuanto al domicilio y el NIF de la consejera doña María GómezGarcía, siendo el correcto el siguiente: calle Perpetuo Socorro, número 1, 1º, Almoradí, con NIF 74190059V. Datos registrales. T4314 , F 182, S 8, H A 74440, I/A 30 ( 5.10.20).
03 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES. Consejero: SANCHEZ PEREZ CESAR;MORANTCLIMENT ALEJANDRO;SENDRA MENGUAL FRANCISCO JAVIER;SERRANO RODRIGUEZ FANNY;SEPULCRE GONZALEZFERNANDO;ARACIL LLORENS MANUEL;SALA MENARGUES CRISTOBAL;BALLESTER ESPINOSA ADRIAN. Presidente:SANCHEZ PEREZ CESAR. Vicepresid.: MORANT CLIMENT ALEJANDRO. Consejero: SAVAL FERRANDO JUANBAUTISTA;PENALVA CASANOVA JOSE MANUEL;PEREZ ANTON RAQUEL;BONILLA GAVILANES JOSE MANUEL.
31 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARRIGOS JUAN ANTONIO MANUEL. VsecrNoConsj: DURA BERENGUER FRANCISCO.Nombramientos. SecreNoConsj: SOLER MESTRE JOSE HILARIO. VsecrNoConsj: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES.Datos registrales. T 4026 , F 216, S 8, H A 74440, I/A 28 (23.05.18).
06 de Abril de 2018Fe de erratas: El poder conferido a favor de don Pedro Juan Barber Pont en la inscripción 27 es de fecha 17 marzo 2017 y no 21marzo 2017 como por error se hizo constar. Datos registrales. T 3528 , F 103, S 8, H A 74440, I/A 27 ( 4.04.17).
12 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. D. Gerente: EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO. Revocaciones. Apoderado: EUGENIO LATORRE JUANEDUARDO. Apo.Manc.: MORANT CLIMENT ALEJANDRO;EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO. Nombramientos. Apoderado:BARBER PONT PEDRO JUAN. Apo.Manc.: MORANT CLIMENT ALEJANDRO. D. Gerente: BARBER PONT PEDRO JUAN.Apo.Manc.: BARBER PONT PEDRO JUAN. Datos registrales. T 3528 , F 103, S 8, H A 74440, I/A 27 ( 4.04.17).
01 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO. Apo.Manc.: DE JUAN NAVARRO MANUEL;MARCO CAMACHOMANUEL ISIDRO;EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO. Nombramientos. Apoderado: EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO.Apo.Manc.: MORANT CLIMENT ALEJANDRO;EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO. Datos registrales. T 3528 , F 101, S 8, H A74440, I/A 26 (23.11.16).
28 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ SALA ENCARNACION DOLORES. Nombramientos. Consejero: PENALVA CASANOVAJOSE MANUEL;PEREZ ANTON RAQUEL;BONILLA GAVILANES JOSE MANUEL. Modificaciones estatutarias. Artículo 16º.Representación de los socios. Artículo 19º. Número de consejeros y duración. Datos registrales. T 3528 , F 100, S 8, H A 74440, I/A25 (21.09.16).
20 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: PASTOR LILLO LUISA;ASENCIO ADSUAR CESAR AUGUSTO;ALBALADEJO MARTINEZJOAQUIN;SOLER MUR ALEJANDRO;CERDAN PASTOR DAVID;DE JUAN NAVARRO MANUEL;BALLESTER ESPINOSAADRIAN;MARCO CAMACHO MANUEL ISIDRO. Presidente: PASTOR LILLO LUISA. Vicepresid.: ASENCIO ADSUAR CESARAUGUSTO. Consejero: DE JUAN NAVARRO MANUEL. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ PEREZ CESAR;MORANTCLIMENT ALEJANDRO;SENDRA MENGUAL FRANCISCO JAVIER;SERRANO RODRIGUEZ FANNY;SEPULCRE GONZALEZFERNANDO;DE JUAN NAVARRO MANUEL;ARACIL LLORENS MANUEL;SALA MENARGUES CRISTOBAL;SANCHEZ SALAENCARNACION DOLORES;BALLESTER ESPINOSA ADRIAN. Presidente: SANCHEZ PEREZ CESAR. Vicepresid.: MORANTCLIMENT ALEJANDRO. Consejero: SAVAL FERRANDO JUAN BAUTISTA. Reelecciones. SecreNoConsj: GARRIGOS JUANANTONIO MANUEL. VsecrNoConsj: DURA BERENGUER FRANCISCO. Datos registrales. T 3528 , F 100, S 8, H A 74440, I/A 24(11.07.16).
02 de Agosto de 2012Cambio de domicilio social. PLAZA DE SAN CRISTOBAL 1 (ALICANTE). Datos registrales. T 3528 , F 100, S 8, H A 74440, I/A 23(24.07.12).
29 de Diciembre de 2011Nombramientos. D. Gerente: EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO. Apo.Sol.: EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO. Apo.Manc.:DE JUAN NAVARRO MANUEL;MARCO CAMACHO MANUEL ISIDRO;EUGENIO LATORRE JUAN EDUARDO. Datos registrales. T3528 , F 98, S 8, H A 74440, I/A 22 (20.12.11).
27 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ CUCHILLO FRANCISCO ESTEBAN;GONZALEZ CUCHILLO FRANCISCOESTEBAN;GONZALEZ CUCHILLO FRANCISCO ESTEBAN. Datos registrales. T 3528 , F 98, S 8, H A 74440, I/A 21 (15.12.11).
22 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: RIPOLL SERRANO JOSE JOAQUIN. Presidente: RIPOLL SERRANO JOSE JOAQUIN. Consejero:JIMENEZ EGEA MARIA DEL CARMEN;LOPEZ GARRIDO JOSE;SEMPERE JAEN MARIA TERESA;LLANOS BLASCOALBERTO;FLUXA CEVA JOSE MARIA;TRIGUEROS SELLES JOSE FRANCISCO;ROVIRA DE OSSO JUAN;SANUS SELLESRAFAEL. Vicepresid.: LLANOS BLASCO ALBERTO. Consejero: ROMERO PONCE PEDRO. SecreNoConsj: PARDO DE AMOSMARIA DOLORES. Nombramientos. Consejero: PASTOR LILLO LUISA;ASENCIO ADSUAR CESAR AUGUSTO;ALBALADEJOMARTINEZ JOAQUIN;SOLER MUR ALEJANDRO;CERDAN PASTOR DAVID;DE JUAN NAVARRO MANUEL;BALLESTERESPINOSA ADRIAN;MARCO CAMACHO MANUEL ISIDRO. SecreNoConsj: GARRIGOS JUAN ANTONIO MANUEL. VsecrNoConsj:DURA BERENGUER FRANCISCO. Presidente: PASTOR LILLO LUISA. Vicepresid.: ASENCIO ADSUAR CESAR AUGUSTO. Datosregistrales. T 3528 , F 97, S 8, H A 74440, I/A 20 ( 9.12.11).
30 de Mayo de 2011Declaración de unipersonalidad. Socio único: SUMA GESTION TRIBUTARIA. DIPUTACION DE ALICANTE. Otros conceptos:Modificación de los estatutos sociales. Datos registrales. T 2612 , F 220, S 8, H A 74440, I/A 19 (19.05.11).
09 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MAGRANER MORENO FRANCISCO JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: PARDO DEAMOS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 2612 , F 220, S 8, H A 74440, I/A 18 (26.04.11).
26 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MAZON GUIXOT CARLOS. Nombramientos. Consejero: ROMERO PONCE PEDRO. Datosregistrales. T 2612 , F 220, S 8, H A 74440, I/A 17 (14.07.10).
18 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CUCHILLO FRANCISCO ESTEBAN. Datos registrales. T 2612 , F 220, S 8, H A 74440,I/A 16 ( 8.02.10).
29 de Abril de 2009Nombramientos. Auditor: COMPAÑIA GENERAL DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 2612 , F 220, S 8, H A 74440, I/A 15(15.04.09).
23 de Abril de 2009Cambio de objeto social. La generación de sistemas de información geográfica para los municipios y especialmente el desarrollo delas siguientes actividades: Realización de todo tipo de proyectos en las áreas de la ingeniería, Cartografía digital, Informática yTratamiento de Imágenes, incluyendo la captación y proceso de d. Datos registrales. T 2612 , F 202, S 8, H A 74440, I/A 14 (8.04.09).