Buscador CIF Logo

Actos BORME Geriatros Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Geriatros Sa

Actos BORME Geriatros Sa - A36780245

Tenemos registrados 143 Actos BORME del Registro Mercantil de Pontevedra para Geriatros Sa con CIF A36780245

馃敊 Perfil de Geriatros Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Pontevedra

Actos BORME de Geriatros Sa

23 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 107, S 8, H PO 12763, I/A 185 (13.11.23).

08 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: LORENZO GALLEDO LUCIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 107, S 8, H PO 12763, I/A 184(27.10.23).

07 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: PASTOR RIVERA CRISTINA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 107, S 8, H PO 12763, I/A 183(27.10.23).

10 de Octubre de 2023
Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 106, S 8, HPO 12763, I/A 182 ( 2.10.23).

18 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPO PARGA EVA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 106, S 8, H PO 12763, I/A 181 ( 8.08.23).

17 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: SOLLA TORRES JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 106, S 8, H PO 12763, I/A 180 (8.08.23).

20 de Junio de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: ALZAMORA CA脩ERO ELENA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 103, S 8, H PO 12763, I/A 175(12.06.23).

02 de Junio de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 103, S 8, H PO 12763,I/A 174 (22.05.23).

23 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: MOSQUERA MERLAN SONIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 103, S 8, H PO 12763, I/A 172(15.05.23).

18 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: ABASCAL CASTA脩ON ALVARO MARIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 103, S 8, H PO 12763,I/A 171 ( 8.05.23).

11 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 103, S 8, H PO 12763, I/A 170 (2.05.23).

18 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ PARDI脩AS LUCIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 102, S 8, H PO 12763, I/A 169 (10.04.23).

11 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: ALLIKA ZABALBEASKOACON EUKEN. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 102, S 8, H PO 12763, I/A168 (28.03.23).

31 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA ELENA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 102, S 8, H PO 12763, I/A 167(23.03.23).

28 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 101, S 8, H PO 12763, I/A 166(16.03.23).

10 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: SARASOLA FERNANDEZ ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE PRIEGO RIVERA LUISARMANDO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 101, S 8, H PO 12763, I/A 165 ( 2.02.23).

05 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: BARBEITO CERNADAS BERTA MARIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 100, S 8, H PO 12763, I/A162 (25.11.22).

Revocaciones. Apo.Sol.: GRA脩A MONROY FERNANDO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 101, S 8, H PO 12763, I/A 163(25.11.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: OTERO FERNANDEZ MARIA ISABEL. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 101, S 8, H PO 12763, I/A164 (25.11.22).

21 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIA脩EZ MARIA TERESA.Datos registrales. T 4208, L 4208, F 100, S 8, H PO 12763, I/A 161 (14.11.22).

07 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS.Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 99, S 8, H PO 12763, I/A 159(27.10.22).

03 de Agosto de 2022
Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENSANTONI. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 99, S 8, H PO 12763, I/A 158 (26.07.22).

01 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: MOZAS POVEDA JOAQUINA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 98, S 8, H PO 12763, I/A 157(20.07.22).

27 de Julio de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 97, S 8, H PO 12763, I/A155 (18.07.22).

Nombramientos. Apoderado: TABOADA VAZQUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 98, S 8, H PO 12763, I/A 156(20.07.22).

21 de Julio de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: CAMPO PARGA EVA;CAMPO PARGA EVA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 96, S 8, H PO 12763,I/A 154 (14.07.22).

13 de Junio de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: GRA脩A MONROY FERNANDO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 96, S 8, H PO 12763, I/A 153 (6.06.22).

03 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREIRA CARRIL FABIAN. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 96, S 8, H PO 12763, I/A 152(21.04.22).

26 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: SUAREZ MARTINEZ XOXE HADRIAN. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 95, S 8, H PO 12763, I/A151 (18.04.22).

11 de Abril de 2022
Nombramientos. Apoderado: INAREJOS GIL DOMINGO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 95, S 8, H PO 12763, I/A 149(31.03.22).

Nombramientos. Apoderado: ALFARAZ PALOMINO CRISTINA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 95, S 8, H PO 12763, I/A 150(31.03.22).

15 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: COLINA DE LA FUENTE VIRGINIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 95, S 8, H PO 12763, I/A 148 (7.03.22).

22 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: ENTRENAS DELGADO RUBEN. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 94, S 8, H PO 12763, I/A 147(11.02.22).

18 de Enero de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: GERIAVI SA. Datosregistrales. T 4208, L 4208, F 94, S 8, H PO 12763, I/A 146 ( 7.01.22).

16 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPO PARGA EVA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 94, S 8, H PO 12763, I/A 145 ( 3.12.21).

10 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: SARASOLA FERNANDEZ ALBERTO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 93, S 8, H PO 12763, I/A144 (29.11.21).

04 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 93, S 8, H PO 12763, I/A 143(26.10.21).

03 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 91, S 8, H PO 12763, I/A 142(22.10.21).

26 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 91, S 8, H PO 12763, I/A 141(15.10.21).

21 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 90, S 8, H PO 12763, I/A 140(13.10.21).

19 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 90, S 8, H PO 12763, I/A 139 ( 7.10.21).

05 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO CERVANTES OLGA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 89, S 8, H PO 12763, I/A 137(24.09.21).

04 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: SOCIAS FUSTER ANDREU. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 90, S 8, H PO 12763, I/A 138(24.09.21).

25 de Agosto de 2021
Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 89, S 8, H PO 12763, I/A 136(17.08.21).

24 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: ROSALES VELARDE INMACULADA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 89, S 8, H PO 12763, I/A 135(16.06.21).

10 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: REYES PONCE MONICA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 88, S 8, H PO 12763, I/A 134 ( 2.06.21).

07 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 88, S 8, H PO 12763, I/A 133(27.05.21).

06 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 88, S 8, H PO12763, I/A 131 (26.04.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: ESTEVEZ GARCIA MARIA PILAR. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 88, S 8, H PO 12763, I/A 132(26.04.21).

07 de Abril de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: NU脩EZ GRANADOS BLANCA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 87, S 8, H PO 12763, I/A 130(26.03.21).

25 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CASCO BEATRIZ. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 87, S 8, H PO 12763, I/A 129(16.11.20).

28 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: SERRATIO MARTINEZ JAVIER. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 87, S 8, H PO 12763, I/A 127(21.09.20).

Revocaciones. Apo.Sol.: ISASI MARTINEZ ALBERT. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 87, S 8, H PO 12763, I/A 128 (21.09.20).

11 de Septiembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: DOMINGO TORRA LAURA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 86, S 8, H PO 12763, I/A 126 (4.09.20).

10 de Agosto de 2020
Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 86, S 8, H PO12763, I/A 124 ( 4.08.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPO PARGA EVA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 86, S 8, H PO 12763, I/A 125 ( 4.08.20).

07 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 86, S 8, H PO 12763, I/A 123(31.07.20).

16 de Julio de 2020
Nombramientos. Apoderado: ORTEGA RECIO ANGELA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 85, S 8, H PO 12763, I/A 122 (

26 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 85, S 8, H PO12763, I/A 121 (22.06.20).

24 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 85, S 8, H PO 12763, I/A 120(18.06.20).

19 de Junio de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: MU脩OZ FERNANDEZ ELENA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 85, S 8, H PO 12763, I/A 119(12.06.20).

13 de Abril de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 84, S 8, H PO 12763, I/A 118 (3.04.20).

19 de Febrero de 2020
Ampliacion del objeto social. La explotaci贸n y/o gesti贸n de las instalaciones dedicadas a residencia, asilo, cuidados psiqui谩tricos,geri谩tricos, j贸venes y ancianos, con o sin hospitalizaci贸n. La asistencia en cl铆nicas para personas con discapacidad intelectual,enfermedad mental y drogodependencia. La formaci贸n y el perfecciona. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 84, S 8, H PO 12763,I/A 117 (10.02.20).

13 de Enero de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: MARI脩O GARCIA VIRGINIA MARIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 84, S 8, H PO 12763, I/A 116( 3.01.20).

23 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 84, S 8, H PO 12763, I/A 115(15.10.19).

23 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ MC COLLUM RAQUEL. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 83, S 8, H PO 12763, I/A 114(17.09.19).

27 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: CANCELO ALVAREZ LAURA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 83, S 8, H PO 12763, I/A 113(19.08.19).

04 de Junio de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: ALAMANCOS SOBRIDO MIGUEL. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 82, S 8, H PO 12763, I/A 111(27.05.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO GONZALEZ ASUNCION. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 83, S 8, H PO 12763, I/A 112(27.05.19).

27 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 82, S 8, H PO 12763, I/A 110(16.05.19).

13 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 82, S 8, H PO 12763, I/A 109 ( 7.05.19).

03 de Abril de 2019
Otros conceptos: Rectificaci贸n de la inscripci贸n 105陋 en cuanto a los apellidos de la apoderada. Se hizo constar como Do帽a RocioMARTINEZ CRUZ cuando en realidad el nombre correcto es DO脩A ROCIO MARTIN CRUZ. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 81,S 8, H PO 12763, I/A 107 (27.03.19).

Revocaciones. Apoderado: TARRIDA IBARS EVA MARIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 81, S 8, H PO 12763, I/A 108(27.03.19).

08 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ ALBA RAFAEL. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ NAVARRO EVA MARIA. Datosregistrales. T 4208, L 4208, F 81, S 8, H PO 12763, I/A 106 ( 1.03.19).

26 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ CRUZ ROCIO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 81, S 8, H PO 12763, I/A 105(19.02.19).

05 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: CORTES LOPEZ NATIVIDAD. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 80, S 8, H PO 12763, I/A 102(29.01.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: RIOS FAGUNDO RODRIGO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 80, S 8, H PO 12763, I/A 103(29.01.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: FRAGUEIRO VILANOVA MARIA ALEJANDRA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 80, S 8, H PO12763, I/A 104 (29.01.19).

16 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 78, S 8, H PO 12763, I/A 99 (8.11.18).

Revocaciones. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 79, S 8, H PO 12763, I/A 100 (9.11.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 79, S 8, H PO 12763, I/A 101 (12.11.18).

14 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: ISASI MARTINEZ ALBERT. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 78, S 8, H PO 12763, I/A 98 ( 5.11.18).

11 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ CASTRO ANGELA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 78, S 8, H PO 12763, I/A 97 (3.10.18).

30 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ALONSO LUIS MANUEL. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 77, S 8, H PO 12763, I/A 96(20.07.18).

24 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 77, S 8, H PO 12763,I/A 95 (17.07.18).

18 de Julio de 2018
Revocaciones. Apoderado: ISASI PEREZ I脩AKI. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 77, S 8, H PO 12763, I/A 94 (12.07.18).

02 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 76, S 8, H PO 12763, I/A 93(26.06.18).

12 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 76, S 8, H PO 12763, I/A 92 (6.06.18).

20 de Abril de 2018
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GONZALEZ RAQUEL. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 76, S 8, H PO 12763, I/A 90(11.04.18).

Nombramientos. Apoderado: MONTEJANO BERMUDEZ MARIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 76, S 8, H PO 12763, I/A 91(11.04.18).

16 de Abril de 2018
Otros conceptos: Modificaci贸n del art铆culo 7 de los estatutos sociales, relativo a la transmisibilidad de las acciones, y modificaci贸n delart铆culo 11 de los estatutos sociales, relativo al usufructo y prenda de acciones sociales. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 75, S 8,H PO 12763, I/A 89 ( 5.04.18).

16 de Marzo de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: NASEIRO RAMUDO PAULO;CALVO GONZALEZ MARIA ASUNCION;VILLAVERDE MARTINEZ ANAISABEL;FIUZA MU脩OZ DANIEL;GARCIA CARRERA SANDRA;MORENO ALMENDRO SONIA;VILLAMARIN FERNANDEZ MARIALUISA;GOMEZ GOMEZ GEMA;RODRIGUEZ TABOADA ALBERTO;SOLLA TORRES JOSE MANUEL;PEREZ FERNANDEZ JOSEMANUEL;GIRALDEZ VAZQUEZ ANA MARIA;LEIS CARRIL ROSA MARIA;BLANCO VAZQUEZ LAURA;FONDO CUNDINSSUSANA;CASTRO RODRIGUEZ RAQUEL;BARBEITO CERNADAS BERTA MARIA;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;IGLESIASEIRIN SARA;FERNANDEZ LORENZO DIEGO;LOPEZ CORZO MARISOL;FERNANDEZ SANJURJO RAQUEL;SARRATO MARTINEZFRANCISCO JAVIER;VAZQUEZ PI脩EIRO RAFAEL ALBERTO;ALVAREZ DELGADO RAFAEL JUAN;MARTINEZ ALBARAFAEL;RODRIGUEZ MOLGUERO PETRA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 74, S 8, H PO 12763, I/A 88 ( 9.03.18).

12 de Marzo de 2018
Revocaciones. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 74, S 8, H PO 12763, I/A 86 (2.03.18).

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 74, S 8, H PO 12763, I/A 87 ( 2.03.18).

21 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apoderado: CALVARRO ORDAS SILVIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 74, S 8, H PO 12763, I/A 84(12.02.18).

19 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 73, S 8, H PO 12763, I/A81 (12.02.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 73, S 8, H PO 12763, I/A 82(12.02.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 74, S 8, H PO 12763, I/A83 (12.02.18).

16 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 72, S 8, H PO 12763, I/A 80 ( 9.02.18).

15 de Noviembre de 2017
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GERIAVI SA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 72, S 8, H PO12763, I/A 79 ( 7.11.17).

04 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 72, S 8, H PO 12763, I/A 78(25.08.17).

31 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apoderado: ISASI PEREZ I脩AKI. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 71, S 8, H PO 12763, I/A 77 (24.08.17).

30 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 119, S 8, H PO 12763, I/A 71(21.08.17).

Nombramientos. Apoderado: VILLAVERDE MARTINEZ ANA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 70, S 8, H PO 12763, I/A 72(23.08.17).

Nombramientos. Apoderado: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 70, S 8, H PO 12763, I/A 73 (23.08.17).

Nombramientos. Apoderado: ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 70, S 8, H PO 12763, I/A 74(23.08.17).

Nombramientos. Apoderado: DOMINGO TORRA LAURA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 70, S 8, H PO 12763, I/A 75(23.08.17).

Nombramientos. Apoderado: CARVARRO ORDAS SILVIA. Datos registrales. T 4208, L 4208, F 71, S 8, H PO 12763, I/A 76(23.08.17).

25 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 117, S 8, H PO 12763, I/A 67(18.08.17).

Nombramientos. Apoderado: TABOADA VAZQUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 118, S 8, H PO 12763, I/A 68(18.08.17).

Nombramientos. Apoderado: BRAVO ARAGON PEDRO. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 118, S 8, H PO 12763, I/A 69(18.08.17).

Nombramientos. Apoderado: MOZAS POVEDA JOAQUINA. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 119, S 8, H PO 12763, I/A 70(18.08.17).

24 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apoderado: ABASCAL CASTA脩ON ALVARO MARIA. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 114, S 8, H PO 12763,I/A 65 (17.08.17).

Nombramientos. Apoderado: TARRIDA IBARS EVA MARIA. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 117, S 8, H PO 12763, I/A 66(17.08.17).

28 de Julio de 2017
Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 113, S 8, H PO 12763, I/A 62 (20.07.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN MARI脩O MARIA;DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 4199, L 4199, F 114, S 8, H PO 12763, I/A 63 (24.07.17).

Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;RODRIGUEZ MARTINEZISABEL;PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 114, S 8, H PO 12763, I/A 64 (24.07.17).

26 de Julio de 2017
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 110, S 8, H PO 12763, I/A 61(19.07.17).

25 de Julio de 2017
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 110, S 8, H PO 12763, I/A 60(18.07.17).

26 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 110, S 8, H PO 12763, I/A 58(16.06.17).

Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 110, S 8, H PO 12763, I/A 59(19.06.17).

23 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 3599, L 3599, F 119, S 8, H PO 12763, I/A 57(15.06.17).

22 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 3599, L 3599, F 119, S 8, H PO 12763, I/A 56(14.06.17).

21 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 3599, L 3599, F 116, S 8, H PO 12763, I/A 55(14.06.17).

20 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 3599, L 3599, F 113, S 8, H PO 12763, I/A 54(12.06.17).

22 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS IV SLU;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II SLU;MAGNUMBUSINESS DIRECTORS III SLU;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SLU;FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA.Vicesecret.:BARCENA ARTEAGABEITIA RAMON. SecreNoConsj: EGERIQUE MOSQUERA PABLO. Vsecr2.NC: RITA RARIS FILGUEIRA.Presidente: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SLU. Con.Delegado: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA. Nombramientos. Adm.Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6, 16, 21, 22 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales.T 3599, L 3599, F 112, S 8, H PO 12763, I/A 53 (15.10.15).

25 de Agosto de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 225, S 8, H PO 12763, I/A 51 (17.08.15).

Revocaciones. Secretario: GIL-ROBLES CASANUEVA JOSE MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj: EGERIQUE MOSQUERAPABLO. Vsecr2.NC: RITA RARIS FILGUEIRA. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 225, S 8, H PO 12763, I/A 52 (17.08.15).

24 de Febrero de 2015
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 225, S 8, H PO 12763, I/A50 (16.02.15).

29 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CORDERO DE LA LASTRA JOSE CARLOS;GUTIERREZ OIS JUAN MANUEL;SANCHEZ MONGEISAAC. SecreNoConsj: LOPEZ CORONA VAZQUEZ XOAN. VsecrNoConsj: VARELA VARAS ANGEL. Presidente: VAZQUEZSACRISTAN MARIA VICTORIA. Nombramientos. Secretario: GIL-ROBLES CASANUEVA JOSE MARIA. Vicesecret.: BARCENAARTEAGABEITIA RAMON. Consejero: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SLU;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS IISLU;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SLU;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS IV SLU;FERNANDEZ MIGUELEZJOSEFINA.Presidente: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I SLU. Con.Delegado: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA.Modificaciones estatutarias. =Art铆culo 21. ORGANO DE ADMINISTRACION= =21.1 Representaci贸n= El Organo de Administraci贸nde la Sociedad es el encargado de dirigir, administrar y representar a la Sociedad en el 谩mbito del objeto social, pudiendo deliberar,resolver y obrar con entera libertad en todo aquello que por Ley o por. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 221, S 8, H PO 12763, I/A42 (16.11.12).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 24.- RETRIBUCION. El cargo de mero Consejero no ser谩 retribuido, todo ello sin perjuiciode la satisfacci贸n delos gastos de viaje en los que incurran en el ejercicio de su cargo previa justificaci贸n de los mismos. No obstante loanterior, el Consejero Delegado percibir谩, como remuneraci贸n. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 223, S 8, H PO 12763, I/A 43(16.11.12).

Revocaciones. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA JESUS;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;FERNANDEZ MIGUELEZJOSEFINA;MORENO ALMENDRO SONIA. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 221, S 8, H PO 12763, I/A 44 (16.11.12).

Nombramientos. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 223, S 8, H PO 12763, I/A 45(16.11.12).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: INVERSIONES SOCICARE SL. Datos registrales. T 3438, L 3438,F 223, S 8, H PO 12763, I/A 46 (16.11.12).

Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 4.- Duraci贸n, comienzo de operaciones y ejercicio social .- LaSociedad tendr谩 una duraci贸n indefinida y dio comienzo a sus operaciones el dia de su constituci贸n. El ejercicio social se iniciar谩 el diaprimero de octubre y terminar谩 el treinta de septiembre de. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 224, S 8, H PO 12763, I/A 47(16.11.12).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 224, S 8, H PO 12763, I/A 48 (19.11.12).

02 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 221, S 8, H PO 12763, I/A 41 (21.12.11).

24 de Noviembre de 2011
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: NCG BANCO SA. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 221, S 8, HPO 12763, I/A 40 (14.11.11).

16 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Secretario: SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA. Nombramientos. VsecrNoConsj: VARELA VARAS ANGEL.SecreNoConsj: LOPEZ CORONA VAZQUEZ XOAN. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 221, S 8, H PO 12763, I/A 39 ( 6.06.11).

01 de Marzo de 2011
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CAIXA DE AFORROS DE GALICIA VIGO OURENSE E PONTEVE.Datos registrales. T 3438, L 3438, F 220, S 8, H PO 12763, I/A 38 (16.02.11).

10 de Diciembre de 2009
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ABRENTE GESTORA GALICIA SL. MILENIUM GRUPO GERONTOLOGICO SL.Datos registrales. T 3438, L 3438, F 220, S 8, H PO 12763, I/A 37 (27.11.09).

04 de Mayo de 2009
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE & TOUCHE ESPA脩A SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTESL. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 219, S 8, H PO 12763, I/A 35 (22.04.09).

Ceses/Dimisiones. Secretario: BARCENA ARTEAGABEITIA RAMON. Vicesecret.: RUIZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Secretario: SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA. Datos registrales. T 3438, L 3438, F 220, S 8, H PO 12763, I/A 36

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n