Actos BORME de Geriavi Sa
07 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 25, S 8, H PO 59295,I/A 62 (27.10.23).
30 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CA脩ERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4203, L 4203,F 24, S 8, H PO 59295, I/A 61 (23.10.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIA脩EZ MARIA TERESA.Datos registrales. T 4203, L 4203, F 23, S 8, H PO 59295, I/A 58 (14.11.22).
02 de Noviembre de 2022Ceses/Dimisiones. Secretario: CUETO FAUS JOSE LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: TARDIN SANCHEZ CAROLINA.Datos registrales. T 4203, L 4203, F 22, S 8, H PO 59295, I/A 56 (24.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL;SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENSANTONI;FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 22, S 8, H PO59295, I/A 55 (26.07.22).
27 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 21, S 8, H PO 59295, I/A54 (18.07.22).
27 de Enero de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 20, S 8, H PO 59295, I/A 53(20.01.22).
19 de Enero de 2022Otros conceptos: EMISION DE UN TITULO MULTIPLE, representativo de 7.694.684 acciones de la Sociedad, n煤meros 59.093.253 a66.787.936, inclusive, que representar谩 el t铆tulo m煤ltiple n煤mero 5, que se entrega al accionista 煤nico. Datos registrales. T 4203, L4203, F 12, S 8, H PO 59295, I/A 41.1 M ( 4.01.22).
12 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: GUERRA FAGALDE LORENZO IGNACIO. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 18, S 8, H PO 59295,I/A 52 ( 3.01.22).
17 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Con.Delegado: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Nombramientos. Consejero: PENA RODRIGUEZ JOSE MARIA. Con.Delegado: PENA RODRIGUEZ JOSE MARIA. Otrosconceptos: Se modifica el Art铆culo 18潞 de los estatutos sociales, en lo relativo a la retribuci贸n del cargo de Administradores. Datosregistrales. T 4203, L 4203, F 15, S 8, H PO 59295, I/A 51 ( 1.12.21).
25 de Agosto de 2021Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4203, L 4203,F 15, S 8, H PO 59295, I/A 50 (17.08.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 15, S 8, H PO 59295, I/A 49(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 15, S 8, H PO59295, I/A 47 (26.04.21).
07 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 14, S 8, H PO 59295, I/A 46(31.07.20).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 14, S 8, H PO59295, I/A 45 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 14, S 8, H PO 59295, I/A 44 (18.06.20).
13 de Mayo de 2020Emisi贸n de obligaciones. Comisario: - Importe de la emisi贸n: 115.000.000,00 Euros. 30.03.20. Datos registrales. T 4203, L 4203, F12, S 8, H PO 59295, I/A 43 ( 6.05.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL;SOLER VICENS ANTONI;FABRE MATHIEU IVES ANDREMARIE. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 12, S 8, H PO 59295, I/A 43 ( 6.05.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 12, S 8, H PO 59295, I/A 42 ( 3.04.20).
17 de Febrero de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 7.694.684,00 Euros. Desembolsado: 7.694.684,00 Euros. Resultante Suscrito: 66.787.936,00 Euros.Resultante Desembolsado: 66.787.936,00 Euros. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 11, S 8, H PO 59295, I/A 41 ( 6.02.20).
13 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: DELANNOY BERTRAND PAUL LUCIEN. Presidente: DELANNOY BERTRAND PAUL LUCIEN.
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 11, S 8, H PO 59295, I/A 39 (15.10.19).
23 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ MC COLLUM RAQUEL. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 11, S 8, H PO 59295, I/A 38
29 de Julio de 2019Revocaciones. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 10, S 8, H PO 59295, I/A 37 (19.07.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 10, S 8, H PO 59295, I/A 36(16.05.19).
24 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: HENIN AYMAR MARIE HENRI. Presidente: HENIN AYMAR MARIE HENRI. Nombramientos.Consejero: DELANNOY BERTRAND PAUL LUCIEN. Presidente: DELANNOY BERTRAND PAUL LUCIEN. Datos registrales. T 4203,L 4203, F 10, S 8, H PO 59295, I/A 35 (12.04.19).
16 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 9, S 8, H PO 59295, I/A 34 (12.11.18).
12 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 8, S 8, H PO 59295, I/A 33 (5.11.18).
16 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: THIBEAU LAURENT JEAN. Nombramientos. Consejero: FABRE MATHIEU IVES ANDRE MARIE.Datos registrales. T 4203, L 4203, F 8, S 8, H PO 59295, I/A 32 ( 9.07.18).
12 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 8, S 8, H PO 59295, I/A 31 (6.06.18).
18 de Mayo de 2018Revocaciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 8, S 8, H PO 59295, I/A 29 ( 9.05.18).
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 8, S 8,H PO 59295, I/A 30 ( 9.05.18).
03 de Mayo de 2018Revocaciones. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 8, S 8, H PO 59295, I/A 28(25.04.18).
28 de Marzo de 2018Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 7, S 8, H PO 59295, I/A 27 (20.03.18).
19 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 7, S 8, H PO 59295, I/A24 (12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 7, S 8, H PO 59295, I/A 25(12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 7, S 8, H PO 59295, I/A26 (12.02.18).
02 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4203, L4203, F 6, S 8, H PO 59295, I/A 23 (25.01.18).
15 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: CONCHILLO ARMENDARIZ FEDERICO;MURIES FENOLL LAURA. Presidente: CONCHILLOARMENDARIZ FEDERICO. SecreNoConsj: EGERIQUE MOSQUERA PABLO. VsecrNoConsj: PEREZ CALLEJO MANUEL.Nombramientos. Consejero: THIBEAU LAURENT JEAN;HENIN AYMAR MARIE HENRI. Presidente: HENIN AYMAR MARIE HENRI.Secretario: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 6, S 8, H PO 59295, I/A 22 ( 7.11.17).
24 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 5, S 8, H PO 59295, I/A 21(16.08.17).
21 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 5, S 8, H PO 59295, I/A 20 (9.08.17).
18 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: PICON GARCIA DE LEANIZ JUAN;CHAMORRO RODRIGUEZ ENRIQUE;VEGAS VICENTELUIS;GARCIA OLIVAN PABLO;NU脩O FERNANDEZ MONGE TERESA;GOMEZ FERRERO HECTOR. Datos registrales. T 4203, L4203, F 4, S 8, H PO 59295, I/A 19 ( 9.08.17).
28 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 4, S 8, H PO 59295, I/A 16 (20.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN MARI脩O MARIA;DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 4203, L 4203, F 4, S 8, H PO 59295, I/A 17 (24.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;RODRIGUEZ MARTINEZISABEL;PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 4, S 8, H PO 59295, I/A 18 (24.07.17).
26 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 4, S 8, H PO 59295, I/A 15
18 de Julio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 1, S 8, H PO 59295, I/A 12(10.07.17).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 4, S 8, H PO 59295, I/A 13(10.07.17).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4203, L 4203, F 4, S 8, H PO 59295, I/A 14(10.07.17).
17 de Julio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4080, L 4080, F 101, S 8, H PO 59295, I/A 11(10.07.17).
15 de Febrero de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 8.300.000,00 Euros. Desembolsado: 8.300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 59.093.252,00 Euros.Resultante Desembolsado: 59.093.252,00 Euros. Datos registrales. T 4080, L 4080, F 101, S 8, H PO 59295, I/A 10 ( 8.02.17).
30 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4080, L 4080, F 100, S 8, H PO 59295, I/A 9 (20.01.17).
25 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 4080, L 4080, F 100, S 8, H PO 59295, I/A 8(16.11.16).
12 de Julio de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 40.000.000,00 Euros. Desembolsado: 40.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 50.793.252,00Euros. Resultante Desembolsado: 50.793.252,00 Euros. Datos registrales. T 4080, L 4080, F 100, S 8, H PO 59295, I/A 7 ( 4.07.16).
18 de Marzo de 2016Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: INVERSIONES SOCICARE SL. Datos registrales. T 4080, L 4080, F 98, S 8, H PO59295, I/A 5 ( 9.03.16).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MURIES FENOLL LAURA;CONCHILLO ARMENDARIZ FEDERICO. Nombramientos.SecreNoConsj: EGERIQUE MOSQUERA PABLO. VsecrNoConsj: PEREZ CALLEJO MANUEL. Consejero: CONCHILLOARMENDARIZ FEDERICO;MURIES FENOLL LAURA;FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Presidente: CONCHILLOARMENDARIZ FEDERICO. Con.Delegado: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 4080, L 4080, F 99, S 8, H PO 59295,I/A 6 ( 9.03.16).
23 de Febrero de 2016Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4080, L 4080, F 98, S 8, H PO 59295, I/A 4 (15.02.16).
30 de Noviembre de 2015Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 (VIGO). Datos registrales. T 4080, L 4080, F 90, S 8, H PO 59295, I/A 1(23.11.15).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 4 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T4080, L 4080, F 97, S 8, H PO 59295, I/A 2 (23.11.15).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 6 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 4080, L 4080, F 97, S 8, H PO 59295,I/A 3 (23.11.15).
21 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Datos registrales. T 33698 , F 63, S 8, H M 606623, I/A 7( 8.10.15).
29 de Septiembre de 2015Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 45.000,00 Euros. Datos registrales. T 33698 , F 62, S 8, H M 606623, I/A 6(22.09.15).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 10.733.252,00 Euros. Desembolsado: 10.733.252,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.793.252,00Euros. Resultante Desembolsado: 10.793.252,00 Euros. Datos registrales. T 33698 , F 62, S 8, H M 606623, I/A 7 (22.09.15).