Actos BORME de Germaine De Capuccini Sa
28 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: PONS TALENS ANA;GINER PASTOR JOSE REMIGIO. Datos registrales. T 4492 , F 209, S 8, H A2880, I/A 59 (20.12.23).
25 de Agosto de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4492 , F 209, S 8, H A 2880, I/A 58 (16.08.23).
30 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ PAZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4492 , F 209, S 8, H A 2880, I/A 57 (22.05.23).
21 de Noviembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: LINDEMANN STEFAN ALEXANDER. Nombramientos. Consejero: SEMMLER MARCOS JORGE.Datos registrales. T 4492 , F 209, S 8, H A 2880, I/A 56 (11.11.22).
12 de Agosto de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4212 , F 103, S 8, H A 2880, I/A 55 ( 4.08.22).
02 de Junio de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: GINER PASTOR JOSE REMIGIO;SEGUI LLODRA JOSE MARIA;PONS TALENS ANA.Nombramientos. Apo.Man.Soli: PONS TALENS ANA;LOPEZ PAZ MIGUEL ANGEL;GINER PASTOR JOSE REMIGIO. Datosregistrales. T 4212 , F 101, S 8, H A 2880, I/A 54 (26.05.22).
14 de Enero de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: PONS TALENS ANA. Datos registrales. T 4212 , F 99, S 8, H A 2880, I/A 53 ( 5.01.21).
06 de Noviembre de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4212 , F 99, S 8, H A 2880, I/A 52 (28.10.19).
30 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apoderado: VIDAL VIDAL MARIA CARMEN. Datos registrales. T 4212 , F 99, S 8, H A 2880, I/A 51 (20.09.19).
19 de Septiembre de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MANDOR INVESTMENTS SL. Datos registrales. T 4212 , F 99, S 8, H A 2880, I/A50 (11.09.19).
14 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: GINER PASTOR JOSE REMIGIO;SEGUI LLODRA JOSE MARIA. Datos registrales. T 4212 , F 96,S 8, H A 2880, I/A 49 ( 3.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: SEGUI LLODRA JOSE MARIA;RODRIGUEZ PEREZ EUGENIO. Datos registrales. T 4212 , F 96, S 8, H A2880, I/A 48 ( 3.05.19).
09 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: VIDAL RUZ RAUL;GINER PASTOR JOSE REMIGIO. Secretario: GINER PASTOR JOSE REMIGIO.Presidente: VIDAL RUZ RAUL. Cons.Del.Sol: VIDAL RUZ RAUL. Consejero: VIDAL VIDAL JESUS. Nombramientos. SecreNoConsj:VAZQUEZ SENIN LORENA. VsecrNoConsj: ESPINOS GOZALVEZ LUCIA. Consejero: LLADO BERTRAND MARCOS JUAN.Presidente: LLADO BERTRAND MARCOS JUAN. Consejero: LINDEMANN STEFAN ALEXANDER;ASARTA BORGO脩O FRANCISCOJAVIER;PARRIZAS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER;PUENTE CUESTAS PABLO;NUEVA COMPA脩IA DE INVERSIONES SA.Otros conceptos: Modificaci贸n de la totalidad de los Estatutos Sociales Unificaci贸n de los derechos atribuidos a las acciones quecomponen el capital social, constituyendo una misma clase de acciones. Datos registrales. T 2946 , F 178, S 8, H A 2880, I/A 47(29.04.19).
18 de Febrero de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 216.360,00 Euros. Resultante Suscrito: 985.640,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importereducci贸n: 300.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 685.140,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 23潞.- Mayor铆a devotos. Datos registrales. T 2946 , F 178, S 8, H A 2880, I/A 46 (11.02.19).
08 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: PUYUELO CAZORLA CARLOS JOSE ALEJANDRO. Cons.Del.Sol: PUYUELO CAZORLA CARLOSJOSE ALEJANDRO. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 32潞.- Retribuci贸n de los miembros del Consejo de Administraci贸n.Datos registrales. T 2946 , F 178, S 8, H A 2880, I/A 45 (27.12.18).
17 de Julio de 2018Reelecciones. Consejero: VIDAL VIDAL JESUS. Datos registrales. T 2946 , F 146, S 8, H A 2880, I/A 44 ( 9.07.18).
04 de Julio de 2017Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: GERMIPIL SA. Datos registrales. T 2946 , F 146, S 8, H A 2880, I/A 43 (26.06.17).
18 de Abril de 2017Nombramientos. Cons.Del.Sol: VIDAL RUZ RAUL. Datos registrales. T 2946 , F 146, S 8, H A 2880, I/A 42 ( 6.04.17).
30 de Noviembre de 2016Modificaciones estatutarias. Art铆culo 18潞.- Convocatoria juntas.-. Datos registrales. T 2946 , F 146, S 8, H A 2880, I/A 41(22.11.16).
16 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: VIDAL VIDAL JESUS. Secretario: VIDAL RUZ RAUL. Nombramientos. Presidente: VIDAL RUZRAUL. Secretario: GINER PASTOR JOSE REMIGIO. Datos registrales. T 2946 , F 145, S 8, H A 2880, I/A 40 ( 8.11.16).
08 de Noviembre de 2016Nombramientos. Auditor: PRB AUDIT PARTNERS SLP. Aud.C.Con.: PRB AUDIT PARTNERS SLP. Datos registrales. T 2946 , F145, S 8, H A 2880, I/A 39 (31.10.16).
13 de Octubre de 2016Revocaciones. Apoderado: BALLESTER CRUSAT MONTSERRAT. Datos registrales. T 2946 , F 145, S 8, H A 2880, I/A 38 (5.10.16).
23 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: VIDAL RUZ RAUL. Secretario: VIDAL RUZ RAUL. Nombramientos. Consejero: GINER PASTORJOSE REMIGIO;VIDAL RUZ RAUL. Secretario: VIDAL RUZ RAUL. Datos registrales. T 2946 , F 145, S 8, H A 2880, I/A 37(16.09.16).
20 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: KOKURA VIDAL SL. Secretario: KOKURA VIDAL SL. Cons.Del.Sol: KOKURA VIDAL SL.Nombramientos. Consejero: VIDAL RUZ RAUL. Secretario: VIDAL RUZ RAUL. Datos registrales. T 2946 , F 145, S 8, H A 2880, I/A36 (12.05.16).
12 de Noviembre de 2015Reelecciones. Aud.C.Con.: G R AUDITORES SL. Datos registrales. T 2946 , F 145, S 8, H A 2880, I/A 35 ( 4.11.15).
11 de Noviembre de 2015Reelecciones. Aud.C.Con.: G R AUDITORES SL. Datos registrales. T 2946 , F 87, S 8, H A 2880, I/A 34 ( 2.11.15).
16 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: G R AUDITORES SL. Datos registrales. T 2946 , F 87, S 8, H A 2880, I/A 33 ( 7.10.15).
14 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: G R AUDITORES SL. Datos registrales. T 2946 , F 87, S 8, H A 2880, I/A 32 ( 5.10.15).
09 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: VIDAL VIDAL JESUS. Nombramientos. Cons.Del.Sol: PUYUELO CAZORLA CARLOS JOSEALEJANDRO. Datos registrales. T 2946 , F 87, S 8, H A 2880, I/A 31 (31.03.15).
18 de Noviembre de 2014Fe de erratas: Por sentencia 298/12 dictada el 18 de octubre de 2012 por el Magistrado Juez de lo Mercantil 1 de Alicante, don RafaelFuentes Devesa, se anula la modificaci贸n de los art铆culos 10, 21, 23 y 33 de los Estatutos acordada por la junta general de 1 deseptiembre de 2011, y que motiv贸 la inscripci贸n 19&. Datos registrales. T 2946 , F 87, S 8, H A 2880, I/A 30 ( 7.11.14).
17 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: VIDAL MASANET MARIA ANGELES. Nombramientos. Consejero: PUYUELO CAZORLA CARLOSJOSE ALEJANDRO. Datos registrales. T 2946 , F 86, S 8, H A 2880, I/A 29 ( 6.11.14).
03 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: KOKURA VIDAL SL;VIDAL MASANET MARIA ANGELES. Presidente: VIDAL MASANET MARIAANGELES. Secretario: KOKURA VIDAL SL. Nombramientos. Presidente: VIDAL VIDAL JESUS. Secretario: KOKURA VIDAL SL.Cons.Del.Sol: VIDAL VIDAL JESUS;KOKURA VIDAL SL. Datos registrales. T 2946 , F 86, S 8, H A 2880, I/A 27 (26.09.14).
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 12潞. Prenda de acciones. Datos registrales. T 2946 , F 86, S 8, H A 2880, I/A 28(29.09.14).
02 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: JORDA VIDAL IGNACIO. Presidente: VIDAL MASANET MARIA ANGELES. Secretario: JORDA VIDALIGNACIO. Cons.Del.Man: JORDA VIDAL IGNACIO. Vicepresid.: KOKURA VIDAL SL. Nombramientos. Presidente: VIDALMASANET MARIA ANGELES. Secretario: KOKURA VIDAL SL. Consejero: VIDAL VIDAL JESUS. Datos registrales. T 2946 , F 86, S8, H A 2880, I/A 26 (25.09.14).
16 de Mayo de 2014Otros conceptos: Nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 4 de abril de 2013, que no ha tenido acceso aeste Registro, por sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante, el d铆a 12 de marzo de 2014, instancia de AlhenaInternational Fitting Corporation. Datos registrales. T 2946 , F 85, S 8, H A 2880, I/A 25 ( 7.05.14).
20 de Enero de 2012Nombramientos. Auditor: G R AUDITORES SL. Aud.C.Con.: G R AUDITORES SL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo 18潞.-convocatoria junta. Datos registrales. T 2946 , F 85, S 8, H A 2880, I/A 23 (11.01.12).
07 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apoderado: VIDAL VIDAL JESUS. Datos registrales. T 2946 , F 85, S 8, H A 2880, I/A 22 (24.11.11).
05 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apoderado: BENEDICTO VIU JOSE LUIS. Datos registrales. T 2946 , F 85, S 8, H A 2880, I/A 21 (23.11.11).
13 de Octubre de 2011Nombramientos. Presidente: VIDAL MASANET MARIA ANGELES. Secretario: JORDA VIDAL IGNACIO. Vicepresid.: KOKURAVIDAL SL. Cons.Del.Man: KOKURA VIDAL SL;JORDA VIDAL IGNACIO;VIDAL MASANET MARIA ANGELES. Datos registrales. T2946 , F 85, S 8, H A 2880, I/A 20 ( 3.10.11).
10 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: VIDAL MASANET MARIA ANGELES. Vicesecret.: VIDAL MASANET MARIA ANGELES. Cons.Del.Sol:VIDAL VIDAL JESUS;VIDAL MASANET MARIA ANGELES. Consejero: VIDAL VIDAL JESUS;VIDAL VIDAL ROSARIO. Secretario:VIDAL VIDAL ROSARIO. Consejero: VIDAL VIDAL MARIA CARMEN. Presidente: VIDAL VIDAL JESUS. Vicepresid.: VIDAL VIDALMARIA CARMEN. Nombramientos. Consejero: VIDAL MASANET MARIA ANGELES;JORDA VIDAL IGNACIO;KOKURA VIDAL SL.Modificaciones estatutarias. Art铆culo 10潞. Transmisi贸n inter vivos. Art铆culo 21潞. Mayorias. Art铆culo 23潞. Mayorias. Art铆culo 33潞.-Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 2946 , F 83, S 8, H A 2880, I/A 19 (28.09.11).
08 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: VIDAL VIDAL JESUS. Nombramientos. Con.Delegado: VIDAL VIDAL JESUS;VIDAL MASANETMARIA ANGELES. Reelecciones. Consejero: VIDAL VIDAL JESUS;VIDAL VIDAL ROSARIO. Secretario: VIDAL VIDAL ROSARIO.Consejero: VIDAL VIDAL MARIA CARMEN. Presidente: VIDAL VIDAL JESUS. Vicepresid.: VIDAL VIDAL MARIA CARMEN. Datosregistrales. T 2946 , F 83, S 8, H A 2880, I/A 18 (26.10.10).
17 de Abril de 2009Nombramientos. Aud.C.Con.: VALLS-TRIVES AUDITORES SL. Datos registrales. T 2946 , F 83, S 8, H A 2880, I/A 17 ( 4.04.09).