Actos BORME de Germans Ferrer Ferrando Sl
10 de Febrero de 2023Revocaciones. ADM.CONJUNTO: FERRER FERRANDO MARIA INMACULADA;FERRER FERRANDO FERNANDO;FERRERFERRANDO CARLOS;FERRER FERRANDO JAVIER MOISES;FERRER FERRANDO PILAR. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.:FERRER FERRANDO CARLOS;FERRER FERRANDO FERNANDO;FERRER FERRANDO JAVIER MOISES;FERRER FERRANDOMARIA INMACULADA. Datos registrales. T 34257 , F 162, S 8, H B 246597, I/A 8 ( 6.02.23).
04 de Noviembre de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 19.040,00 Euros. Resultante Suscrito: 76.160,00 Euros. Datos registrales. T 34257 , F161, S 8, H B 246597, I/A 7 (26.10.22).
05 de Enero de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 19.040,00 Euros. Resultante Suscrito: 95.200,00 Euros. Datos registrales. T 34257 , F160, S 8, H B 246597, I/A 6 (29.12.16).
23 de Diciembre de 2016Revocaciones. ADM.CONJUNTO: FERRER FERRANDO JOSE RAMON. Datos registrales. T 34257 , F 160, S 8, H B 246597, I/A 5(15.12.16).
08 de Mayo de 2009Revocaciones. ADMINISTR.: FERRER SAAVEDRA RAMON. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: FERRER FERRANDO MARIAINMACULADA;FERRER FERRANDO FERNANDO;FERRER FERRANDO CARLOS;FERRER FERRANDO JAVIER MOISES;FERRERFERRANDO JOSE RAMON;FERRER FERRANDO PILAR. Modificaciones estatutarias. ART.19.- MODIFICACION EN LAESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 34257 , F 159, S 8, H B 246597, I/A 4(27.04.09).