Actos BORME de Germans Homs Lloguer De Maquinaria 1852 Sl
19 de Octubre de 2022Cambio de denominaci贸n social. HOMS RENTALS S.L. Datos registrales. T 45676 , F 212, S 8, H B 394996, I/A 17 (11.10.22).
18 de Marzo de 2022Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: KOMPE ELEVACIO SL. Datos registrales. T 43279 , F 44, S 8, H B 394996, I/A 16(11.03.22).
10 de Diciembre de 2021Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: LLOGUERS DEL TER S.L. Datos registrales. T 43279 , F 41, S 8, H B 394996, I/A15 (30.11.21).
17 de Septiembre de 2021Nombramientos. AUDIT.CUENT.: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 43279 , F 41, S 8, H B 394996, I/A 14 (10.09.21).
22 de Junio de 2021Revocaciones. CONSEJERO: SUMA CAPITAL INVEST I SL. REPR.143 RRM: ARROYO SIERRA DAVID. Nombramientos.CONSEJERO: SUMA CORPORATE SL. REPR.143 RRM: ARROYO SIERRA DAVID. Datos registrales. T 43279 , F 40, S 8, H B394996, I/A 13 (14.06.21).
22 de Octubre de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 10.937.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 937.500,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Capital: 62.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 43279 , F 39, S 8, H B 394996, I/A 12(15.10.19).
11 de Junio de 2019Revocaciones. CONSEJERO: SUMA CAPITAL PARTNERS SL. REPR.143 RRM: ARROYO SIERRA DAVID. Nombramientos.CONSEJERO: SUMA CAPITAL INVEST I SL. REPR.143 RRM: ARROYO SIERRA DAVID. Datos registrales. T 43279 , F 39, S 8, HB 394996, I/A 11 ( 3.06.19).
23 de Abril de 2019Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7,9,12,13,19,20 Y 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.CREACION DE CLASES DE PARTICIPACIONES. Datos registrales. T 41734 , F 199, S 8, H B 394996, I/A 10 (11.04.19).
09 de Octubre de 2018Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: S3M IBERIA SL. Datos registrales. T 41734 , F 197, S 8, H B 394996, I/A 9 (2.10.18).
23 de Agosto de 2018Nombramientos. APODERAD.SOL: HOMS COMAS VICENC;HOMS COMAS MARC. Datos registrales. T 41734 , F 196, S 8, H B394996, I/A 8 (14.08.18).
02 de Agosto de 2018Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: HOMS COMAS VICENTE;HOMS COMAS MARC. Nombramientos. CONSEJERO: HOMSCOMAS VICENC. PRESIDENTE: HOMS COMAS VICENC. CONSEJERO: HOMS COMAS MARC;RIERA MAS POL;SUMA CAPITALPARTNERS SL. REPR.143 RRM: ARROYO SIERRA DAVID. CONSEJERO: SUMA CAPITAL ASESORAMIENTO SL. REPR.143RRM: CEBRIAN VELEZ MANUEL. SECR.NO CONS: FOZ GIRALT XAVIER. V-SEC NO CON: BERMUDEZ GUTIERREZ JORDI.Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.375.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.875.000,00 Euros. Datos registrales. T 41734 , F 194,S 8, H B 394996, I/A 7 (25.07.18).
28 de Julio de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 41734 ,F 194, S 8, H B 394996, I/A 6 (20.07.17).
17 de Febrero de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. Datos registrales. T 41734 , F 193, S 8, H B394996, I/A 5 ( 7.02.17).
27 de Octubre de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.100.000,00 Euros. Datos registrales. T 41734 , F 193,S 8, H B 394996, I/A 4 (19.10.16).
01 de Agosto de 2016Cambio de domicilio social. CL FRANCESC LAYRET Num.10 (MATARO). Datos registrales. T 41734 , F 193, S 8, H B 394996, I/A3 (21.07.16).
24 de Abril de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.600.000,00 Euros. Datos registrales. T 41734 , F 192, S8, H B 394996, I/A 2 (16.04.15).
11 de Marzo de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 25.01.10. Objeto social: EL ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LACONSTRUCCION. Domicilio: CL JOSEP TRUETA, S/N (CABRERA DE MAR). Capital: 100.000,00 Euros. Nombramientos.