Actos BORME de Gero Vitalia Burgos Sl
10 de Octubre de 2023Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 76, S 8, H PO64698, I/A 45 ( 2.10.23).
16 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SARRATO MARTINEZ JAVIER. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 76, S 8, H PO 64698, I/A 44 (7.08.23).
04 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CA脩ERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276,F 75, S 8, H PO 64698, I/A 42 (26.07.23).
28 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA ELENA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 75, S 8, H PO 64698, I/A 41 (20.07.23).
27 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 75, S 8, H PO 64698,I/A 40 (18.07.23).
24 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO QUINTELA SANDRA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNA VALENZUELA MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 4276, L 4276, F 74, S 8, H PO 64698, I/A 39 (13.07.23).
16 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIA脩EZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 73, S 8, H PO 64698, I/A 36 (8.06.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 73, S 8, H PO 64698, I/A 37 (8.06.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 72, S 8, H PO 64698, I/A 35(14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 72, S 8, H PO64698, I/A 34 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 72, S 8, H PO64698, I/A 33 (26.07.22).
20 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: GERO VITALIA SL.Datos registrales. T 4276, L 4276, F 72, S 8, H PO 64698, I/A 32 (11.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 71, S 8, H PO 64698, I/A 31(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 70, S 8, H PO 64698, I/A 30(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 69, S 8, H PO 64698, I/A 29(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 69, S 8, H PO 64698, I/A 28 (13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 69, S 8, H PO 64698, I/A 27 ( 7.10.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 68, S 8, H PO 64698, I/A 26 ( 8.06.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 68, S 8, H PO 64698, I/A 25(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 68, S 8, H PO64698, I/A 24 (26.04.21).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 68, S 8, H PO64698, I/A 23 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 67, S 8, H PO 64698, I/A 22 (18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 67, S 8, H PO 64698, I/A 21 ( 3.04.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 67, S 8, H PO 64698, I/A 20 (15.10.19).
06 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 67, S 8, H PO 64698, I/A 19(30.05.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 67, S 8, H PO 64698, I/A 18(16.05.19).
22 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ CARRION JUANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 66, S 8, H PO 64698, I/A 17 (10.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 66, S 8, H PO 64698, I/A 16 ( 7.05.19).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 66, S 8, H PO 64698, I/A 15 ( 2.05.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MELON CASTRO MARIA JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 65, S 8, H PO 64698, I/A 13(28.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 66, S 8, H PO 64698, I/A 14 (28.03.19).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 65, S 8, H PO 64698,I/A 12 (22.03.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 214, S 8, H PO 64698, I/A 10(18.03.19).
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 208, S 8, H PO 64698, I/A 11(20.03.19).
26 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 213, S 8, H PO 64698, I/A 7(15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 213, S 8, H PO 64698,I/A 8 (15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;PRIETO DEL RIO SANDRA;ORTS SAN JOSEALFREDO;GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU;PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 213,S 8, H PO 64698, I/A 9 (18.03.19).
22 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 210, S 8, H PO 64698, I/A 4(13.03.19).
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 212, S 8, H PO 64698, I/A 5(14.03.19).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 212, S 8, H PO 64698, I/A 6(14.03.19).
20 de Marzo de 2019Revocaciones. Apoderado: ESPERILLA ALVAREZ MARIA ANGELA. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 209, S 8, H PO 64698,I/A 3 (12.03.19).
05 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 BAJOS (VIGO). Datos registrales. T 4267, L 4267, F 205, S 8, H PO64698, I/A 1 (29.01.19).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 3 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL, y MODIFICADO elart铆culo 30 de los estatutos sociales para establecer el car谩cter GRATUITO del 贸rgano de administraci贸n. Datos registrales. T 4267,L 4267, F 209, S 8, H PO 64698, I/A 2 (29.01.19).
17 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL. Datos registrales. T 1333 , F 162, S 8, H VA 21375, I/A 7 (10.01.19).
18 de Mayo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 144.960,00 Euros. Resultante Suscrito: 148.160,00 Euros. Datos registrales. T 1333 , F 162, S 8, HVA 21375, I/A 6 (10.05.16).
24 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Auditor: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1333 , F 162, S 8, H VA 21375, I/A 5 (17.12.15).
04 de Agosto de 2014Cambio de domicilio social. C/ FRANCISCO DE VITORIA 24 (ARROYO DE LA ENCOMIENDA). Datos registrales. T 1333 , F 162,S 8, H VA 21375, I/A 4 (28.07.14).
21 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: ESPERILLA ALVAREZ MARIA ANGELA. Datos registrales. T 1333 , F 161, S 8, H VA 21375, I/A 3(14.10.13).
22 de Agosto de 2013Nombramientos. Auditor: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1333 , F 161, S 8, H VA 21375, I/A 2 (14.08.13).