Actos BORME de Gero Vitalia Guadalajara Sl
28 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 200, S 8, H PO 64710,I/A 41 (20.12.23).
30 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CAÑERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276,F 200, S 8, H PO 64710, I/A 40 (23.10.23).
28 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 200, S 8, H PO 64710, I/A 39(20.09.23).
26 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIAÑEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 199, S 8, H PO 64710, I/A 38(19.09.23).
22 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apoderado: MOZAS POVEDA JOAQUINA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 199, S 8, H PO 64710, I/A 37(14.09.23).
24 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO QUINTELA SANDRA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNA VALENZUELA MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 4276, L 4276, F 198, S 8, H PO 64710, I/A 36 (13.07.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 198, S 8, H PO 64710, I/A 35(14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 197, S 8, HPO 64710, I/A 34 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 197, S 8, HPO 64710, I/A 33 (26.07.22).
09 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: OSUNA IZQUIERDO CESAR. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 197, S 8, H PO 64710, I/A 32(29.04.22).
18 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: INSTITUTO SOCIOSANITARIO SL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 197, S 8, H PO 64710, I/A 31 ( 7.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 196, S 8, H PO 64710, I/A 30(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 195, S 8, H PO 64710, I/A 29(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 194, S 8, H PO 64710, I/A 28(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 194, S 8, H PO 64710, I/A 27(13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 193, S 8, H PO 64710, I/A 26 ( 7.10.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 193, S 8, H PO 64710, I/A 25 ( 8.06.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 193, S 8, H PO 64710, I/A 24(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 193, S 8, H PO64710, I/A 23 (26.04.21).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 193, S 8, H PO64710, I/A 22 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 192, S 8, H PO 64710, I/A 21(18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 192, S 8, H PO 64710, I/A 20 (3.04.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 192, S 8, H PO 64710, I/A 19 (15.10.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 192, S 8, H PO 64710, I/A 18(16.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 192, S 8, H PO 64710, I/A 17 ( 7.05.19).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: OSUNA IZQUIERDO CESAR. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 191, S 8, H PO 64710, I/A 15(30.04.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 191, S 8, H PO 64710, I/A 16 (2.05.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MELON CASTRO MARIA JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 191, S 8, H PO 64710, I/A 13(28.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 191, S 8, H PO 64710, I/A 14 (28.03.19).
03 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 190, S 8, H PO 64710, I/A 12(28.03.19).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 220, S 8, H PO 64710,I/A 11 (22.03.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 74, S 8, H PO 64710, I/A 9(18.03.19).
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 218, S 8, H PO 64710, I/A 10(20.03.19).
26 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 73, S 8, H PO 64710, I/A 6(15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 73, S 8, H PO 64710, I/A7 (15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;PRIETO DEL RIOSANDRA;ORTS SAN JOSE ALFREDO;GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 73, S 8, H PO64710, I/A 8 (18.03.19).
22 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 69, S 8, H PO 64710, I/A 3 (13.03.19).
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 72, S 8, H PO 64710, I/A 4 (14.03.19).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 72, S 8, H PO 64710, I/A 5(14.03.19).
07 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 BAJOS (VIGO). Datos registrales. T 4268, L 4268, F 65, S 8, H PO64710, I/A 1 (30.01.19).
Otros conceptos: MODIFICADO el artículo 3 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL y MODIFICADO elartículo 30 de los estatutos sociales para establecer el carácter GRATUITO del órgano de administración. Datos registrales. T 4268,L 4268, F 69, S 8, H PO 64710, I/A 2 (30.01.19).
21 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL. Datos registrales. T 1337 , F 178, S 8, H VA 21532, I/A 7 (14.01.19).
03 de Octubre de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: INSTITUTO SOCIO SANITARIO SL. Datos registrales. T 1337 , F178, S 8, H VA 21532, I/A 6 (26.09.18).
30 de Enero de 2018Ampliación de capital. Capital: 120.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 814.176,00 Euros. Datos registrales. T 1337 , F 178, S 8, HVA 21532, I/A 5 (23.01.18).