Actos BORME de Gero Vitalia Monfarracinos Sl
10 de Octubre de 2023Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4461, L 4461, F 10, S 8, H PO64712, I/A 45 ( 2.10.23).
29 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4461, L 4461, F 10, S 8, H PO 64712, I/A44 (21.09.23).
16 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SARRATO MARTINEZ JAVIER. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 149, S 8, H PO 64712, I/A 43 (7.08.23).
04 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CA脩ERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4282, L 4282,F 149, S 8, H PO 64712, I/A 42 (26.07.23).
28 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA ELENA. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 149, S 8, H PO 64712, I/A 41 (20.07.23).
27 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 148, S 8, H PO 64712,I/A 40 (18.07.23).
24 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO QUINTELA SANDRA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNA VALENZUELA MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 4282, L 4282, F 147, S 8, H PO 64712, I/A 39 (13.07.23).
16 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIA脩EZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 146, S 8, H PO 64712, I/A 36 (8.06.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 146, S 8, H PO 64712, I/A 37 (8.06.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 146, S 8, H PO 64712, I/A 35(14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 146, S 8, HPO 64712, I/A 34 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 146, S 8, HPO 64712, I/A 33 (26.07.22).
20 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: GERO VITALIA SL.Datos registrales. T 4282, L 4282, F 145, S 8, H PO 64712, I/A 32 (11.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 145, S 8, H PO 64712, I/A 31(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 143, S 8, H PO 64712, I/A 30(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 142, S 8, H PO 64712, I/A 29(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 142, S 8, H PO 64712, I/A 28(13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 142, S 8, H PO 64712, I/A 27 ( 7.10.21).
14 de Octubre de 2021Otros conceptos: El socio 煤nico decide la modificaci贸n de los art铆culos 7潞 y 9潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 4282,L 4282, F 142, S 8, H PO 64712, I/A 26 ( 4.10.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 141, S 8, H PO 64712, I/A 25 ( 8.06.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 141, S 8, H PO 64712, I/A 24(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 141, S 8, H PO64712, I/A 23 (26.04.21).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 141, S 8, H PO64712, I/A 22 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 141, S 8, H PO 64712, I/A 21(18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 140, S 8, H PO 64712, I/A 20 (3.04.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 140, S 8, H PO 64712, I/A 19 (15.10.19).
06 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 140, S 8, H PO 64712, I/A 18(30.05.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4282, L 4282, F 140, S 8, H PO 64712, I/A 17(16.05.19).
22 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: NIETO GONZALEZ MARI CARMEN. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 164, S 8, H PO 64712, I/A 16(10.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 164, S 8, H PO 64712, I/A 15 ( 7.05.19).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 164, S 8, H PO 64712, I/A 14 (2.05.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MELON CASTRO MARIA JOSE. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 163, S 8, H PO 64712, I/A 12(28.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 164, S 8, H PO 64712, I/A 13 (28.03.19).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 163, S 8, H PO 64712,I/A 11 (22.03.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 87, S 8, H PO 64712, I/A 9(18.03.19).
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 160, S 8, H PO 64712, I/A 10(20.03.19).
26 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 86, S 8, H PO 64712, I/A 6(15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 86, S 8, H PO 64712, I/A7 (15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;PRIETO DEL RIOSANDRA;ORTS SAN JOSE ALFREDO;GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 87, S 8, H PO64712, I/A 8 (18.03.19).
22 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 82, S 8, H PO 64712, I/A 3 (13.03.19).
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 85, S 8, H PO 64712, I/A 4 (14.03.19).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 85, S 8, H PO 64712, I/A 5(14.03.19).
07 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 BAJOS (VIGO). Datos registrales. T 4268, L 4268, F 80, S 8, H PO64712, I/A 1 (30.01.19).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 3 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T4268, L 4268, F 82, S 8, H PO 64712, I/A 2 (30.01.19).
17 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL. Datos registrales. T 1395 , F 65, S 8, H VA 23879, I/A 6 (10.01.19).
18 de Mayo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 340.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 343.100,00 Euros. Datos registrales. T 1395 , F 64, S 8, HVA 23879, I/A 5 (10.05.16).
24 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Auditor: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1395 , F 64, S 8, H VA 23879, I/A 4 (17.12.15).
04 de Agosto de 2014Cambio de domicilio social. C/ FRANCISCO DE VITORIA 24 (ARROYO DE LA ENCOMIENDA). Datos registrales. T 1395 , F 64,S 8, H VA 23879, I/A 3 (28.07.14).
22 de Agosto de 2013Nombramientos. Auditor: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1395 , F 64, S 8, H VA 23879, I/A 2 (14.08.13).
12 de Abril de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 8.02.11. Objeto social: La promoci贸n, construcci贸n, explotaci贸n y gesti贸n, as铆 como elasesoramiento a terceros y el equipamiento de residencias para personas de la tercera edad y/o con minusval铆as o incapacidades,asistidas, no asistidas y mixtas,tanto para estancias permanentes como temporales, etc. Domicilio: C/ CA脩ADON 50 (ZARATAN).Capital: 3.100,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GERO VITALIA SL. Nombramientos. Adm. Unico:ORTEGA MESA DIEGO. Datos registrales. T 1395 , F 63, S 8, H VA 23879, I/A 1 ( 1.04.11).