Actos BORME de Gero Vitalia Ourense Sl
28 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 109, S 8, H PO 64726,I/A 40 (20.12.23).
30 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CA脩ERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276,F 109, S 8, H PO 64726, I/A 39 (23.10.23).
29 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 108, S 8, H PO 64726,I/A 38 (21.09.23).
28 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 107, S 8, H PO 64726, I/A 37(20.09.23).
26 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIA脩EZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 107, S 8, H PO 64726, I/A 36(19.09.23).
19 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO QUINTELA SANDRA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNA VALENZUELA MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 4276, L 4276, F 106, S 8, H PO 64726, I/A 35 ( 8.09.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 106, S 8, H PO 64726, I/A 34(14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 106, S 8, HPO 64726, I/A 33 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 106, S 8, HPO 64726, I/A 32 (26.07.22).
20 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: GERO VITALIA SL.Datos registrales. T 4276, L 4276, F 105, S 8, H PO 64726, I/A 31 (11.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 105, S 8, H PO 64726, I/A 30(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 103, S 8, H PO 64726, I/A 29(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 103, S 8, H PO 64726, I/A 28(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 102, S 8, H PO 64726, I/A 27(13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 102, S 8, H PO 64726, I/A 26 ( 7.10.21).
20 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 102, S 8, H PO 64726, I/A 25(12.07.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 102, S 8, H PO 64726, I/A 24 ( 8.06.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 101, S 8, H PO 64726, I/A 23(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 101, S 8, H PO64726, I/A 22 (26.04.21).
19 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: BLANCO VAZQUEZ LAURA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 101, S 8, H PO 64726, I/A 21 (7.01.21).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 101, S 8, H PO64726, I/A 20 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 100, S 8, H PO 64726, I/A 19(18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 100, S 8, H PO 64726, I/A 18 (3.04.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 100, S 8, H PO 64726, I/A 17 (15.10.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 100, S 8, H PO 64726, I/A 16(16.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 100, S 8, H PO 64726, I/A 15 ( 7.05.19).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 99, S 8, H PO 64726, I/A 14 ( 2.05.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MELON CASTRO MARIA JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 99, S 8, H PO 64726, I/A 12(28.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 99, S 8, H PO 64726, I/A 13 (28.03.19).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 98, S 8, H PO 64726,I/A 11 (22.03.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 222, S 8, H PO 64726, I/A 9(18.03.19).
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 225, S 8, H PO 64726, I/A 10(20.03.19).
26 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 221, S 8, H PO 64726, I/A 6(15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 222, S 8, H PO 64726,I/A 7 (15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;GUTIERREZ HERREROSARANTZAZU;PRIETO DEL RIO SANDRA;ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 222, S 8, H PO 64726,I/A 8 (18.03.19).
22 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 217, S 8, H PO 64726, I/A 3(13.03.19).
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 220, S 8, H PO 64726, I/A 4(14.03.19).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 221, S 8, H PO 64726, I/A 5(14.03.19).
08 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 BAJOS (VIGO). Datos registrales. T 4268, L 4268, F 215, S 8, H PO64726, I/A 1 (31.01.19).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 4 de los estatutos sociales correspondientes al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales.
21 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL. Datos registrales. T 1521 , F 129, S 8, H VA 29102, I/A 2 (14.01.19).
31 de Mayo de 2017Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 17.04.17. Objeto social: La promoci贸n, construcci贸n, explotaci贸n y gesti贸n, as铆 como elasesoramiento a terceros y el equipamiento de residencias para personas de la tercera edad/o minusval铆as o incapacidades, asistidas,no asistidas y mixtas, tanto para estancias permanentes como temporales, as铆 como de residencias de d铆as. Domicilio: C/ FRANCISCODE VITORIA 24 (ARROYO DE LA ENCOMIENDA). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GEROVITALIA SL. Nombramientos. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO. Datos registrales. T 1521 , F 127, S 8, H VA 29102, I/A 1(24.05.17).