Actos BORME de Gero Vitalia Sl
28 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 63, S 8, H PO 64763,I/A 45 (20.12.23).
07 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: ROMERO RODRIGUEZ ADELA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 63, S 8, H PO 64763, I/A 44(26.10.23).
30 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CA脩ERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276,F 63, S 8, H PO 64763, I/A 43 (23.10.23).
29 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 62, S 8, H PO 64763, I/A42 (21.09.23).
28 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 61, S 8, H PO 64763, I/A 41(20.09.23).
26 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIA脩EZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 61, S 8, H PO 64763, I/A 40(19.09.23).
19 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO QUINTELA SANDRA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNA VALENZUELA MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 4276, L 4276, F 60, S 8, H PO 64763, I/A 39 ( 8.09.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 60, S 8, H PO 64763, I/A 38(14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 60, S 8, H PO64763, I/A 37 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 60, S 8, H PO64763, I/A 36 (26.07.22).
19 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: GERIATROS SA.Datos registrales. T 4276, L 4276, F 60, S 8, H PO 64763, I/A 35 (10.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 59, S 8, H PO 64763, I/A 34(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 57, S 8, H PO 64763, I/A 33(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 57, S 8, H PO 64763, I/A 32(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 56, S 8, H PO 64763, I/A 31 (13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 56, S 8, H PO 64763, I/A 30 ( 7.10.21).
01 de Septiembre de 2021Otros conceptos: El socio 煤nico decide a帽adir el apartado IV) al articulo 6潞 de los estatutos sociales y a帽adir el art铆culo 6潞 bis a losmismos. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 56, S 8, H PO 64763, I/A 29 (24.08.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 56, S 8, H PO 64763, I/A 28 ( 8.06.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 56, S 8, H PO 64763, I/A 27(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 55, S 8, H PO64763, I/A 26 (26.04.21).
18 de Febrero de 2021Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: GERO VITALIA CALPE SL. GERO VITALIA CONSULTORES SL. GERO VITALIA LARIOJA SL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 55, S 8, H PO 64763, I/A 25 (10.02.21).
07 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 54, S 8, H PO 64763, I/A 24(31.07.20).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 54, S 8, H PO64763, I/A 23 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 54, S 8, H PO 64763, I/A 22 (18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 54, S 8, H PO 64763, I/A 21 ( 3.04.20).
06 de Febrero de 2020Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 54, S 8, H PO 64763, I/A 20 (31.01.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 53, S 8, H PO 64763, I/A 19 (15.10.19).
20 de Agosto de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 53, S 8, H PO 64763, I/A 18 (9.08.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 53, S 8, H PO 64763, I/A 17(16.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 53, S 8, H PO 64763, I/A 16 ( 7.05.19).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 52, S 8, H PO 64763, I/A 15 ( 2.05.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MELON CASTRO MARIA JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 52, S 8, H PO 64763, I/A 13(28.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 52, S 8, H PO 64763, I/A 14 (28.03.19).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 51, S 8, H PO 64763,I/A 12 (22.03.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 34, S 8, H PO 64763, I/A 10(18.03.19).
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 37, S 8, H PO 64763, I/A 11(20.03.19).
26 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 33, S 8, H PO 64763, I/A 7(15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 34, S 8, H PO 64763, I/A8 (15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PRIETO DEL RIO SANDRA;PITEL MENDEZ MARIAEUGENIA;ORTS SAN JOSE ALFREDO;GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 34, S 8, H PO
22 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 30, S 8, H PO 64763, I/A 4 (13.03.19).
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 33, S 8, H PO 64763, I/A 5 (14.03.19).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 33, S 8, H PO 64763, I/A 6(14.03.19).
20 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: HERNAIZ DEL CAMPO FELIX;HERNAIZ DEL CAMPO FELIX. Datos registrales. T 4270, L 4270, F 29, S8, H PO 64763, I/A 3 (12.03.19).
15 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 BAJOS (VIGO). Datos registrales. T 4270, L 4270, F 20, S 8, H PO64763, I/A 1 ( 7.02.19).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 2 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T4270, L 4270, F 29, S 8, H PO 64763, I/A 2 ( 7.02.19).
30 de Enero de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GERIATROS SA. Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GONZALEZ MAESTRO
31 de Enero de 2017Nombramientos. Aud.C.Con.: IN AUDIT GRUPO AUDITOR CONSULTOR SLP. Datos registrales. T 1390 , F 111, S 8, H VA 21335,I/A 15 (24.01.17).
24 de Diciembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 399.980,00 Euros. Resultante Suscrito: 828.500,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: SIGLO RESIDENCIAL SL. Datos registrales. T 1390 , F 110, S 8, H VA 21335, I/A 12 (17.12.15).
Ceses/Dimisiones. Auditor: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1390 , F 111, S 8, H VA 21335, I/A 13 (17.12.15).
Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1390 , F 111, S 8, H VA 21335, I/A 14(17.12.15).
17 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GERO CAPITALIA SL. Presidente: GERO CAPITALIA SL. Consejero: ROMERO RODRIGUEZADELA. Vicepresid.: ROMERO RODRIGUEZ ADELA. Consejero: ESPERILLA ALVAREZ MARIA ANGELA;CONSTRUCCIONESZENON HERNAIZ SA;ASESORES GRO SL. Nombramientos. Consejero: GERO CAPITALIA SL;ROMERO RODRIGUEZADELA;GERONTORIOJA GLOBAL SL;SADORI GLOBAL SLPresidente: GERO CAPITALIA SL. Vicepresid.: ROMERO RODRIGUEZADELA. Vicesecret.: ROMERO RODRIGUEZ ADELA. Reelecciones. SecreNoConsj: GONZALEZ MAESTRO CARLOS. Datosregistrales. T 1390 , F 110, S 8, H VA 21335, I/A 11 (10.03.15).
25 de Septiembre de 2014Cambio de domicilio social. C/ FRANCISCO DE VITORIA 24 (ARROYO DE LA ENCOMIENDA). Datos registrales. T 1390 , F 110,S 8, H VA 21335, I/A 10 (18.09.14).
01 de Abril de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO RODRIGUEZ ADELA. Datos registrales. T 1390 , F 109, S 8, H VA 21335, I/A 9 (25.03.14).
22 de Agosto de 2013Nombramientos. Auditor: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1390 , F 109, S 8, H VA 21335, I/A 7 (14.08.13).
Nombramientos. Aud.C.Con.: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1390 , F 109, S 8, H VA 21335, I/A 8 (14.08.13).
03 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA MESA DIEGO;HERNAIZ DEL CAMPO FELIX. Datos registrales. T 1390 , F 109, S 8, H VA21335, I/A 6 (25.03.13).
09 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORTEGA MESA DIEGO;GARCIA ESPERILLA DANIEL. Nombramientos. SecreNoConsj:GONZALEZ MAESTRO CARLOS. Consejero: GERO CAPITALIA SL. Presidente: GERO CAPITALIA SL. Consejero: ROMERORODRIGUEZ ADELA. Vicepresid.: ROMERO RODRIGUEZ ADELA. Consejero: ESPERILLA ALVAREZ MARIAANGELA;CONSTRUCCIONES ZENON HERNAIZ SA;ASESORES GRO SL. Otros conceptos: Nueva redacci贸n de los EstatutosSociales de la entidad. Datos registrales. T 1332 , F 210, S 8, H VA 21335, I/A 4 (28.02.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA MESA DIEGO;HERNAIZ DEL CAMPO FELIX. Datos registrales. T 1390 , F 109, S 8, H VA21335, I/A 5 (28.02.11).
04 de Febrero de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 424.920,00 Euros. Resultante Suscrito: 428.520,00 Euros. Datos registrales. T 1332 , F 210, S 8, HVA 21335, I/A 3 (26.01.10).
20 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTEGA MESA DIEGO;MINGUEZ PEROTE CARLOS FERNANDO;GARCIA ESPERILLA DANIEL.Con.Delegado: ORTEGA MESA DIEGO. Nombramientos. Adm. Solid.: ORTEGA MESA DIEGO;GARCIA ESPERILLA DANIEL.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datosregistrales. T 1332 , F 209, S 8, H VA 21335, I/A 2 (11.11.09).