Actos BORME de Gerplex Sa
22 de Febrero de 2023Revocaciones. ADM.CONCURS.: RCD CONCURSAL SLP. REP.ADM.CONC: ALBIOL PLANS JORDI. Otros conceptos:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 885/2020, AUTOFIRME DE FECHA 23/01/2023, CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD. Extinci贸n. Datos registrales. T 44168 , F 170,S 8, H B 55622, I/A 59 (15.02.23).
03 de Diciembre de 2021Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO885/2020, AUTO FIRME DE FECHA 20/10/2021, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DE LASOCIEDAD. Datos registrales. T 44168 , F 169, S 8, H B 55622, I/A 58 (26.11.21).
15 de Enero de 2021Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO885/2020, AUTO FIRME DE FECHA 01/07/2020, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION.Datos registrales. T 44168 , F 163, S 8, H B 55622, I/A 57 ( 8.01.21).
20 de Agosto de 2020Revocaciones. ADM.UNICO: CID JUNCOSA GERMAN MARIA. Nombramientos. ADM.CONCURS.: RCD CONCURSAL SLP.REP.ADM.CONC: ALBIOL PLANS JORDI. Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 885/2020, AUTO FIRME DE FECHA 28/05/2020, DECLARACIONDE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. Disoluci贸n. Judicial. Datosregistrales. T 44168 , F 162, S 8, H B 55622, I/A 56 (13.08.20).
11 de Octubre de 2019Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CROWE AUDITORES ESPA脩A SLP. Datos registrales. T 44168 , F 162, S 8, H B 55622, I/A 55 (3.10.19).
08 de Junio de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: LLADO POLA JORGE. Datos registrales. T 44168 , F 161, S 8, H B 55622, I/A 54 (31.05.17).
21 de Marzo de 2017Revocaciones. ADM.UNICO: CID JUNCOSA GERMAN MARIA. Nombramientos. ADM.UNICO: CID JUNCOSA GERMAN MARIA.Datos registrales. T 44168 , F 161, S 8, H B 55622, I/A 53 ( 9.03.17).
30 de Marzo de 2016Revocaciones. APODERADO: MARTI PIDELASERRA JORDI;LLADO POLA JORGE. Datos registrales. T 44168 , F 161, S 8, H B55622, I/A 52 (17.03.16).
21 de Diciembre de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 44168 , F 161, S 8, H B 55622, I/A 51(10.12.15).
12 de Febrero de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: LLADO POLA JORGE. Datos registrales. T 38168 , F 20, S 8, H B 55622, I/A 50 ( 4.02.14).
16 de Septiembre de 2013Modificaciones estatutarias. ART.6.- CREACION DE LA PAGINA WEG CORPORATIVA: www.gerplex.com. ART.21.-CONVOCATORIA JUNTA GENERAL. ART.31.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. P谩ginaweb de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.gerplex.com. Datos registrales. T 38168 , F 20, S 8, H B 55622,
24 de Junio de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 399.665,00 Euros. Desembolsado: 399.665,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.074.115,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.074.115,00 Euros. Datos registrales. T 38168 , F 19, S 8, H B 55622, I/A 48 (13.06.13).
29 de Abril de 2013Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 38168 , F 19, S 8, H B 55622, I/A 47(22.04.13).
27 de Febrero de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 432.720,00 Euros. Desembolsado: 432.720,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.674.450,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.674.450,00 Euros. Datos registrales. T 38168 , F 19, S 8, H B 55622, I/A 46 (20.02.13).
31 de Octubre de 2012Revocaciones. APODERADO: PUIGDOLLERS VIVES SONIA. Datos registrales. T 38168 , F 18, S 8, H B 55622, I/A 45 (19.10.12).
05 de Octubre de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 41,84 Euros. Resultante Suscrito: 2.071.106,10 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:170.623,90 Euros. Desembolsado: 170.623,90 Euros. Resultante Suscrito: 2.241.730,00 Euros. Resultante Desembolsado:2.241.730,00 Euros. Datos registrales. T 38168 , F 18, S 8, H B 55622, I/A 44 (26.09.12).
24 de Mayo de 2012Cambio de domicilio social. CR SANTA CREU DE CALAFELL NUM.77-FONOLLARD NORD (SANT BOI DE LLOBREGAT). Datosregistrales. T 38168 , F 18, S 8, H B 55622, I/A 43 (14.05.12).
19 de Abril de 2012Revocaciones. ADM.UNICO: CID JUNCOSA GERMAN MARIA. Nombramientos. ADM.UNICO: CID JUNCOSA GERMAN MARIA.Datos registrales. T 38168 , F 17, S 8, H B 55622, I/A 42 ( 3.04.12).
14 de Julio de 2011Revocaciones. APODERADO: ROYUELA SALA SANTIAGO. Datos registrales. T 38168 , F 16, S 8, H B 55622, I/A 39 ( 4.07.11).
Revocaciones. APODERADO: RODRIGUEZ ESCOBAR PEDRO. Datos registrales. T 38168 , F 16, S 8, H B 55622, I/A 40 (4.07.11).
Nombramientos. APODERADO: PUIGDOLLERS VIVES SONIA. Datos registrales. T 38168 , F 16, S 8, H B 55622, I/A 41 (4.07.11).
28 de Mayo de 2010Nombramientos. APODERADO: CID ESTRADA CLAUDIA. Datos registrales. T 38168 , F 15, S 8, H B 55622, I/A 37 (18.05.10).
Nombramientos. APODERADO: LLADO POLA JORGE;FERRER VALLS JUAN JOSE. Datos registrales. T 38168 , F 15, S 8, H B55622, I/A 38 (18.05.10).
04 de Enero de 2010Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 38168 , F 14, S 8, H B 55622, I/A 36(22.12.09).