Actos BORME de Geryvida De Extremadura Sa
27 de Enero de 2023Reelecciones. Consejero: CRESPO MARQUEZ MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPOMARIA LUISA;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Presidente:PINILLA CRESPO VALENTIN. Secretario: PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Cons.Del.Sol: PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLACRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Datos registrales. T785, L 612, F 224, S 8, H CC 9516, I/A 24 (18.01.23).
31 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: CARRETERO ACEVEDO FRANCISCO LUIS;FERNANDEZ MARTINEZ RICARDO JAVIER. Datosregistrales. T 785, L 612, F 224, S 8, H CC 9516, I/A 23 (23.05.22).
17 de Enero de 2022Nombramientos. Auditor: PLAN AUDIT SL. Datos registrales. T 785, L 612, F 224, S 8, H CC 9516, I/A 22 (20.12.21).
24 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: PLAN AUDIT SL. Datos registrales. T 785, L 612, F 224, S 8, H CC 9516, I/A 21 ( 9.01.19).
18 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPOMARIA LUISA;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Presidente:PINILLA FERNANDEZ VALENTIN. Secretario: PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Cons.Del.Sol: PINILLA FERNANDEZVALENTIN;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ.Nombramientos. Consejero: CRESPO MARQUEZ MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLACRESPO MARIA LUISA;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ.Presidente: PINILLA CRESPO VALENTIN. Secretario: PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Cons.Del.Sol: PINILLA CRESPOVALENTIN;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ.Datos registrales. T 785, L 612, F 220, S 8, H CC 9516, I/A 20 (10.07.18).
04 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPOMARIA LUISA;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Presidente:PINILLA FERNANDEZ VALENTIN. Cons.Del.Sol: PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;PINILLA CRESPOCESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Secretario: PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO. Nombramientos.Consejero: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO MARIA LUISA;PINILLACRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Presidente: PINILLA FERNANDEZVALENTIN. Secretario: PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Datos registrales. T 785, L 612, F 218, S 8, H CC 9516, I/A 18(27.03.17).
Nombramientos. Cons.Del.Sol: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESARAUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Datos registrales. T 785, L 612, F 218, S 8, H CC 9516, I/A 19 (27.03.17).
03 de Noviembre de 2016Nombramientos. Auditor: PLAN AUDIT SL. Datos registrales. T 785, L 612, F 218, S 8, H CC 9516, I/A 17 (19.10.16).
12 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CARRETERO ACEVEDO FRANCISCO LUIS. Nombramientos. Secretario: PINILLA CRESPOCESAR AUGUSTO. Datos registrales. T 785, L 612, F 218, S 8, H CC 9516, I/A 16 (20.04.15).
26 de Junio de 2013Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ampliación de capital. Suscrito: 1.540.000,00 Euros. Desembolsado: 1.540.000,00Euros. Resultante Suscrito: 3.340.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 3.340.000,00 Euros. Datos registrales. T 785, L 612, F217, S 8, H CC 9516, I/A 15 (15.06.13).
04 de Junio de 2013Nombramientos. Auditor: PLAN AUDIT SL. Datos registrales. T 785, L 612, F 217, S 8, H CC 9516, I/A 14 (28.05.13).
22 de Mayo de 2013Ampliacion del objeto social. El diseño y realización de acciones formativas relacionadas con su actividad. Datos registrales. T785, L 612, F 217, S 8, H CC 9516, I/A 13 (13.05.13).
16 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPOVALENTIN;PINILLA CRESPO MARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ;CARRETERO ACEVEDO FRANCISCOLUIS;VALIENTE CANCHO FERNANDO. Presidente: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN. Cons.Del.Sol: PINILLA FERNANDEZVALENTIN;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESAR AUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. SecreNoConsj:CARRETERO ACEVEDO FRANCISCO LUIS. Nombramientos. Consejero: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;PINILLA CRESPOMARIA DEL CARMEN;PINILLA CRESPO MARIA LUISA;PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA CRESPO CESARAUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Presidente: PINILLA FERNANDEZ VALENTIN. SecreNoConsj: CARRETEROACEVEDO FRANCISCO LUIS. Datos registrales. T 785, L 612, F 214, S 8, H CC 9516, I/A 11 ( 2.02.12).
Nombramientos. Cons.Del.Sol: PINILLA CRESPO VALENTIN;PINILLA FERNANDEZ VALENTIN;PINILLA CRESPO CESARAUGUSTO;PINILLA CRESPO MARIA BEATRIZ. Datos registrales. T 785, L 612, F 215, S 8, H CC 9516, I/A 12 ( 2.02.12).
13 de Diciembre de 2011Otros conceptos: Modificación de plazo de incentivos regionales, que finalizará el 26/06/2013. Datos registrales. T 738, L 565, F97, S 8, H CC 9516, I/A 1 8 (29.11.11).
14 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: GARCIA MOLANO ANA BELEN. Datos registrales. T 785, L 612, F 210, S 8, H CC 9516, I/A 10(28.02.11).
08 de Septiembre de 2010Otros conceptos: Modificación de plazo de incentivos regionales. El plazo finalizará el día 26.06.2011. Datos registrales. T 738, L565, F 97, S 8, H CC 9516, I/A 1 6 (31.08.10).
25 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: CARRETERO ACEVEDO FRANCISCO LUIS. Consejero: CRIADO DIAZ ANTONIO. Revocaciones.Apo.Sol.: CRIADO DIAZ ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: CARRETERO ACEVEDO FRANCISCO LUIS. Datosregistrales. T 785, L 612, F 209, S 8, H CC 9516, I/A 9 ( 4.03.10).
05 de Junio de 2009Nombramientos. Apoderado: GARCIA MOLANO JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 785, L 612, F 183, S 8, H CC 9516, I/A 8(23.05.09).
25 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MARTINEZ RICARDO JAVIER. Datos registrales. T 785, L 612, F 183, S 8, H CC 9516,I/A 7 (12.02.09).