Buscador CIF Logo

Actos BORME Gesblanca 2020 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gesblanca 2020 Sl

Actos BORME Gesblanca 2020 Sl - B73578437

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Gesblanca 2020 Sl con CIF B73578437

馃敊 Perfil de Gesblanca 2020 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Gesblanca 2020 Sl

16 de Agosto de 2023
Nombramientos. Cons.Del.Man: JUAN MARIN GARCIA. Datos registrales. T 3563 , F 180, S 8, H MU 68429, I/A 13 ( 8.08.23).

14 de Octubre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON. Presidente: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON.Cons.Del.Man: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON. Consejero: PASCUAL HERRERA ORTEGA. Secretario: PASCUAL HERRERAORTEGA. Consejero: JUAN MARIN GARCIA. Cons.Del.Man: JUAN MARIN GARCIA. Consejero: RAMON HERRERAORTEGA;GARCIA RIBON JULIO ANTONIO;ANGEL GIMENO FLETA;MANUEL HERRERA ROMERO;JUAN MANUEL RIVASMONGE;JUAN ORTIZ MARTINEZ;ANGEL LOBO BEDMAR;SANTIAGO GARRIDO PASCUAL. Cons.Del.Man: PASCUAL HERRERAORTEGA. Nombramientos. Consejero: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON. Presidente: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON.Consejero: PASCUAL HERRERA ORTEGA. Secretario: PASCUAL HERRERA ORTEGA. Consejero: JUAN MARIN GARCIA;JULIOANTONIO GARCIA RIBON;ANGEL GIMENO FLETA;MANUEL HERRERA ROMERO;JUAN ORTIZ MARTINEZ;ANGEL LOBOBEDMAR;SANTIAGO GARRIDO PASCUAL;RAMON HERRERA ORTEGA;JOSEP SOLER COSTA;DAVID DIEZ CORTIJO.

25 de Marzo de 2022
Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS. Datos registrales. T 3563 , F 180, S 8, H MU 68429,I/A 11 (18.03.22).

19 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: RAMON HERRERA ORTEGA. Nombramientos. Cons.Del.Man: PASCUAL HERRERAORTEGA. Datos registrales. T 2616 , F 27, S 8, H MU 68429, I/A 10 (13.03.20).

03 de Julio de 2018
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON;PASCUAL HERRERAORTEGA;RAMON HERRERA ORTEGA;JUAN MARIN GARCIA;GARCIA RIBON JULIO ANTONIO;ANGEL GIMENO FLETA;MANUELHERRERA ROMERO;JUAN MANUEL RIVAS MONGE;JUAN LEON MOLINA;JUAN ORTIZ MARTINEZ;ANGEL LOBOBEDMAR;SANTIAGO GARRIDO PASCUAL. Presidente: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON. Cons.Del.Man: SANTIAGO MARTINEZGABALDON. Secretario: PASCUAL HERRERA ORTEGA. Cons.Del.Man: RAMON HERRERA ORTEGA;JUAN MARIN GARCIA.Nombramientos. Consejero: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON. Presidente: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON. Cons.Del.Man:SANTIAGO MARTINEZ GABALDON. Consejero: PASCUAL HERRERA ORTEGA. Secretario: PASCUAL HERRERA ORTEGA.Consejero: JUAN MARIN GARCIA. Cons.Del.Man: JUAN MARIN GARCIA. Consejero: RAMON HERRERA ORTEGA;GARCIA RIBONJULIO ANTONIO;ANGEL GIMENO FLETA;MANUEL HERRERA ROMERO;JUAN MANUEL RIVAS MONGE;JUAN ORTIZMARTINEZ;ANGEL LOBO BEDMAR;SANTIAGO GARRIDO PASCUAL. Cons.Del.Man: RAMON HERRERA ORTEGA. Datosregistrales. T 2616 , F 27, S 8, H MU 68429, I/A 9 (26.06.18).

22 de Mayo de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 195.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 978.120,00 Euros. Datos registrales. T 2616 , F 27, S 8, HMU 68429, I/A 8 (14.05.15).

30 de Diciembre de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 195.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 783.120,00 Euros. Datos registrales. T 2616 , F 26, S 8, HMU 68429, I/A 6 (20.12.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON. Presidente: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON. Consejero:PASCUAL HERRERA ORTEGA. Secretario: PASCUAL HERRERA ORTEGA. Cons.Del.Man: SANTIAGO MARTINEZGABALDON;PASCUAL HERRERA ORTEGA. Consejero: JUAN MANUEL RIVAS MONGE. Cons.Del.Man: JUAN MANUEL RIVASMONGE. Consejero: GARCIA RIBON JULIO ANTONIO;ANGEL GIMENO FLETA;MANUEL HERRERA ROMERO;RAMON HERRERAORTEGA;JUAN MARIN GARCIA;JUAN LEON MOLINA;ROGELIO RUBIO MINGUEZ. Nombramientos. Consejero: SANTIAGOMARTINEZ GABALDON;PASCUAL HERRERA ORTEGA;GARCIA RIBON JULIO ANTONIO;ANGEL GIMENO FLETA;MANUELHERRERA ROMERO;JUAN MANUEL RIVAS MONGE;JUAN MARIN GARCIA;JUAN LEON MOLINA;RAMON HERRERA

25 de Octubre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 195.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 588.120,00 Euros. Datos registrales. T 2616 , F 26, S 8, HMU 68429, I/A 5 (16.10.12).

24 de Febrero de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 195.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 393.120,00 Euros. Datos registrales. T 2616 , F 25, S 8, HMU 68429, I/A 4 (16.02.12).

13 de Julio de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 195.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 198.120,00 Euros. Datos registrales. T 2616 , F 25, S 8, HMU 68429, I/A 3 ( 4.07.11).

05 de Octubre de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: RAMON HERRERA ORTEGA;MANUEL HERRERA ROMERO. Nombramientos. Consejero:SANTIAGO MARTINEZ GABALDON. Presidente: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON. Consejero: PASCUAL HERRERA ORTEGA.Secretario: PASCUAL HERRERA ORTEGA. Cons.Del.Man: SANTIAGO MARTINEZ GABALDON;PASCUAL HERRERA ORTEGA.Consejero: JUAN MANUEL RIVAS MONGE. Cons.Del.Man: JUAN MANUEL RIVAS MONGE. Consejero: GARCIA RIBON JULIOANTONIO;ANGEL GIMENO FLETA;MANUEL HERRERA ROMERO;RAMON HERRERA ORTEGA;JUAN MARIN GARCIA;JUANLEON MOLINA;ROGELIO RUBIO MINGUEZ. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoresmancomunados a Consejo de administraci贸n. Otros conceptos: Modificacion del articulo 7 de los estatutos sociales. Datosregistrales. T 2616 , F 24, S 8, H MU 68429, I/A 2 (25.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n