Buscador CIF Logo

Actos BORME Gescoagro Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gescoagro Sa

Actos BORME Gescoagro Sa - A80419401

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gescoagro Sa con CIF A80419401

🔙 Perfil de Gescoagro Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gescoagro Sa

11 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: SPIEGELBERG DE ORTUETA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 41000 , F 6, S 8, H M 74129, I/A35 ( 3.11.20).

15 de Octubre de 2020
Revocaciones. Con.Delegado: SPIEGELBERG DE ORTUETA JUAN. Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 28 de losestatutos sociales.. Cambio de domicilio social. C/ FELIPE IV 3 3ºC (MADRID). Datos registrales. T 16325 , F 128, S 8, H M74129, I/A 34 ( 7.10.20).

26 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Consejero: SPIEGELBERG DE ORTUETA JUAN. Presidente: SPIEGELBERG DE ORTUETA JUAN. Con.Delegado:SPIEGELBERG DE ORTUETA JUAN. Consejero: SPIEGELBERG RAMIREZ PABLO;RAMIREZ SANCHEZ ESPERANZA. Secretario:RAMIREZ SANCHEZ ESPERANZA. Consejero: GARCIA TORRECILLA MARIA LUISA. Datos registrales. T 16325 , F 128, S 8, H M74129, I/A 33 (18.12.19).

09 de Julio de 2019
Nombramientos. Apoderado: PEREZ RAMIREZ RAFAEL. Datos registrales. T 16325 , F 127, S 8, H M 74129, I/A 32 ( 2.07.19).

04 de Mayo de 2017
Revocaciones. Apoderado: ALONSO SOLANO LAURA;MORTAZAWI MANDANA. Datos registrales. T 16325 , F 126, S 8, H M74129, I/A 31 (25.04.17).

23 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: SIERRA BARDAJI MATEO. Datos registrales. T 16325 , F 126, S 8, H M 74129, I/A 30 (15.12.15).

05 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: SPIEGELBERG RAMIREZ MIGUEL JUAN. Secretario: SPIEGELBERG RAMIREZ MIGUEL JUAN.Nombramientos. Consejero: RAMIREZ SANCHEZ ESPERANZA. Secretario: RAMIREZ SANCHEZ ESPERANZA. Consejero:GARCIA TORRECILLA MARIA LUISA. Reelecciones. Consejero: SPIEGELBERG DE ORTUETA JUAN. Presidente: SPIEGELBERGDE ORTUETA JUAN. Con.Delegado: SPIEGELBERG DE ORTUETA JUAN. Consejero: SIERRA BARDAJI MATEO;SPIEGELBERGRAMIREZ PABLO. Datos registrales. T 16325 , F 125, S 8, H M 74129, I/A 28 (27.05.15).

Revocaciones. Apoderado: SPIEGELBERG RAMIREZ MIGUEL JUAN. Datos registrales. T 16325 , F 126, S 8, H M 74129, I/A 29(27.05.15).

28 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: ALONSO SOLANO LAURA;MORTAZAWI MANDANA. Datos registrales. T 16325 , F 124, S 8, H M74129, I/A 27 (16.11.11).

21 de Marzo de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: GAMIZ LOPEZ ANTONIO. Nombramientos. Consejero: SPIEGELBERG RAMIREZ PABLO.Reelecciones. Consejero: SPIEGELBERG DE ORTUETA JUAN. Presidente: SPIEGELBERG DE ORTUETA JUAN. Con.Delegado:SPIEGELBERG DE ORTUETA JUAN. Consejero: SIERRA BARDAJI MATEO;SPIEGELBERG RAMIREZ MIGUEL JUAN. Secretario:SPIEGELBERG RAMIREZ MIGUEL JUAN. Datos registrales. T 16325 , F 123, S 8, H M 74129, I/A 26 ( 8.03.11).

02 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ SANCHEZ ESPERANZA. Datos registrales. T 16325 , F 122, S 8, H M 74129, I/A 25(23.08.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información