Actos BORME de Geservicio Sl
15 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BARAMBIO MARTINEZ ADOLFO. Nombramientos. Adm. Mancom.: BARAMBIO MARTINEZADOLFO;BARAMBIO PEREA ALEJANDRO. Ampliación de capital. Capital: 841,68 Euros. Resultante Suscrito: 8.416,80 Euros.Modificaciones estatutarias. Modificados los artículos 1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º y 13º de los estatutos sociales. . Otros conceptos:Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 741 , F 222, S 8,H M 14926, I/A 13 ( 5.11.21).
Nombramientos. Apoderado: BARAMBIO MARTINEZ ADOLFO. Datos registrales. T 741 , F 225, S 8, H M 14926, I/A 14 ( 5.11.21).
24 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: CABEZUDO COPA JUAN MIGUEL;CHAMON ARRIBAS AUGUSTO GERMAN;BARAMBIOMARTINEZ ADOLFO;GONZALEZ DELICADO ALFONSO. Presidente: BARAMBIO MARTINEZ ADOLFO. Vicepresid.: CABEZUDOCOPA JUAN MIGUEL. Secretario: GONZALEZ DELICADO ALFONSO. Consejero: SAINZ ARMADA IÑIGO. Vicesecret.: SAINZARMADA IÑIGO. Revocaciones. Apoderado: BARAMBIO MARTINEZ ADOLFO;LAZARO GONZALEZ JUAN CELESTINO.Nombramientos. Adm. Unico: BARAMBIO MARTINEZ ADOLFO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejode administración a Administrador único. Datos registrales. T 741 , F 222, S 8, H M 14926, I/A 12 (15.06.16).
19 de Noviembre de 2015Ampliación de capital. Capital: 4.569,12 Euros. Resultante Suscrito: 7.575,12 Euros. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR ENLA INSCRIPCION 9& LA PUBLICACION DEL ACTO DE AMPLIACION DE CAPITAL: CAPITAL SUSCRITO 4.569,12E, CAPITALRESULTANTE 7.575,12E TOTALMENTE DESEMBOLSADOS. Datos registrales. T 741 , F 59, S 8, H M 14926, I/A 9 (28.06.12).
21 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apoderado: BARAMBIO MARTINEZ ADOLFO. Datos registrales. T 741 , F 221, S 8, H M 14926, I/A 11 ( 8.09.15).
20 de Marzo de 2015Otros conceptos: DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION DE ESTA SOCIEDAD , SIENDO LAS SOCIEDADES QUE EN SU DIASERAN LAS ABSORBIDAS , " BARAMBIO GAS SL " , DOMICILIADA EN CUENCA Y " ESTACIONES DE SERVICIO MADRID 2010SL " , DOMICILIADA EN MADRID.- Datos registrales. T 741 , F 51, S 8, H M 14926, I/A 1M (10.03.15).
17 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: LAZARO GONZALEZ JUAN CELESTINO. Vicesecret.: LAZARO GONZALEZ JUAN CELESTINO.Nombramientos. Consejero: SAINZ ARMADA IÑIGO. Vicesecret.: SAINZ ARMADA IÑIGO. Datos registrales. T 741 , F 220, S 8, HM 14926, I/A 10 ( 9.12.13).
10 de Julio de 2012Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: RIO DE ORO SA. RIO DE ORO LEGANES SA. Datos registrales. T 741 , F 59, S 8,H M 14926, I/A 9 (28.06.12).
21 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: BARAMBIO MARTINEZ ADOLFO;LAZARO GONZALEZ JUAN CELESTINO. Datos registrales. T 741, F 58, S 8, H M 14926, I/A 8 (11.01.11).
20 de Enero de 2011Revocaciones. Apoderado: BAUTISTA PAREJO FERNANDO;BAUTISTA PAREJO VICENTE. Datos registrales. T 741 , F 57, S 8,H M 14926, I/A 6 (11.01.11).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BAUTISTA PAREJO JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: LAZARO GONZALEZ JUANCELESTINO;CABEZUDO COPA JUAN MIGUEL;CHAMON ARRIBAS AUGUSTO GERMAN;BARAMBIO MARTINEZADOLFO;GONZALEZ DELICADO ALFONSO. Presidente: BARAMBIO MARTINEZ ADOLFO. Vicepresid.: CABEZUDO COPA JUANMIGUEL. Secretario: GONZALEZ DELICADO ALFONSO. Vicesecret.: LAZARO GONZALEZ JUAN CELESTINO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 741 , F57, S 8, H M 14926, I/A 7 (11.01.11).