Buscador CIF Logo

Actos BORME Gesmunpal Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gesmunpal Sociedad Anonima

Actos BORME Gesmunpal Sociedad Anonima - A48913297

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Vizcaya para Gesmunpal Sociedad Anonima con CIF A48913297

馃敊 Perfil de Gesmunpal Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Vizcaya

Actos BORME de Gesmunpal Sociedad Anonima

15 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3540 , F 138, S 8, H BI 19390, I/A 30(31.10.23).

12 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: GIL LLERENA JUAN JOSE;GONZALEZ LASO DE LA VEGA CARLOS;RICO ALONSO CARLOSMANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 3540 , F 138, S 8, H BI 19390, I/A 29 (31.03.23).

07 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apoderado: FRANCES TORTOSA RICARDO. Datos registrales. T 3540 , F 136, S 8, H BI 19390, I/A 28(27.01.23).

21 de Julio de 2021
Revocaciones. Apoderado: CANDELA PINA FRANCISCO. Datos registrales. T 3540 , F 135, S 8, H BI 19390, I/A 26 (13.07.21).

Nombramientos. Apoderado: ETXEBARRIA OLALDE IZASKUN. Datos registrales. T 3540 , F 135, S 8, H BI 19390, I/A 27(13.07.21).

12 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apoderado: RICO ALONSO CARLOS MANUEL;GARCIA MARTOS SUSANA;CA脩IZARES GONZALEZ JOSEFERNANDO;BANOUH MARTIN SAADA. Datos registrales. T 3540 , F 128, S 8, H BI 19390, I/A 25 ( 4.05.21).

14 de Abril de 2021
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3540 , F 128, S 8, H BI 19390, I/A 23 (7.04.21).

05 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ CONTRERAS GONZALO. VsecrNoConsj: DIAZ GRIDILLA PABLO. Consejero:PLAZA GONZALEZ FERNANDO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL;CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE.Presidente:CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE. Nombramientos. Adm. Unico: GIANT BIDCO SOCIEDAD LIMITADA. Modificacionesestatutarias. Modificado el art铆culo 9潞 de los estatutos sociales referente al 贸rgano de administraci贸n. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 3540 , F 126, S 8, H BI 19390, I/A

28 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROBLES GARCIA RAMIRO. Presidente: ROBLES GARCIA RAMIRO. Nombramientos. Consejero:CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE. Presidente: CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE. Datos registrales. T 3540 , F 126, S8, H BI 19390, I/A 21 (19.02.20).

04 de Julio de 2019
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales.T 3540 , F 125, S 8, H BI 19390, I/A 19 (25.06.19).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.420,24 Euros. Resultante Suscrito: 57.686,47 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:2.313,75 Euros. Desembolsado: 2.313,75 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,22 Euros. Resultante Desembolsado: 60.000,22 Euros.Datos registrales. T 3540 , F 125, S 8, H BI 19390, I/A 20 (25.06.19).

23 de Mayo de 2019
Modificaciones estatutarias. Modificado el apartado quinquies del art铆culo 9潞 de los estatutos sociales referente al 贸rgano deadministraci贸n. Datos registrales. T 3540 , F 125, S 8, H BI 19390, I/A 18 ( 9.05.19).

21 de Marzo de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ARIETA-ARAUNABE脩A SUSAETA FRANCISCO JAVIER;DIEZ SAEZ VICTOR RAMIRO.Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZ CONTRERAS GONZALO. VsecrNoConsj: DIAZ GRIDILLA PABLO. Consejero:ROBLES GARCIA RAMIRO;PLAZA GONZALEZ FERNANDO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL. Presidente: ROBLES GARCIARAMIRO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Consejo de administraci贸n.Datos registrales. T 3540 , F 86, S 8, H BI 19390, I/A 16 (11.03.19).

Revocaciones. Apoderado: ARIETA-ARAUNABE脩A SUSAETA FRANCISCO JAVIER;DIEZ SAEZ VICTOR RAMIRO;DIEZ TEJEROJON KOLDOBIKA. Nombramientos. Apoderado: GIL LLERENA JUAN JOSE;GONZALEZ LASO DE LA VEGA CARLOS;RICOALONSO CARLOS MANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;CANDELA PINA FRANCISCO. Datos registrales. T 3540, F 124, S 8, H BI 19390, I/A 17 (11.03.19).

22 de Diciembre de 2016
Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: GESMUNPALIA SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 3540 , F 84, S 8, H BI 19390, I/A 15 (13.12.16).

26 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIEZ SAEZ VICTOR RAMIRO;ARIETA-ARAUNABE脩A SUSAETA FRANCISCO JAVIER. Presidente:ARIETA-ARAUNABE脩A SUSAETA FRANCISCO JAVIER. Cons.Del.Man: ARIETA-ARAUNABE脩A SUSAETA FRANCISCOJAVIER;DIEZ SAEZ VICTOR RAMIRO. Consejero: GONZALEZ LASO DE LA VEGA CARLOS. Secretario: DIEZ SAEZ VICTORRAMIRO. Nombramientos. Adm. Mancom.: ARIETA-ARAUNABE脩A SUSAETA FRANCISCO JAVIER;DIEZ SAEZ VICTORRAMIRO. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n y nueva redacci贸n de los Estatutos Sociales.. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 3540 , F 83, S 8, H BI19390, I/A 14 (19.08.16).

10 de Junio de 2013
Revocaciones. Apoderado: DIEZ AGUILERA EDUARDO. Datos registrales. T 3540 , F 82, S 8, H BI 19390, I/A 13 ( 4.06.13).

26 de Diciembre de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 12.021,34 Euros. Resultante Suscrito: 60.106,71 Euros. Datos registrales. T 3540 , F 82,S 8, H BI 19390, I/A 12 (13.12.12).

15 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ TOME JOSE MANUEL. Secretario: FERNANDEZ TOME JOSE MANUEL. Consejero:PEREZ MANCHA MIGUEL ANGEL. Vicesecret.: PEREZ MANCHA MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Man: FERNANDEZ TOME JOSEMANUEL;PEREZ MANCHA MIGUEL ANGEL. Vicepresid.: DIEZ SAEZ VICTOR RAMIRO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZLASO DE LA VEGA CARLOS. Secretario: DIEZ SAEZ VICTOR RAMIRO. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 12.021,34 Euros.Desembolsado: 12.021,34 Euros. Resultante Suscrito: 72.128,05 Euros. Resultante Desembolsado: 72.128,05 Euros. Datosregistrales. T 3540 , F 81, S 8, H BI 19390, I/A 11 ( 2.10.12).

30 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apoderado: ARIETA ARAUNABE脩A SUSAETA FRANCISCO JAVIER;DIEZ SAEZ VICTOR RAMIRO;DIEZ TEJEROJON KOLDOBIKA;DIEZ AGUILERA EDUARDO;GONZALEZ LASO DE LA VEGA CARLOS. Datos registrales. T 3540 , F 80, S 8, HBI 19390, I/A 10 (14.08.12).

02 de Noviembre de 2010
Reelecciones. Consejero: DIEZ SAEZ VICTOR RAMIRO. Vicepresid.: DIEZ SAEZ VICTOR RAMIRO. Consejero: ARIETAARAUNABE脩A SUSAETA FRANCISCO JAVIER. Presidente: ARIETA ARAUNABE脩A SUSAETA FRANCISCO JAVIER. Consejero:FERNANDEZ TOME JOSE MANUEL. Secretario: FERNANDEZ TOME JOSE MANUEL. Consejero: PEREZ MANCHA MIGUELANGEL. Vicesecret.: PEREZ MANCHA MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Man: ARIETA ARAUNABE脩A SUSAETA FRANCISCOJAVIER;FERNANDEZ TOME JOSE MANUEL;DIEZ SAEZ VICTOR RAMIRO;PEREZ MANCHA MIGUEL ANGEL. Datos registrales.T 3540 , F 79, S 8, H BI 19390, I/A 9 (19.10.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n