Actos BORME de Gestamp 2008 Sl
10 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 700, L 491, F 37, S 8, H BU 13696, I/A 17 ( 3.11.23).
16 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: ARISTI ANSORENA ROBERTO. Datos registrales. T 700, L 491, F 35, S 8, H BU 13696, I/A 16(10.03.23).
12 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 700, L 491, F 35, S 8, H BU 13696, I/A 15 ( 2.12.22).
29 de Julio de 2022Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL.Datos registrales. T 700, L 491, F 35, S 8, H BU 13696, I/A 14 (22.07.22).
11 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RIBERAS MERA FRANCISCO JOSE;RIBERAS MERA JUAN MARIA. Nombramientos. Consejero:VAZQUEZ PASCUAL DAVID;LOPEZ PE脩A FRANCISCO;RIBERAS MERA FRANCISCO JOSE. Presidente: RIBERAS MERAFRANCISCO JOSE. Secretario: VAZQUEZ PASCUAL DAVID. Con.Delegado: RIBERAS MERA FRANCISCO JOSE. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T700, L 491, F 33, S 8, H BU 13696, I/A 12 ( 4.10.17).
09 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: DE FRUTOS CHAMERO FELIPE. Datos registrales. T 700, L 491, F 32, S 8, H BU 13696, I/A 11 (2.02.17).
23 de Noviembre de 2015Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datosregistrales. T 622, L 413, F 81, S 8, H BU 13696, I/A 10 (17.11.15).
18 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: IZQUIERDO ELENA CONSUELO. Datos registrales. T 622, L 413, F 81, S 8, H BU 13696, I/A 9(11.11.14).
01 de Abril de 2013Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 622, L 413, F 81, S 8, H BU 13696, I/A 8 (21.03.13).
29 de Junio de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 15.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 622, L 413, F80, S 8, H BU 13696, I/A 7 (20.06.12).
04 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 9.996.940,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 622, L 413, F80, S 8, H BU 13696, I/A 6 (26.01.11).
31 de Enero de 2011Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 622, L 413, F 80, S 8, H BU 13696, I/A 5(20.01.11).
25 de Noviembre de 2010Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL;ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 622, L 413, F 79, S 8, H BU 13696, I/A4 (16.11.10).
05 de Agosto de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: ALVAREZ MANZANO GABRIEL;MARIN SANCHEZ DIEGO. Datos registrales. T 622, L 413, F 79, S8, H BU 13696, I/A 3 (27.07.10).
12 de Julio de 2010Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/5. Cambio de domicilio social. C/ GREGORIO LOPEZ BRAVO 89 -POLIGONO INDUSTRIAL D (BURGOS). Datos registrales. T 622, L 413, F 78, S 8, H BU 13696, I/A 2 ( 1.07.10).
10 de Mayo de 2010Nombramientos. Apoderado: SCHULZ HANS PETER;WEISS VOLKER. Datos registrales. T 26013 , F 80, S 8, H M 468946, I/A 3(28.04.10).
02 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apoderado: MARIN SANCHEZ DIEGO. Datos registrales. T 26013 , F 79, S 8, H M 468946, I/A 2 (21.10.09).