Actos BORME de Gestice Sociedad Limitada
27 de Diciembre de 2016Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GESTISERV SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 958, L 722, F 197, S 8, HAB 3227, I/A 28 (19.12.16).
23 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: RIBERA GARCIA FRANCISCO. Presidente: RIBERA GARCIA FRANCISCO. Consejero:HERNANDEZ VIZCAINO MARIA ADELA. Vicepresid.: HERNANDEZ VIZCAINO MARIA ADELA. Consejero: MARTINEZ HERNANDEZJUAN FRANCISCO. Secretario: MARTINEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO. Consejero: MARTINEZ LILLO JUAN;GARCIA MASJUAN. Nombramientos. Adm. Solid.: MARTINEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO;HERNANDEZ VIZCAINO MARIA ADELA.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales.T 958, L 722, F 197, S 8, H AB 3227, I/A 27 (16.05.16).
03 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RIBERA DOMENE FRANCISCO. Datos registrales. T 958, L 722, F 197, S 8, H AB 3227, I/A 26(27.07.15).
30 de Julio de 2015Revocaciones. Apoderado: GARCIA MAS JUAN. Datos registrales. T 936, L 700, F 70, S 8, H AB 3227, I/A 24 (23.07.15).
Revocaciones. Apoderado: RIBERA GARCIA FRANCISCO. Apo.Sol.: RIBERA GARCIA FRANCISCO. Datos registrales. T 958, L722, F 197, S 8, H AB 3227, I/A 25 (23.07.15).
14 de Enero de 2015Revocaciones. Apoderado: RIBERA DOMENE FRANCISCO. Datos registrales. T 936, L 700, F 70, S 8, H AB 3227, I/A 22 (7.01.15).
Revocaciones. Apoderado: ALCAIDE CRESPO GONZALO. Datos registrales. T 936, L 700, F 70, S 8, H AB 3227, I/A 23 ( 7.01.15).
09 de Octubre de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 177.715,70 Euros. Resultante Suscrito: 458.190,38 Euros. Datos registrales. T 538, L 302, F 58, S8, H AB 3227, I/A 21 ( 2.10.13).
29 de Enero de 2013P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1,33 Euros. Resultante Suscrito: 66.110,00Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 214.364,68 Euros. Resultante Suscrito: 280.474,68 Euros. Datos registrales. T 538, L 302, F57, S 8, H AB 3227, I/A 20 (22.01.13).