Buscador CIF Logo

Actos BORME Gestilar Gestion Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gestilar Gestion Sl

Actos BORME Gestilar Gestion Sl - B85796647

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gestilar Gestion Sl con CIF B85796647

馃敊 Perfil de Gestilar Gestion Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gestilar Gestion Sl

23 de Septiembre de 2022
Cambio de domicilio social. C/ JOSE ANTONIO FERNANDEZ ORDO脩EZ 40, OFICINA 10 (MADRID). Datos registrales. T 36020 ,F 206, S 8, H M 488063, I/A 21 (16.09.22).

15 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: GUILLAMON CRIADO PABLO. Datos registrales. T 36020 , F 205, S 8, H M 488063, I/A 20 (8.06.21).

11 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ MARTA;MATEO LOPEZ SUSANA. Datos registrales. T 36020 , F205, S 8, H M 488063, I/A 19 ( 5.06.21).

23 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: BRAVO MU脩OZ FRANCISCO. Datos registrales. T 36020 , F 204, S 8, H M 488063, I/A 18(16.06.20).

11 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: GARCIA-CARRASCO BLANCO JORGE. Datos registrales. T 36020 , F 204, S 8, H M 488063, I/A 17 (4.09.19).

06 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: GUERRERO JUANES RAUL. Datos registrales. T 36020 , F 203, S 8, H M 488063, I/A 16 (26.02.19).

27 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ ESTEFANIA ANA. Datos registrales. T 36020 , F 202, S 8, H M 488063, I/A 15 (20.11.17).

02 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: GARCIA-CARRASCO BLANCO JORGE. Datos registrales. T 36020 , F 201, S 8, H M 488063, I/A 14(24.10.17).

28 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA VALCARCEL GONZALEZ FRANCISCO JAVIER;GARCIA-VALCARCEL GONZALEZMARTA. Presidente: GARCIA VALCARCEL GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: GARCIA VALCARCEL GONZALEZFRANCISCO JAVIER. Secretario: GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ MARTA. Consejero: GARCIA VALCARCEL GONZALEZ PABLO.Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ FRANCISCO-JAVIER. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 36020 , F 201, S 8, H M 488063, I/A 13(21.09.17).

27 de Septiembre de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.090,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.916,25 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:1.149,75 Euros. Resultante Suscrito: 3.066,00 Euros. Datos registrales. T 27085 , F 178, S 8, H M 488063, I/A 12 (20.09.17).

31 de Mayo de 2016
Cambio de domicilio social. C/ QUINTANAVIDES 19 - EDIFICIO 4, 3潞 E (MADRID). Datos registrales. T 27085 , F 178, S 8, H M488063, I/A 11 (24.05.16).

26 de Abril de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 601,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.405,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:601,25 Euros. Resultante Suscrito: 3.006,25 Euros. Datos registrales. T 27085 , F 177, S 8, H M 488063, I/A 10 (18.04.16).

16 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ ESTEFANIA ANA. Datos registrales. T 27085 , F 176, S 8, H M 488063, I/A 9 ( 6.11.15).

02 de Noviembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: CALVO ESTEBAN ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: GARCIA VALCARCEL GONZALEZPABLO. Datos registrales. T 27085 , F 176, S 8, H M 488063, I/A 7 (23.10.15).

Cambio de domicilio social. C/ QUINTANAVIDES 17, - EDIFICIO 3, 2-E (MADRID). Datos registrales. T 27085 , F 176, S 8, H M488063, I/A 8 (23.10.15).

26 de Octubre de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: CALVO ESTEBAN ENRIQUE. Datos registrales. T 27085 , F 176, S 8, H M 488063, I/A 6 (16.10.15).

21 de Abril de 2015
Nombramientos. Apoderado: MATEO LOPEZ SUSANA. Datos registrales. T 27085 , F 175, S 8, H M 488063, I/A 5 (10.04.15).

09 de Abril de 2015
Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 1& LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIODE GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ MARTA. Datos registrales. T 27085 , F 171, S 8, H M 488063, I/A 1 (16.11.09).

06 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apoderado: SAEZ ACHAERANDIO NATALIA. Datos registrales. T 27085 , F 175, S 8, H M 488063, I/A 4(26.02.15).

17 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ MARTA. Datos registrales. T 27085 , F 174, S 8, H M 488063, I/A3 ( 7.11.14).

23 de Agosto de 2013
Nombramientos. Secretario: GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ MARTA. Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscricpic贸n 1&el nombramiento como SECRETARIO de MARTA GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ. Datos registrales. T 27085 , F 171, S 8, H M488063, I/A 1 (16.11.09).

27 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA-VALCARCEL GONZALEZ MARTA;CALVO ESTEBAN ENRIQUE. Datos registrales. T 27085 ,F 173, S 8, H M 488063, I/A 2 (16.11.09).

26 de Noviembre de 2009
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 20.10.09. Objeto social: LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCION,REFORMA Y PROMOCION DE TODACLASE DE INMUEBLES. Domicilio: C/ LOPE DE VEGA NUMERO 47, ESCALERA DERECHA,1潞 DE (MADRID). Capital: 3.006,00 Euros. Nombramientos. Consejero: GARCIA VALCARCEL GONZALEZ FRANCISCOJAVIER;GARCIA VALCARCEL GONZALEZ MARTA;CALVO ESTEBAN ENRIQUE. Presidente: GARCIA VALCARCEL GONZALEZFRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: GARCIA VALCARCEL GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Consejero: GARCIA VALCARCELGONZALEZ MARTA. Datos registrales. T 27085 , F 171, S 8, H M 488063, I/A 1 (16.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n