Actos BORME de Gestion Asistencial Aragonesa Sl
21 de Noviembre de 2023Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3823 , F 98, S 8, H Z 31085, I/A 36 (13.11.23).
30 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALENCIA BETRAN MARTA;CORREAS MIR MIGUEL ANGEL;CASTRO FERNANDEZ JUANCARLOS;MOLINA MARTINEZ LUIS;GARCIA GARCIA JUAN MANUEL;MORENO LORENTE MARIA PILAR;PEREZ CASINOPILAR;GARRIDO RAMOS DESIREE;GUERRERO HERNANDEZ SANTIAGO;PEREZ ESTEBAN ANTONIO;LADRERO PABLOMARINA;SUBIAS ESCOLAN PEDRO;ARANDA NAUDIN BEATRIZ;MARTINEZ BAULUZ RAFAEL;CANO MATUTEPEDRO;GUTIERREZ MINGUEZA RUBEN. Datos registrales. T 3823 , F 97, S 8, H Z 31085, I/A 35 (24.05.23).
27 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3823 , F 97, S 8, H Z 31085, I/A 32 (20.12.21).
21 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3823 , F 97, S 8, H Z 31085, I/A 31 (15.12.20).
26 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3521 , F 151, S 8, H Z 31085, I/A 30 (18.12.19).
06 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3521 , F 151, S 8, H Z 31085, I/A 29 (30.01.19).
27 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: CASTRO FERNANDEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 3521 , F 151, S 8, H Z 31085, I/A 28(21.11.18).
12 de Septiembre de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3521 , F 151, S 8, H Z 31085, I/A 27 ( 5.09.18).
03 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PEREZ ESTEBAN ANTONIO. Datos registrales. T 3521 , F 151, S 8, H Z 31085, I/A 26(20.04.18).
10 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GUIU LAPRESTA JAVIER;CASTRO FERNANDEZ JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm.Mancom.: MOLINA MARTINEZ LUIS;PEREZ ESTEBAN ANTONIO. Datos registrales. T 3521 , F 150, S 8, H Z 31085, I/A 25 (3.10.17).
01 de Agosto de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: MONSERRATE MONFORTE JOSE MIGUEL;CARCAS BLASCO ARMANDO;CORREAS MIR MIGUELANGEL;RAMIREZ BENITO MANUEL;GUIU LAPRESTA JAVIER;CASTRO FERNANDEZ JUAN CARLOS;DELGADO CASTROCARLOS;MOLINA MARTINEZ LUIS;GARCIA GARCIA JUAN MANUEL;VALENCIA BETRAN MARTA;MARTINEZ BAULUZ RAFAEL.Nombramientos. Apo.Manc.: VALENCIA BETRAN MARTA;MOLINA MARTINEZ LUIS;CASTRO FERNANDEZ JUANCARLOS;CORREAS MIR MIGUEL ANGEL;GARCIA GARCIA JUAN MANUEL;MORENO LORENTE MARIA PILAR;PEREZ CASINOPILAR;GARRIDO RAMOS DESIREE;GUERRERO HERNANDEZ SANTIAGO;PEREZ ESTEBAN ANTONIO;LADRERO PABLOMARINA;SUBIAS ESCOLAN PEDRO JOSE;ARANDA NAUDIN BEATRIZ. Apoderado: MOLINA MARTINEZ LUIS. Datos registrales.T 3521 , F 149, S 8, H Z 31085, I/A 24 (21.07.17).
08 de Febrero de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3521 , F 149, S 8, H Z 31085, I/A 23 (26.01.17).
22 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3521 , F 149, S 8, H Z 31085, I/A 22 (14.01.16).
04 de Marzo de 2015Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3521 , F 149, S 8, H Z 31085, I/A 21 (24.02.15).
15 de Abril de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: GUIU LAPRESTA FRANCISCO JAVIER;DELGADO CASTRO CARLOS;GARCIA FAJARDOERNESTO;MOLINA MARTINEZ LUIS;GARCIA GARCIA JUAN MANUEL;VALENCIA BETRAN MARTA;MARTINEZ BAULUZ RAFAEL.Nombramientos. Apo.Manc.: MONSERRATE MONFORTE JOSE MIGUEL;CARCAS BLASCO ARMANDO;CORREAS MIR MIGUELANGEL;RAMIREZ BENITO MANUEL;GUIU LAPRESTA JAVIER;CASTRO FERNANDEZ JUAN CARLOS;DELGADO CASTROCARLOS;MOLINA MARTINEZ LUIS;GARCIA GARCIA JUAN MANUEL;VALENCIA BETRAN MARTA;MARTINEZ BAULUZ RAFAEL.Datos registrales. T 3521 , F 148, S 8, H Z 31085, I/A 20 ( 8.04.13).
25 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CORREAS MIR MIGUEL ANGEL;RAMIREZ BENITO JUAN-MANUEL. Nombramientos. Adm.Mancom.: CASTRO FERNANDEZ JUAN CARLOS;GARCIA GARCIA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 3521 , F 148, S 8, H Z31085, I/A 19 (16.01.13).
21 de Marzo de 2012Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3521 , F 148, S 8, H Z 31085, I/A 18 ( 8.03.12).
17 de Noviembre de 2011Modificaciones estatutarias. Art铆culo 23: Aprobaci贸n de cuentas y reparto del resultado. 23.1 Corresponde a la Junta General: a)Aprobar las cuentas anuales. El acuerdo se tomar谩 por mayor铆a de los votos v谩lidamente emitidos, siempre que representen al menosun tercio de los votos correspondientes a las participaciones. Datos registrales. T 3521 , F 147, S 8, H Z 31085, I/A 17 ( 3.11.11).
21 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: HERNAZ GRACIA MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: RAMIREZ BENITOJUAN-MANUEL. Datos registrales. T 3521 , F 147, S 8, H Z 31085, I/A 16 (10.09.10).
22 de Febrero de 2010Modificaciones estatutarias. Art铆culo 2潞.- Tiene por objeto social la plena integraci贸n social y laboral de las personas condiscapacidad, a trav茅s de la posible calificaci贸n como Centro Especial de Empleo. Son actividades propias que la Sociedad puederealizar: a)Servicios administrativos y auxiliares de los mismos, de. Otros conceptos: Se rectifica la redacci贸n del art铆culo 2潞 de losEstatutos sociales tras constatar el 贸rgano de administraci贸n un erroren la certificaci贸n del acta que recog铆a los acuerdos de laJunta de30/06/2009 en la que se modific贸 el objeto social y el mencionado art铆culo. Datos registrales. T 3521 , F 147, S 8, H Z 31085, I/A 15(11.02.10).
07 de Diciembre de 2009Cambio de objeto social. -la plena integraci贸n social y laboral de las personas con discapacidad a trav茅s de la posible calificaci贸ncomo Centro Especial de Empleo. Son actividades propias que la sociedad puede realizar: a Servicios de mantenimiento, reparaci贸n, einstalaci贸n de equipos de electricidad general, electr贸nicos. Datos registrales. T 3521 , F 147, S 8, H Z 31085, I/A 14 (26.11.09).