Buscador CIF Logo

Actos BORME Gestion De Activos Castellana 40 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gestion De Activos Castellana 40 Sl

Actos BORME Gestion De Activos Castellana 40 Sl - B81798076

Tenemos registrados 37 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gestion De Activos Castellana 40 Sl con CIF B81798076

馃敊 Perfil de Gestion De Activos Castellana 40 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gestion De Activos Castellana 40 Sl

01 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: ALCAY MORANDEIRA CARLOS JESUS;MARTINEZ MARISCAL JOSE JOAQUIN;GONZALEZ MARTINMARIA MONTSERRAT. Datos registrales. T 38762 , F 207, S 8, H M 197498, I/A 44 (24.11.23).

19 de Septiembre de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ GARCIA LAURA;GOMEZ SANTOS ANA BELEN;DEL VAL MARTINEZ JORGE. Datosregistrales. T 38762 , F 206, S 8, H M 197498, I/A 43 (12.09.23).

04 de Septiembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Representan: FERNANDEZ GARCIA LAURA. Nombramientos. Representan: ACOSTA RAMIREZ MIGUELPEDRO. Datos registrales. T 38762 , F 206, S 8, H M 197498, I/A 42 (28.08.23).

13 de Junio de 2023
Revocaciones. Apoderado: DEY SHOMIT;DEY SHOMIT. Apo.Sol.: BLAZQUEZ MARQUEZ ADOLFO. Datos registrales. T 38762 , F206, S 8, H M 197498, I/A 41 ( 6.06.23).

03 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apoderado: ALISEDA SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA SL. Datos registrales. T 38762 , F 203, S 8, H M197498, I/A 40 (27.01.23).

19 de Enero de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: USED ALONSO ENRIQUE. Otros conceptos: Modificaci贸n del contenido del poder conferido a donCarlos Montoya Reguera, que motiv贸 la inscripci贸n 16陋, en cuanto a los l铆mites econ贸micos de los apartados "Facultades decontrataci贸n" y "Facultades de disposici贸n y gesti贸n; contrataci贸n bancaria y financiera". Datos registrales. T 38762 , F 203, S 8, H M197498, I/A 39 (12.01.23).

23 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: USED ALONSO ENRIQUE. Nombramientos. Representan: MONTOYA REGUERA CARLOS.Datos registrales. T 38762 , F 203, S 8, H M 197498, I/A 38 (16.12.22).

13 de Septiembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ-VELAYOS RIVERA MAYA. Nombramientos. Apo.Sol.: NU脩O CANDELA LUIS. Datosregistrales. T 38762 , F 200, S 8, H M 197498, I/A 37 ( 6.09.22).

10 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: MARRERO FERNANDEZ-CID SANTIAGO. Nombramientos. Apo.Sol.: DEL VAL MARTINEZ JORGE.Datos registrales. T 38762 , F 199, S 8, H M 197498, I/A 36 ( 1.12.21).

16 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: ARIZCUN MU脩OZ ARANZAZU. Apo.Man.Soli: URBEMED INGENIERIA Y PAISAJE S.L. Datosregistrales. T 38762 , F 199, S 8, H M 197498, I/A 35 ( 9.11.21).

23 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA. Datos registrales. T 38762 , F 198, S 8, H M197498, I/A 34 (16.09.21).

02 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: SUNCAPITAL MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 38762 , F 198, S 8, H M197498, I/A 33 (26.05.21).

11 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: LABRADOR ARROYO ALBERTO;SANCHEZ TORRE ROQUE;BAZAGA BUSTOS MARIA ANGELES.Datos registrales. T 38762 , F 197, S 8, H M 197498, I/A 32 ( 4.05.21).

07 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: M.I. ESPRE REAL ESTATE SL. Representan: COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICKMARIE. Datos registrales. T 38762 , F 197, S 8, H M 197498, I/A 31 (29.03.21).

30 de Marzo de 2021
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 38762 , F 197, S 8, H M 197498, I/A 30 (23.03.21).

15 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ SANTOS ANA BELEN;JIMENEZ CRESPO DULCENOMBRE DE MARIA;MARREROFERNANDEZ-CID SANTIAGO;GONZALEZ MARTIN MARIA MONTSERRAT;GUTIERREZ GARCIA VICTOR;MARIN DE RODA ANA.Datos registrales. T 38762 , F 195, S 8, H M 197498, I/A 29 ( 4.12.20).

06 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apoderado: PASCUAL GONZALEZ-BABE JOSE MARIA;PASCUAL GONZALEZ-BABE JOSE MARIA. Apo.Sol.:PASCUAL GONZALEZ-BABE JOSE MARIA. Apoderado: ISTURIZ LAZARO JAVIER. Apo.Sol.: MONTES ALONSO MARIA ANGELES.Datos registrales. T 38762 , F 195, S 8, H M 197498, I/A 28 (29.09.20).

02 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: URBEMED INGENIERIA Y PAISAJE S.L. Datos registrales. T 38762 , F 195, S 8, H M 197498, I/A27 (25.09.20).

03 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: GAMERO ALONSO ESTER. Apo.Sol.: JIMENEZ SANCHEZ SARA. Datos registrales. T 38762 , F 194,S 8, H M 197498, I/A 26 (26.11.19).

24 de Septiembre de 2019
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 38762 , F 194, S 8, H M 197498, I/A 25 (17.09.19).

30 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: SANZ EXPOSITO LUIS-ALBERTO;RANERA BERMUDEZ ELENA;TERAN CONTRERAS JAVIER. Datosregistrales. T 38762 , F 194, S 8, H M 197498, I/A 24 (23.08.19).

29 de Agosto de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 53.429,97 Euros. Resultante Suscrito: 56.435,03 Euros. Datos registrales. T 38762 , F 193, S 8, HM 197498, I/A 23 (22.08.19).

06 de Junio de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO CARBALLO VICTORIA;MARTINEZ MARISCAL JOSE JOAQUIN;BARROSO SAINZDAVID;MONTES ALONSO MARIA ANGELES. Datos registrales. T 30262 , F 94, S 8, H M 197498, I/A 22 (30.05.19).

27 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ-VELAYOS RIVERA MAYA. Apo.Sol.: ESCOBAR LAGO PILAR. Nombramientos.Apoderado: GONZALEZ-VELAYOS RIVERA MAYA;ISTURIZ LAZARO JAVIER;GARCIA MALO DE MOLINA MEGIA ELENA;BUSTOSSALGADO ITZIAR;VARELA PAZ MANUEL ALBERTO. Datos registrales. T 30262 , F 89, S 8, H M 197498, I/A 21 (20.05.19).

10 de Abril de 2019
Revocaciones. Apoderado: DEL SOL SANCHEZ ANA-ISABEL. Apo.Sol.: DEL SOL SANCHEZ ANA-ISABEL;MARTIN NU脩EZISABEL. Datos registrales. T 30262 , F 89, S 8, H M 197498, I/A 20 ( 3.04.19).

19 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: CEBADA ROLDAN BARBARA;CEBADA ROLDAN BARBARA. Apo.Sol.: PADILLA DEL VAL JUANCARLOS;RODRIGUEZ ZAMORA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 30262 , F 88, S 8, H M 197498, I/A 19 (12.02.19).

30 de Enero de 2019
Nombramientos. Adm. Mancom.: M.I. ESPRE REAL ESTATE SL. Representan: COLIN JACQUES-VITAL ANTOINE PATRICKMARIE. Modificaciones estatutarias. 25 y 26. Datos registrales. T 30262 , F 88, S 8, H M 197498, I/A 18 (23.01.19).

12 de Noviembre de 2018
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: QUASAR FINANCE SL. Datos registrales. T 30262 , F 88, S 8, H M

11 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: MENDILUCE FRADERA EDUARDO;USED ALONSO ENRIQUE;MONTOYA REGUERACARLOS;FERNANDEZ GARCIA LAURA;MONGE RIAT ALEJANDRO;LOPEZ CLEMENTE FERNANDO;BLAZQUEZ MARQUEZADOLFO;PADILLA DEL VAL JUAN CARLOS;PASCUAL GONZALEZ-BABE JOSE MARIA;AGUSTI ORERO MARIA DELCARMEN;MENDOZA JUEZ BERTA;DEL SOL SANCHEZ ANA-ISABEL;MORAGA RAMIREZ JUAN ANTONIO;RONCERO VICENTELUIS;SANZ EXPOSITO LUIS-ALBERTO;RIQUELME ORTIZ MARIA JOSE;MARTIN FERREIRA EUGENIA LOURDES;MARTINNU脩EZ ISABEL;ALCAY MORANDEIRA CARLOS JESUS;MOINELO LOPEZ TANIA;ARIZCUN MU脩OZ ARANZAZU;ESCOBAR LAGOPILAR;RANERA BERMUDEZ ELENA;LABRADOR ARROYO ALBERTO;TERAN CONTRERAS JAVIER;SANCHEZ TORREROQUE;BURSTEDT EMMA HELENA MARTA;RODRIGUEZ ZAMORA JUAN ANTONIO;RUBIO MARTIN ANDREA;BAZAGA BUSTOSMARIA ANGELES;JIMENEZ SANCHEZ SARA;CALVO CARBALLO VICTORIA. Datos registrales. T 30262 , F 80, S 8, H M 197498,I/A 16 ( 3.10.18).

08 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ-VELAYOS RIVERA MAYA. Datos registrales. T 30262 , F 79, S 8, H M 197498, I/A 15(28.09.18).

14 de Agosto de 2018
Nombramientos. Apoderado: DAVIES SIMON DAVID AUSTIN;KOSTADINOV VASILEV PANAYOT;DEY SHOMIT;BOSSY JEAN-FRANCOIS PASCAL EMMANUEL;HOFFMANN SOLVEIG DIANA;MEDIANE ANISSA;CABALLERO MARTINEZ JOSEGABRIEL;LEFEBVRE PIERRE-YVES;PIAIA ELENA;PAGES SERRA LAIA;ROCH DOROTA MARTA;MOINELO LOPEZTANIA;PASCUAL GONZALEZ-BABE JOSE MARIA;DEL SOL SANCHEZ ANA-ISABEL;MORAGA RAMIREZ JUANANTONIO;RONCERO VICENTE LUIS;CEBADA ROLDAN BARBARA;GAMERO ALONSO ESTER;MONTOYA REGUERACARLOS;MARIN DE RODA ANA;DAVIES SIMON DAVID AUSTIN;KOSTADINOV VASILEV PANAYOT;DEY SHOMIT;BOSSY JEAN-FRANCOIS PASCAL EMMANUEL;HOFFMANN SOLVEIG DIANA;MEDIANE ANISSA;CABALLERO MARTINEZ JOSEGABRIEL;LEFEBVRE PIERRE-YVES;PIAIA ELENA;PAGES SERRA LAIA;ROCH DOROTA MARTA;MOINELO LOPEZTANIA;PASCUAL GONZALEZ-BABE JOSE MARIA;DEL SOL SANCHEZ ANA-ISABEL;MORAGA RAMIREZ JUANANTONIO;RONCERO VICENTE LUIS;CEBADA ROLDAN BARBARA;GAMERO ALONSO ESTER;MONTOYA REGUERACARLOS;MARIN DE RODA ANA. Datos registrales. T 30262 , F 77, S 8, H M 197498, I/A 14 ( 7.08.18).

26 de Junio de 2018
Modificaciones estatutarias. 8 Y 12. Datos registrales. T 30262 , F 76, S 8, H M 197498, I/A 13 (19.06.18).

08 de Junio de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ BLANCO JOSE FERNANDO. Nombramientos. Representan: USED ALONSOENRIQUE;FERNANDEZ GARCIA LAURA. Adm. Mancom.: RENNELL PROPERTIES 2018 SL;MOALA PROPERTIES 2018 SL. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Cambio de domiciliosocial. PASEO DE LA CASTELLANA 280 2 (MADRID). Datos registrales. T 30262 , F 75, S 8, H M 197498, I/A 12 ( 1.06.18).

16 de Enero de 2017
Revocaciones. Apoderado: CARABANTE DE LA PLAZA LUIS. Datos registrales. T 30262 , F 75, S 8, H M 197498, I/A 11 (3.01.17).

07 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: AUDITECO SA. Datos registrales. T 30262 , F 75, S 8, H M 197498, I/A 10 (29.09.16).

30 de Mayo de 2013
Nombramientos. Auditor: AUDITECO SA. Datos registrales. T 30262 , F 75, S 8, H M 197498, I/A 9 (22.05.13).

15 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: CARABANTE DE LA PLAZA LUIS. Datos registrales. T 30262 , F 73, S 8, H M 197498, I/A 8 (5.11.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n