Buscador CIF Logo

Actos BORME Gestion De Servicios De Algete Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gestion De Servicios De Algete Sa

Actos BORME Gestion De Servicios De Algete Sa - A82589557

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gestion De Servicios De Algete Sa con CIF A82589557

馃敊 Perfil de Gestion De Servicios De Algete Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gestion De Servicios De Algete Sa

02 de Octubre de 2023
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Ampliacion del objeto social. Promover, fomentar,gestionar, contratar y realizar, con amplitud de forma y facultades; la actividad econ贸mica y el empleo en el municipio de Algete...Datos registrales. T 31170 , F 33, S 8, H M 251714, I/A 40 (25.09.23).

31 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MOYA CRUZ SERGIO;GUTIERREZ VIVAS ALEJANDRO;HERNANDEZ TEJADAMARIO;GUERRERO PRIETO JOSE-IGNACIO;CALDERON TORRES SANTIAGO;CORTHAY FERRAN MARIAFRANCISCA;GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO. Secretario: HERNANDEZ TEJADA MARIO. Consejero: ALDEANO GOMEZENRIQUETA;VALLE GARCIA JUAN JESUS. Presidente: VALLE GARCIA JUAN JESUS. Consejero: CALDERON GOMEZRAFAEL;PEREZ ARANDA MARIA NIEVES. Gerente: FERNANDEZ PALOMARES EDUARDO. Revocaciones. Apoderado: AGUADODEL OLMO MARIA JOSEFA;VALLE GARCIA JUAN JESUS;PINEDO HERNANDEZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: PEREZACHIAGA CARLOS;CALDERON GOMEZ RAFAEL;GRIJALBO BORRAS CARLOS FERNANDO;CAYUELA PEREZ ELENA;VALLEGARCIA JUAN JESUS;FERNANDEZ SAUCE ANASTASIO;ALONSO SANCHEZ ROBERTO;ESTRADA LOPEZ JESUS ANTONIO.Presidente: PEREZ ACHIAGA CARLOS. Secretario: ESTRADA LOPEZ JESUS ANTONIO. Gerente: HIDALGO PEREZ MARIANO.Apoderado: HIDALGO PEREZ MARIANO. Datos registrales. T 31170 , F 31, S 8, H M 251714, I/A 39 (24.08.23).

20 de Junio de 2023
Revocaciones. Apoderado: LLORENS BLASCO VICENTE ARTURO. Datos registrales. T 31170 , F 31, S 8, H M 251714, I/A 38(13.06.23).

20 de Abril de 2022
Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 31170 , F 31, S 8, H M 251714, I/A 37 (11.04.22).

10 de Noviembre de 2021
Cambio de objeto social. 1. Proyecto, realizaci贸n y conservaci贸n de viales, redes de riego, redes de saneamiento, redes deabastecimiento de agua movimiento de tierra, aceras, aparcamientos, plazas p煤blicas y nuevas urbanizaciones. 2. Proyecto,realizaci贸n y conservaci贸n de se帽alizaci贸n horizontal, vertical y sem谩foros,. Datos registrales. T 31170 , F 29, S 8, H M 251714, I/A34 ( 2.11.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA PUEBLA MESTA CESAREO;LEGIDO DE LA VEGA MARIA VICTORIA. Nombramientos.Consejero: CALDERON GOMEZ RAFAEL;PEREZ ARANDA MARIA NIEVES. Datos registrales. T 31170 , F 29, S 8, H M 251714, I/A35 ( 2.11.21).

Nombramientos. Apoderado: VALLE GARCIA JUAN JESUS;LLORENS BLASCO VICENTE ARTURO;PINEDO HERNANDEZALBERTO. Datos registrales. T 31170 , F 29, S 8, H M 251714, I/A 36 ( 2.11.21).

30 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Gerente: MARTINEZ JIMENEZ ALBERTO. Datos registrales. T 31170 , F 28, S 8, H M 251714, I/A 33(23.06.21).

27 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ CARTON JESUS MARIA. Presidente: FERNANDEZ CARTON JESUS MARIA.Consejero: LLORENS BLASCO VICENTE ARTURO. Nombramientos. Consejero: ALDEANO GOMEZ ENRIQUETA;VALLE GARCIAJUAN JESUS. Presidente: VALLE GARCIA JUAN JESUS. Datos registrales. T 31170 , F 28, S 8, H M 251714, I/A 32 (20.04.21).

11 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 31170 , F 28, S 8, H M 251714, I/A 31 ( 4.02.21).

24 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: DEL TRIUNFO CALLEJA LORENZO. Nombramientos. Gerente: MARTINEZ JIMENEZ ALBERTO.Datos registrales. T 31170 , F 27, S 8, H M 251714, I/A 30 (17.12.19).

12 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRERA GUTIERREZ-CORTINES ELENA;PEREZ ARANDA MARIA NIEVES;CALDERONTORRES SANTIAGO;MARTINEZ CALVO ESPERANZA;LLORENS BLASCO VICENTE ARTURO;FERNANDEZ CARTON JESUSMARIA;FERNANDEZ GARCIA JAIME;GUERRERO PRIETO JOSE-IGNACIO;HERNANDEZ TEJADA MARIO;HIDALGO PEREZMARIANO. Presidente: HIDALGO PEREZ MARIANO. Vicepresid.: FERNANDEZ CARTON JESUS MARIA. Secretario: HERNANDEZTEJADA MARIO. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ CARTON JESUS MARIA;MOYA CRUZ SERGIO;DE LA PUEBLAMESTA CESAREO;LEGIDO DE LA VEGA MARIA VICTORIA;LLORENS BLASCO VICENTE ARTURO;GUTIERREZ VIVASALEJANDRO;HERNANDEZ TEJADA MARIO;GUERRERO PRIETO JOSE-IGNACIO;CALDERON TORRES SANTIAGO;CORTHAYFERRAN MARIA FRANCISCA;GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO. Presidente: FERNANDEZ CARTON JESUS MARIA. Secretario:HERNANDEZ TEJADA MARIO. Datos registrales. T 31170 , F 27, S 8, H M 251714, I/A 29 ( 5.09.19).

31 de Mayo de 2018
Nombramientos. Auditor: L & M AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 31170 , F26, S 8, H M 251714, I/A 28 (22.05.18).

29 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRENS SANABRIA MARIA ANGELES. Vicepresid.: TORRENS SANABRIA MARIA ANGELES.Consejero: GALIANA ORTEGA JOSE LUIS;CARMONA SERRANO DANIEL;ROA SALAZAR MARIO;FERNANDEZ COYA JOSELUIS;ROJO MARTIN FRANCISCO JAVIER;MARQUES FERNANDEZ BERNAL ADOLFO. Secretario: MARQUES FERNANDEZBERNAL ADOLFO. Presidente: ROJO MARTIN FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: LLORENS BLASCO VICENTEARTURO;FERNANDEZ CARTON JESUS MARIA;FERNANDEZ GARCIA JAIME;GUERRERO PRIETO JOSE-IGNACIO;HERNANDEZTEJADA MARIO;HIDALGO PEREZ MARIANO. Presidente: HIDALGO PEREZ MARIANO. Vicepresid.: FERNANDEZ CARTON JESUSMARIA. Secretario: HERNANDEZ TEJADA MARIO. Datos registrales. T 31170 , F 26, S 8, H M 251714, I/A 27 (22.05.18).

26 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: VEGA COLINAS MARCO AURELIO;GONZALEZ JUAN BORJA;MORILLA RUEDADOLORES;CALDERON TORRES SANTIAGO;HIDALGO PEREZ MARIANO. Presidente: HIDALGO PEREZ MARIANO. Vicepresid.:VEGA COLINAS MARCO AURELIO. Secretario: GONZALEZ JUAN BORJA. Consejero: MARQUES FERNANDEZ BERNALADOLFO;GIL FERNANDEZ ALBERTO;VERAS PALACIOS JESUS. Nombramientos. Consejero: ROJO MARTIN FRANCISCOJAVIER;HERRERA GUTIERREZ-CORTINES ELENA;PEREZ ARANDA MARIA NIEVES;CALDERON TORRESSANTIAGO;MARQUES FERNANDEZ BERNAL ADOLFO;GALIANA ORTEGA JOSE LUIS;CARMONA SERRANO DANIEL;ROASALAZAR MARIO;FERNANDEZ COYA JOSE LUIS;TORRENS SANABRIA MARIA ANGELES;MARTINEZ CALVO ESPERANZA.Secretario: MARQUES FERNANDEZ BERNAL ADOLFO. Presidente: ROJO MARTIN FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: TORRENSSANABRIA MARIA ANGELES. Datos registrales. T 31170 , F 25, S 8, H M 251714, I/A 26 (15.10.15).

05 de Mayo de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 928.323,84 Euros. Resultante Suscrito: 996.142,20 Euros. Datos registrales. T 31170 , F24, S 8, H M 251714, I/A 25 (23.04.14).

07 de Febrero de 2014
Reelecciones. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 31170 , F 24, S 8, H M 251714, I/A 23 (30.01.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA TAJADA GOMEZ ENRIQUE;ESPINOSA MU脩OZ CARLOS;DURAN JIMENEZ ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: VERAS PALACIOS JESUS. Datos registrales. T 31170 , F 24, S 8, H M 251714, I/A 24 (30.01.14).

03 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Representan: RODRIGUEZ MASEDA JUAN CARLOS. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 32/2012.FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 10/10/2013. Sentencia de aprobaci贸n del convenio. Juzgado: num. 5 JUZGADO MERCANTILMADRID. Juez: DON JAVIER GARCIA MARRERO. Resoluciones: Aprobaci贸n de la propuesta de convenio: Una espera de 2 a帽os y11 meses con el siguiente calendario de pagos: - En el 2 a帽o se abonar谩 el 58% del cr茅dito; - 11 meses siguientes al 41,5 %. Loscr茅ditos subordinados ser谩 abonados con las mismas esperas, inci谩ndose el c贸mputo una vez efectuado el pag. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 32/2012. Fecha de resoluci贸n 7/03/2012. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado:num. 5 JUZGADO MERCANTIL MADRID. Juez: DON JAVIER GARCIA MARRERO. Administrador Concursal. Fecha 10/10/2013,NIF/CIF B86046281. DICTUM ESTUDIO JURIDICO Y ECONOMICO SLP. Datos registrales. T 31170 , F 23, S 8, H M 251714, I/A 22(24.01.14).

31 de Enero de 2014
Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA ANOTACION LETRA A DE LA SOCIEDAD, EL NOMBRAMIENTO DELREPRESENTANTE DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL, SIENDO DON JUAN CARLOS RODRIGUEZ MASEDA. Datosregistrales. T 24602 , F 134, S 8, H M 251714, I/A A (26.03.12).

28 de Octubre de 2013
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.323.446,04 Euros. Desembolsado: 1.323.446,04 Euros. Resultante Suscrito: 1.924.466,04 Euros.Resultante Desembolsado: 1.924.466,04 Euros. Datos registrales. T 31170 , F 22, S 8, H M 251714, I/A 21 (21.10.13).

28 de Junio de 2013
Revocaciones. Apoderado: DEL MONTE GIL NURIA. Nombramientos. Apoderado: DEL TRIUNFO CALLEJA LORENZO. Datosregistrales. T 24602 , F 136, S 8, H M 251714, I/A 20 (20.06.13).

30 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRUTOS MARTIN MARIA ROCIO;SEVILLA PEREZ MANUEL;MORENO MARTIN RICARDOLUDOVICO. Secretario: FRUTOS MARTIN MARIA ROCIO. Nombramientos. Secretario: GONZALEZ JUAN BORJA. Consejero: DELA TAJADA GOMEZ ENRIQUE;MARQUES FERNANDEZ BERNAL ADOLFO;GIL FERNANDEZ ALBERTOApoderado: DEL MONTEGIL NURIA. Datos registrales. T 24602 , F 134, S 8, H M 251714, I/A 19 (19.10.12).

09 de Abril de 2012
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 32/2012. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 7/03/2012. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 5 JUZGADO MERCANTIL MADRID. Juez: DON JAVIER GARCIA MARRERO. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 32/2012. Fecha de resoluci贸n 7/03/2012. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 5JUZGADO MERCANTIL MADRID. Juez: DON JAVIER GARCIA MARRERO. Administrador Concursal. Fecha 7/03/2012, NIF/CIFB86046281. DICTUM ESTUDIO JURIDICO Y ECONOMICO SLP. Datos registrales. T 24602 , F 134, S 8, H M 251714, I/A A(26.03.12).

15 de Febrero de 2012
Modificaciones estatutarias. NUEVA REDACCION DE LOS ARTICULOS 16 Y 18. Cambio de objeto social. LA REALIZACIONGESTION Y MANTENIMIENTO DE CUALQUIER OBRA DE INFRAESTRUCTURA, DE SERVICIOS O DE EDIFICACION EN ELMUNICIPIO QUE LE SEA ENCOMENDADA POREL AYUNTAMIENTO DE ALGETE. LA REALIZACION DE TODOS LOS SERVICIOSCON EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL IMPORTE. Datos registrales. T 24602 , F 133, S 8, H M 251714, I/A 18 ( 3.02.12).

13 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: HIDALGO PEREZ MARIANO;FRUTOS MARTIN MARIA ROCIO;DURAN JIMENEZENRIQUE;CABEZAS MORO OCTAVIO;SEVILLA PEREZ MANUEL;RODRIGUEZ PEREZ CARLOS. Presidente: HIDALGO PEREZ

06 de Mayo de 2011
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 405.688,50 Euros. Datos registrales. T 24602 , F 132, S 8, H M 251714, I/A16 (15.04.11).

30 de Marzo de 2011
Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ESTATUTOS EN UN NUEVO TEXTO.. Cambio de objeto social. LAREALIZACION GESTION Y MANTENIMIENTO DE CUALQUIER OBRA DE INFRAESTRUCTURA, DE SERVICIOS O DEEDIFICACION EN EL MUNICIPIO QUE LE SEA ENCOMENDADA POREL AYUNTAMIENTO DE ALGETE. Datos registrales. T24602 , F 127, S 8, H M 251714, I/A 15 (17.03.11).

22 de Marzo de 2011
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 0,79 Euros. Desembolsado: 0,79 Euros. Resultante Suscrito: 60.102,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 60.102,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 540.918,00 Euros. Desembolsado: 135.229,50 Euros. ResultanteSuscrito: 601.020,00 Euros. Resultante Desembolsado: 195.331,50 Euros. Datos registrales. T 24602 , F 126, S 8, H M 251714, I/A14 (10.03.11).

09 de Junio de 2010
Nombramientos. Auditor: L & M AUDITORES SL. Datos registrales. T 24602 , F 126, S 8, H M 251714, I/A 13 (27.05.10).

29 de Octubre de 2009
Nombramientos. Auditor: MEDIANO CORTES MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 24602 , F 125, S 8, H M 251714, I/A 12(19.10.09).

18 de Agosto de 2009
Nombramientos. Auditor: MEDIANO CORTES MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 24602 , F 125, S 8, H M 251714, I/A 11 (6.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n