Actos BORME de Gestion Geriatrica Del Principado De Asturias Sa
24 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: BARQUERO FERNANDEZ ALICIA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 148, S 8, H PO 59101, I/A 63(16.10.23).
10 de Octubre de 2023Modificación de poderes. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 148, S 8, HPO 59101, I/A 62 ( 2.10.23).
29 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 147, S 8, H PO 59101,I/A 61 (21.09.23).
16 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SARRATO MARTINEZ JAVIER. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 146, S 8, H PO 59101, I/A 60 (7.08.23).
04 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CAÑERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4256, L 4256,F 146, S 8, H PO 59101, I/A 59 (26.07.23).
28 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA ELENA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 146, S 8, H PO 59101, I/A 58 (20.07.23).
27 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 145, S 8, H PO 59101,I/A 57 (18.07.23).
24 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO QUINTELA SANDRA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNA VALENZUELA MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 4256, L 4256, F 144, S 8, H PO 59101, I/A 56 (13.07.23).
16 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIAÑEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 143, S 8, H PO 59101, I/A 53 (8.06.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 144, S 8, H PO 59101, I/A 54 (8.06.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 143, S 8, H PO 59101, I/A 52(14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datosregistrales. T 4256, L 4256, F 143, S 8, H PO 59101, I/A 51 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENSANTONI. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 143, S 8, H PO 59101, I/A 50 (26.07.22).
20 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: GERIATRICOS DELPRINCIPADO SA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 142, S 8, H PO 59101, I/A 49 (11.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 142, S 8, H PO 59101, I/A 48(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 140, S 8, H PO 59101, I/A 47(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 140, S 8, H PO 59101, I/A 46(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 139, S 8, H PO 59101, I/A 45(13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 139, S 8, H PO 59101, I/A 44 ( 7.10.21).
14 de Octubre de 2021Otros conceptos: El socio único decide añadir los artículos 8 bis y 8 ter a los estatutos sociales. Datos registrales. T 4256, L 4256,F 139, S 8, H PO 59101, I/A 43 ( 4.10.21).
28 de Junio de 2021Otros conceptos: EMISION Y ENTREGA DE UN TITULO MULTIPLE, nominativo, representativo de la totalidad de las acciones querepresentan el capital social de la entidad, numerado con el NUMERO 1. Datos registrales. T 4071, L 4071, F 81, S 8, H PO 59101,I/A 1.1 1 (17.06.21).
10 de Junio de 2021Cancelaciones de oficio de nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA. Nombramientos. Adm. Unico:FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 139, S 8, H PO 59101, I/A 42 ( 2.06.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 138, S 8, H PO 59101, I/A 41(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 138, S 8, H PO59101, I/A 40 (26.04.21).
07 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: NUÑEZ GRANADOS BLANCA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 138, S 8, H PO 59101, I/A 39(26.03.21).
07 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 138, S 8, H PO 59101, I/A 38(31.07.20).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 137, S 8, H PO59101, I/A 37 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 137, S 8, H PO 59101, I/A 36(18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 137, S 8, H PO 59101, I/A 35 (3.04.20).
27 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: LAGO COLLAR RAQUEL. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 137, S 8, H PO 59101, I/A 34 (19.02.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 137, S 8, H PO 59101, I/A 33(15.10.19).
06 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 136, S 8, H PO 59101, I/A 32(30.05.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 136, S 8, H PO 59101, I/A 31(16.05.19).
16 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 135, S 8, H PO 59101, I/A 28 (8.11.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 135, S 8, H PO 59101, I/A 29 (9.11.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4256, L 4256, F 135, S 8, H PO 59101, I/A 30 (12.11.18).
24 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 10, S 8, H PO 59101,I/A 27 (17.07.18).
18 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: ISASI PEREZ IÑAKI. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 10, S 8, H PO 59101, I/A 26 (12.07.18).
02 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 9, S 8, H PO 59101, I/A 25(26.06.18).
12 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 9, S 8, H PO 59101, I/A 24 (6.06.18).
16 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ CASTAÑON MARIA CARMEN. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 9, S 8, H PO 59101, I/A23 ( 9.03.18).
12 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 9, S 8, H PO 59101, I/A 22 (2.03.18).
19 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 8, S 8, H PO 59101, I/A19 (12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 8, S 8, H PO 59101, I/A 20(12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 9, S 8, H PO 59101, I/A21 (12.02.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 7, S 8, H PO 59101, I/A 18 ( 9.02.18).
04 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 7, S 8, H PO 59101, I/A 17 (25.08.17).
31 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: ISASI PEREZ IÑAKI. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 6, S 8, H PO 59101, I/A 16 (24.08.17).
25 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 6, S 8, H PO 59101, I/A 15
28 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 5, S 8, H PO 59101, I/A 12 (20.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN MARIÑO MARIA;DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 4199, L 4199, F 5, S 8, H PO 59101, I/A 13 (24.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;RODRIGUEZ MARTINEZISABEL;PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 6, S 8, H PO 59101, I/A 14 (24.07.17).
26 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 5, S 8, H PO 59101, I/A 11(19.07.17).
25 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 2, S 8, H PO 59101, I/A 10 (18.07.17).
26 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 1, S 8, H PO 59101, I/A 8(16.06.17).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 1, S 8, H PO 59101, I/A 9(19.06.17).
23 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 1, S 8, H PO 59101, I/A 7(15.06.17).
22 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 4199, L 4199, F 1, S 8, H PO 59101, I/A 6(14.06.17).
21 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4071, L 4071, F 86, S 8, H PO 59101, I/A 5(14.06.17).
20 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4071, L 4071, F 83, S 8, H PO 59101, I/A 4(12.06.17).
12 de Noviembre de 2015Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 4071, L 4071, F 83, S 8, H PO 59101, I/A 3(29.10.15).
20 de Octubre de 2015Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 (VIGO). Datos registrales. T 4071, L 4071, F 70, S 8, H PO 59101, I/A 1(13.10.15).
Otros conceptos: MODIFICADO el artículo 4º de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales.T 4071, L 4071, F 83, S 8, H PO 59101, I/A 2 (13.10.15).
07 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL.Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministración: Administradores mancomunados a Administrador único. Datos registrales. T 2927 , F 171, S 8, H AS 26155, I/A 7(28.09.15).
09 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: COCINA PALACIO JESUS;CAMPOS MENENDEZ JOSE LUIS;GONZALEZ GONZALEZ PAULO.Presidente: COCINA PALACIO JESUS. Secretario: GONZALEZ GONZALEZ PAULO. Con.Delegado: GONZALEZ GONZALEZPAULO. Nombramientos. Adm. Mancom.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL. Apo.Sol.:FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFINA;PENAS GARCIA MARIA JESUS. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 21.- Larepresentación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá al órgano de administración con sujeción a las normas queseguidamente se establecen en función de cual sea la modalidad de órgano de administración, que en cada momento dirija yadministre la compañía: a) al Artículo de los estatutos: ARTICULO 23º.- El Ejercicio Social comenzará el 1 de octubre de cada año yfinalizará el 30 de septiembre del año siguiente. . Artículo de los estatutos: ARTICULO 17.- La Sociedad será regida y administrada, aelección de la Junta General, sin necesidad de modificación estatutaria por: a) un administrador único; b) varios administradoressolidarios, con un mínimo de dos y un máximo de cinco; c) dos administradores. Otros conceptos: ARTICULO 18º.- Losadministradores serán nombrados por un plazo máximo de seis años, sin perjuicio de poder ser cesados en cualquier momento poracuerdo de la Junta General con lo establecido en el artículo 14 de estos estatutos. Datos registrales. T 2927 , F 170, S 8, H AS26155, I/A 6 ( 1.04.14).
19 de Abril de 2010Declaración de unipersonalidad. Socio único: GERIATRICOS DEL PRINCIPADO SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: COCINAPALACIO JESUS;RIERA PALACIO MARIA MERCEDES;CAMPOS MULERO JOSE RAMON. Presidente: COCINA PALACIO JESUS.Secretario: RIERA PALACIO MARIA MERCEDES. Cons.Del.Sol: COCINA PALACIO JESUS;RIERA PALACIO MARIA MERCEDES.Nombramientos. Consejero: COCINA PALACIO JESUS;CAMPOS MENENDEZ JOSE LUIS;GONZALEZ GONZALEZ PAULO.Presidente: COCINA PALACIO JESUS. Secretario: GONZALEZ GONZALEZ PAULO. Con.Delegado: GONZALEZ GONZALEZPAULO. Datos registrales. T 2927 , F 169, S 8, H AS 26155, I/A 5 ( 8.04.10).