Buscador CIF Logo

Actos BORME Gestion Global De Recursos Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gestion Global De Recursos Sl

Actos BORME Gestion Global De Recursos Sl - B82340977

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Salamanca para Gestion Global De Recursos Sl con CIF B82340977

🔙 Perfil de Gestion Global De Recursos Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Salamanca

Actos BORME de Gestion Global De Recursos Sl

24 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: EGIDO MATEOS ROCIO;EGIDO MATEOS ROCIO. Apo.Manc.: EGIDO MATEOS ROCIO;CALLESVILLAMANDOS JUAN-LUIS;MARTINEZ VELASCO LAURA;EGIDO MATEOS ROCIO;BONET SANCHEZ SEBASTIAN. Datosregistrales. T 299 , F 16, S 8, H SA 8884, I/A 25 ( 8.11.23).

20 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS;MARTINEZ VELASCO LAURA;CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS;MARTINEZ VELASCO LAURA. Apo.Manc.: CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS;MARTINEZ VELASCO LAURA;CALLESVILLAMANDOS JUAN-LUIS;MARTINEZ VELASCO LAURA;BONET SANCHEZ SEBASTIAN. Datos registrales. T 298 , F 225, S 8, HSA 8884, I/A 24 ( 9.10.23).

16 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO FERNANDO;CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS;MARTINEZVELASCO LAURA. Otros conceptos: REVOCA las facultades otorgadas a favor de DON JUAN-LUIS CALLES VILLAMANDOS yDOÑA LAURA MARTINEZ VELASCO, mediante escritura otorgada en Salamanca, el día 20 de Junio de 2.016, ante el que fue suNotario, Don Julio Rodríguez García, con el número 1.269 de su protocolo, que motivó la inscripción 14ª. Datos registrales. T 298 , F224, S 8, H SA 8884, I/A 22 ( 6.10.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: BONET SANCHEZ SEBASTIAN. Apo.Manc.: BONET SANCHEZ SEBASTIAN;CALLES VILLAMANDOSJUAN-LUIS;MARTINEZ VELASCO LAURA. Datos registrales. T 298 , F 224, S 8, H SA 8884, I/A 23 ( 6.10.23).

24 de Agosto de 2023
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ OCHARAN MARIA-GUADALUPE. Datos registrales. T 298 , F 223, S 8, H SA 8884, I/A 19(16.08.23).

Revocaciones. Apoderado: LOPEZ MUÑOZ MARCELINO. Datos registrales. T 298 , F 224, S 8, H SA 8884, I/A 20 (16.08.23).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ MANZANO MARIA. Apo.Manc.: FERNANDEZ MANZANO MARIA. Datos registrales. T298 , F 224, S 8, H SA 8884, I/A 21 (16.08.23).

19 de Junio de 2023
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: CACHEDA HUERGO CANTABRIA SL. Datos registrales. T 298 , F 207, S 8, H SA8884, I/A 18 ( 6.06.23).

02 de Abril de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS;FERNANDEZ MANZANO MARIA;MARTINEZ VELASCO LAURA.Nombramientos. Apo.Man.Soli: CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS;FERNANDEZ MANZANO MARIA;MARTINEZ VELASCOLAURA. Datos registrales. T 298 , F 207, S 8, H SA 8884, I/A 17 (21.03.18).

06 de Octubre de 2016
Revocaciones. Apoderado: VEGA GUTIERREZ MARCOS. Datos registrales. T 298 , F 207, S 8, H SA 8884, I/A 16 (29.09.16).

22 de Julio de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO FERNANDO. Datos registrales. T 298 , F 196, S 8, H SA 8884,I/A 14 (11.07.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CALLES VILLAMANDOS JUAN-LUIS;FERNANDEZ MANZANO MARIA;MARTINEZ VELASCOLAURA. Datos registrales. T 298 , F 197, S 8, H SA 8884, I/A 15 (11.07.16).

18 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apoderado: ALANIS PATIÑO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 298 , F 196, S 8, H SA 8884, I/A 13 (30.04.15).

13 de Agosto de 2014
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ MUÑOZ MARCELINO. Datos registrales. T 298 , F 196, S 8, H SA 8884, I/A 12 (28.07.14).

28 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALANIS MARCOS CARLOS. Datos registrales. T 298 , F 196, S 8, H SA 8884, I/A 11 (20.02.14).

22 de Noviembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: DEL SOL RODRIGUEZ JOSE-LUIS. Datos registrales. T 298 , F 195, S 8, H SA 8884, I/A 10 (11.11.13).

19 de Julio de 2013
Nombramientos. Apoderado: DEL SOL RODRIGUEZ JOSE-LUIS. Datos registrales. T 298 , F 195, S 8, H SA 8884, I/A 8(10.07.13).

Revocaciones. Apo.Sol.: TAMAYO DONCEL PABLO. Datos registrales. T 298 , F 195, S 8, H SA 8884, I/A 9 (10.07.13).

24 de Enero de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ALANIS MARCOS MARIA DEL ROSARIO. Nombramientos. Adm. Solid.: ALANIS MARCOS JUANANTONIO. Datos registrales. T 298 , F 195, S 8, H SA 8884, I/A 7 (15.01.13).

22 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: TAMAYO DONCEL PABLO;GARCIA ALCALDE MARIA JOSE. Datos registrales. T 298 , F 195, S 8, HSA 8884, I/A 6 ( 8.03.12).

25 de Marzo de 2011
Cambio de domicilio social. C/ PRIMERA 17-19 2 - OFICINA 206 PARQUE EMPRESARI (CARBAJOSA DE LA SAGRADA). Datosregistrales. T 298 , F 194, S 8, H SA 8884, I/A 5 (15.03.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información