Buscador CIF Logo

Actos BORME Gestion Instalaciones Fotovoltaicas Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gestion Instalaciones Fotovoltaicas Sl

Actos BORME Gestion Instalaciones Fotovoltaicas Sl - B84627975

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gestion Instalaciones Fotovoltaicas Sl con CIF B84627975

馃敊 Perfil de Gestion Instalaciones Fotovoltaicas Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gestion Instalaciones Fotovoltaicas Sl

14 de Junio de 2023
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 44808 , F80, S 8, H M 400798, I/A 25 ( 7.06.23).

19 de Abril de 2023
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SEGOVIA FV SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARCIAMENDEZ ANTONIO;MARCOS ALONSO MARTINEZ JUAN BOSCO. Revocaciones. Apoderado: GESBAN SERVICIOSADMINISTRATIVOS GLOBALES SL. Apo.Manc.: MARCOS ALONSO MARTINEZ JUAN BOSCO;PEREZ RAMIREZ ANTONIO.Apoderado: BORQUE GARCIA GUSTAVO;MARCOS ALONSO MARTINEZ JUAN BOSCO;PEREZ RAMIREZ ANTONIO;MA脩ASARIZA MARIA TERESA;BAILLO MORENO ALVARO. Nombramientos. Adm. Mancom.: SANABRIA SMITH PEDROALEJANDRO;JAQUETE PASTOR JUAN. Apo.Manc.: GORTAZAR SANCHEZ-TORRES I脩IGO;MARTI JUNCO JUANIGNACIO;CASTELLANO TORNERO CESAR;REBOLLO RICO IGNACIO;ANGUELA GALISTEO AMADEU;PEREZ MAGDALENOMIGUEL ANGEL. Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 91 - PLANTA 11 (MADRID). Datos registrales. T27184 , F 142, S 8, H M 400798, I/A 24 (12.04.23).

22 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: DIOSDADO CRIADO PEDRO MANUEL;BASAGOITI SALAZAR JOSE MARIA. Nombramientos.Adm. Mancom.: GARCIA MENDEZ ANTONIO;MARCOS ALONSO MARTINEZ JUAN BOSCO. Otros conceptos: Cambio del Organode Administraci贸n: Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 27184 , F 141, S 8, H M400798, I/A 23 (13.04.22).

18 de Enero de 2019
Revocaciones. Apoderado: DIEZ ZAPATERO JUAN CARLOS;FERNANDEZ PEREZ JESUS;VEGUEZ CA脩ADILLASCARLOS;HERRERA EUSEBIO GREGORIO;SOLANS GALOBART CARLOS. Datos registrales. T 27184 , F 141, S 8, H M 400798,I/A 22 (10.01.19).

04 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PEREZ RAMIREZ ANTONIO;MARCOS ALONSO MARTINEZ JUAN BOSCO. Nombramientos.Adm. Solid.: DIOSDADO CRIADO PEDRO MANUEL;BASAGOITI SALAZAR JOSE MARIA. Otros conceptos: Cambio del Organo de

26 de Abril de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: HERRERA EUSEBIO GREGORIO;SOLANS GALOBART CARLOS. Nombramientos. Apoderado:MA脩AS ARIZA MARIA TERESA;BAILLO MORENO ALVARO. Datos registrales. T 27184 , F 140, S 8, H M 400798, I/A 20(18.04.17).

10 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: SOLANS GALOBART CARLOS. Nombramientos. Adm. Mancom.: MARCOS ALONSOMARTINEZ JUAN BOSCO. Datos registrales. T 27184 , F 139, S 8, H M 400798, I/A 19 ( 3.02.17).

14 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27184 , F 139, S 8, H M 400798,I/A 18 ( 4.11.16).

09 de Mayo de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ DE ALDA GUTIERREZ MARIA LUZ. Nombramientos. Apoderado: BORQUE GARCIAGUSTAVO;MARCOS ALONSO MARTINEZ JUAN BOSCO;HERRERA EUSEBIO GREGORIO;PEREZ RAMIREZ ANTONIO;SOLANSGALOBART CARLOS. Datos registrales. T 27184 , F 138, S 8, H M 400798, I/A 17 (28.04.16).

26 de Junio de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ DE ALDA GUTIERREZ MARIA LUZ;MARCOS ALONSO MARTINEZ JUAN BOSCO;HERRERAEUSEBIO GREGORIO;PEREZ RAMIREZ ANTONIO;SOLANS GALOBART CARLOS. Datos registrales. T 27184 , F 137, S 8, H M400798, I/A 15 (17.06.15).

Revocaciones. Apo.Manc.: GADEA DE MIGUEL RAQUEL;HERRERA EUSEBIO GREGORIO;DIAZ GONZALEZ RICARDO.Apoderado: PALACIOS CASTA脩EDA LUIS;GARCIA-MONZON ALONSO CARLOS. Datos registrales. T 27184 , F 138, S 8, H M400798, I/A 16 (18.06.15).

22 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SEBARES URBANO MARCOS FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Mancom.: PEREZ RAMIREZANTONIO;SOLANS GALOBART CARLOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores mancomunados. Datos registrales. T 27184 , F 136, S 8, H M 400798, I/A 14 (15.06.15).

28 de Abril de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: MONTERO EZPONDABURU IGNACIO. Datos registrales. T 27184 , F 136, S 8, H M 400798, I/A 13(15.04.14).

15 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: PALACIOS CASTA脩EDA LUIS;GARCIA-MONZON ALONSO CARLOS. Datos registrales. T 27184 , F136, S 8, H M 400798, I/A 11 ( 4.04.14).

Revocaciones. Apo.Sol.: PALACIOS CASTA脩EDA LUIS;GARCIA-MONZON ALONSO CARLOS. Datos registrales. T 27184 , F136, S 8, H M 400798, I/A 12 ( 7.04.14).

02 de Abril de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: PALACIOS CASTA脩EDA LUIS;GARCIA-MONZON ALONSO CARLOS. Datos registrales. T 27184 , F135, S 8, H M 400798, I/A 10 (19.03.13).

04 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: HERRERA EUSEBIO GREGORIO;MONTERO EZPONDABURU IGNACIO;DIAZ GONZALEZRICARDO;BRYON JUSTIN ROGER;MA脩AS ARIZA MARIA TERESA;DELICADO TRIGO MANUEL ESTEBAN;HERRERA EUSEBIOGREGORIO;MONTERO EZPONDABURU IGNACIO;DIAZ GONZALEZ RICARDO;BRYON JUSTIN ROGER;MA脩AS ARIZA MARIATERESA;GADEA DE MIGUEL RAQUEL. Datos registrales. T 27184 , F 135, S 8, H M 400798, I/A 9 (21.10.10).

15 de Febrero de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: GADEA DE MIGUEL RAQUEL;HERRERA EUSEBIO GREGORIO;MONTERO EZPONDABURUIGNACIO;DIAZ GONZALEZ RICARDO. Datos registrales. T 22433 , F 95, S 8, H M 400798, I/A 8 ( 3.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n