Buscador CIF Logo

Actos BORME Gestion Tributaria Territorial Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gestion Tributaria Territorial Sa

Actos BORME Gestion Tributaria Territorial Sa - A81957367

Tenemos registrados 116 Actos BORME del Registro Mercantil de Alicante para Gestion Tributaria Territorial Sa con CIF A81957367

馃敊 Perfil de Gestion Tributaria Territorial Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Alicante

Actos BORME de Gestion Tributaria Territorial Sa

04 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: BERNAL TALAVE VERONICA. Apo.Man.Soli: BERNAL TALAVE VERONICA. Datos registrales. T 4387, F 111, S 8, H A 133643, I/A 80 (27.11.23).

10 de Octubre de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4387 , F 111, S 8, H A 133643, I/A 79 ( 2.10.23).

03 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GIL LLERENA JUAN JOSE. Datos registrales. T 4387 , F 111, S 8, H A 133643, I/A 78 (21.04.23).

16 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRANCES TORTOSA RICARDO. Datos registrales. T 4387 , F 109, S 8, H A 133643, I/A 77 (9.02.23).

15 de Febrero de 2023
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GIANT BIDCO SL. Datos registrales. T 4387 , F 109, S 8, H A 133643, I/A 76 (7.02.23).

27 de Abril de 2022
Nombramientos. Apoderado: DEL RIO GONZALEZ MARIA JESUS. Apo.Manc.: DEL RIO GONZALEZ MARIA JESUS. Datosregistrales. T 4387 , F 100, S 8, H A 133643, I/A 75 (19.04.22).

02 de Marzo de 2022
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 4387 , F 107, S 8, H A 133643, I/A 74 (22.02.22).

28 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: CERECEDA ORUEZABAL CAROLINA. Apo.Man.Soli: CERECEDA ORUEZABAL CAROLINA. Datosregistrales. T 4387 , F 107, S 8, H A 133643, I/A 73 (17.02.22).

25 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: OLMO ASENSIO SERGIO. Apo.Man.Soli: OLMO ASENSIO SERGIO. Datos registrales. T 4387 , F106, S 8, H A 133643, I/A 72 (17.02.22).

23 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE;OSES MUGICA NURIA. Apo.Manc.: PLAZA GONZALEZFERNANDO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;PEREZ FORNIESFRANCISCO;PEREZ ALONSO ROSA DOLORES. Apo.Sol.: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;RICO ALONSO CARLOSMANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;PEREZ FORNIES FRANCISCO;PEREZ ALONSO ROSA DOLORES.Apo.Man.Soli: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSEFERNANDO;PEREZ FORNIES FRANCISCO;PEREZ ALONSO ROSA DOLORES. Apo.Manc.: PLAZA GONZALEZFERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL. Apoderado: PLAZA GONZALEZFERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;HERRERO LUCAS DANIEL. Apo.Manc.: HERRERO LUCAS DANIEL.Apo.Man.Soli: SANCHEZ DOMENECH RAQUEL;ORTS GUTIERREZ PAULA;LOPEZ SERRANO GUADALUPE DE LOS ANGELES.Datos registrales. T 4387 , F 105, S 8, H A 133643, I/A 70 (14.02.22).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ ACOSTA MELISA ORENCIA. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ ACOSTA MELISA ORENCIA.Datos registrales. T 4387 , F 105, S 8, H A 133643, I/A 71 (16.02.22).

01 de Octubre de 2021
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TAXEFFORTS SL. Datos registrales. T 4387 , F 105, S 8, H A 133643, I/A 69(23.09.21).

28 de Julio de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA MARTOS SUSANA. Datos registrales. T 4387 , F 105, S 8, H A 133643, I/A 68 (20.07.21).

23 de Julio de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: CANDELA PINA FRANCISCO. Apo.Sol.: CANDELA PINA FRANCISCO. Apo.Man.Soli: CANDELA PINAFRANCISCO. Apo.Manc.: CANDELA PINA FRANCISCO. Apoderado: CANDELA PINA FRANCISCO. Datos registrales. T 4387 , F104, S 8, H A 133643, I/A 67 (15.07.21).

20 de Julio de 2021
Nombramientos. Apoderado: ARIAS GISBERT JORGE. Apo.Man.Soli: ARIAS GISBERT JORGE. Datos registrales. T 4387 , F 104,S 8, H A 133643, I/A 66 (12.07.21).

05 de Julio de 2021
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TAXEFFORTS SL. Datos registrales. T 4217 , F 205, S 8, H A 133643, I/A 65(25.06.21).

04 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: ISMAYILOV JAMAL MUBARIZ;DE QUEROL DELCLAUX I脩IGO MARIA;CHERCHALI NASSIN.Apo.Manc.: CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;GARCIA MARTOS SUSANA;PEREZ ALONSO ROSA DOLORES;BANOUHMARTIN SAADA. Apo.Sol.: CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;GARCIA MARTOS SUSANA;PEREZ ALONSO ROSADOLORES;BANOUH MARTIN SAADA. Apo.Manc.: CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;PEREZ ALONSO ROSA DOLORES.Apo.Sol.: CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;BANOUH MARTIN SAADA;PEREZ ALONSO ROSA DOLORES;CA脩IZARESGONZALEZ JOSE FERNANDO;PEREZ ALONSO ROSA DOLORES. Apo.Man.Soli: CA脩IZARES GONZALEZ JOSEFERNANDO;GARCIA MARTOS SUSANA;PEREZ ALONSO ROSA DOLORES;BANOUH MARTIN SAADA. Apo.Manc.: RICO ALONSOCARLOS MANUEL;RICO ALONSO CARLOS MANUEL;RICO ALONSO CARLOS MANUEL. Datos registrales. T 4217 , F 204, S 8, HA 133643, I/A 64 (26.05.21).

24 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LABORDA BAILO AURORA. Datos registrales. T 4217 , F 203, S 8, H A 133643, I/A 63 (17.05.21).

06 de Abril de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4217 , F 202, S 8, H A 133643, I/A 61 (24.03.21).

25 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE;EYRIES GARCIA DE VINUESA IGNACIO;HERREROLUCAS DANIEL;PLAZA GONZALEZ FERNANDO;ZUDAIRE SAROBE JOSE MIGUEL BLAS;JUNCO DE MIGUEL RICARDOVALENTIN;OSES MUGICA NURIA. Presidente: CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE. SecreNoConsj: FERNANDEZ CONTRERASGONZALO. VsecrNoConsj: DIAZ GRIDILLA PABLO. Nombramientos. Adm. Unico: GIANT BIDCO SL. Modificacionesestatutarias. Art铆culo 18. Modos de organizar la administraci贸n. Art铆culo 19. Retribuci贸n del 贸rgano de administraci贸n.. Art铆culo 20.-Duraci贸n del cargo.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.Datos registrales. T 4217 , F 202, S 8, H A 133643, I/A 60 (16.03.21).

02 de Junio de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ ROBLES PEDRO JESUS. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ ROBLES PEDRO JESUS. Datosregistrales. T 4217 , F 202, S 8, H A 133643, I/A 59 (26.05.20).

27 de Mayo de 2020
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MARTOS SUSANA;GIL LLERENA JUAN JOSE. Apo.Man.Soli: GIL LLERENA JUAN JOSE.Apoderado: SANCHEZ DOMENECH RAQUEL. Apo.Man.Soli: MONTERO PRIETO ANA ISABEL;LOSADA CAMPA JOSECARLOS;CANDELA GALLUD CLIO. Apo.Sol.: LOPEZ SERRANO GUADALUPE. Apo.Man.Soli: LOPEZ SERRANO GUADALUPE.Apo.Sol.: ROBLES GARCIA RAMIRO. Datos registrales. T 4217 , F 202, S 8, H A 133643, I/A 58 (19.05.20).

04 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Presidente: ROBLES GARCIA RAMIRO. Consejero: ROBLES GARCIA RAMIRO. Nombramientos. Consejero:OSES MUGICA NURIA. Presidente: CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE. Datos registrales. T 4217 , F 201, S 8, H A 133643, I/A57 (25.02.20).

27 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ LUNA VICTORIA CESAR AUGUSTO. Datos registrales. T 4217 , F 201, S 8, H A 133643,I/A 56 (18.12.19).

20 de Junio de 2019
Modificaciones estatutarias. Art铆culo 22潞. Convocatoria y funcionamiento del consejo. Datos registrales. T 4217 , F 200, S 8, H A133643, I/A 47 (12.06.19).

07 de Junio de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ SERRANO GUADALUPE DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 4217 , F 199, S 8, H A133643, I/A 45 (30.05.19).

06 de Junio de 2019
Fe de erratas: Rectificada la inscripci贸n 34陋 de otorgamiento de poder en el sentido de que las facultades conferidas a la apoderada,son de EXCLUSIVO EJERCICIO EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA REGION DE MURCIA y no de EXCLUSIVO EJERCICIO ENEL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALU脩A,. Datos registrales. T 4181 , F 11, S 8, H A 133643,I/A 44 (29.05.19).

05 de Junio de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ DOMENECH RAQUEL. Datos registrales. T 4217 , F 198, S 8, H A 133643, I/A 43(29.05.19).

04 de Junio de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTS GUTIERREZ PAULA. Datos registrales. T 4181 , F 11, S 8, H A 133643, I/A 42 (27.05.19).

31 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOSADA CAMPA JOSE CARLOS. Datos registrales. T 4181 , F 10, S 8, H A 133643, I/A 41(24.05.19).

30 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIL LLERENA JUAN JOSE. Datos registrales. T 4181 , F 9, S 8, H A 133643, I/A 40 (23.05.19).

29 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA MARTOS SUSANA. Datos registrales. T 4181 , F 8, S 8, H A 133643, I/A 39 (21.05.19).

27 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTERO PRIETO ANA ISABEL. Datos registrales. T 4181 , F 7, S 8, H A 133643, I/A 38(17.05.19).

05 de Marzo de 2019
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 4181 , F 7, S 8, H A 133643, I/A 37 (25.02.19).

23 de Enero de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRUZ COBO JOSE. Datos registrales. T 4181 , F 6, S 8, H A 133643, I/A 36 (15.01.19).

22 de Enero de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ MENDEZ ESTEBAN. Datos registrales. T 4181 , F 5, S 8, H A 133643, I/A 35(14.01.19).

18 de Enero de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA FERRER MARIA ISABEL. Datos registrales. T 4075 , F 81, S 8, H A 133643, I/A 34(10.01.19).

24 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: ROBLES GARCIA RAMIRO. Datos registrales. T 4075 , F 79, S 8, H A 133643, I/A 33 (14.12.18).

21 de Diciembre de 2018
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 769,60 Euros. Desembolsado: 769,60 Euros. Resultante Suscrito: 5.801.764,28 Euros. ResultanteDesembolsado: 5.801.764,28 Euros. Datos registrales. T 4075 , F 79, S 8, H A 133643, I/A 32 (13.12.18).

15 de Noviembre de 2018
Cambio de objeto social. I. Realizaci贸n de estudios, informes y asistencia t茅cnica de car谩cter tributario, catastral, cartogr谩fico,inform谩tico y de sistemas organizativos relacionados con la gesti贸n de los tributos y otros ingresos de derecho p煤blico; as铆 como lagesti贸n econ贸mica, administrativa, de personal y patrimonial. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: COLABORACIONTECNICA TRIBUTARIA SL. TRIBUGEST GESTION DE TRIBUTOS SA. Datos registrales. T 4075 , F 78, S 8, H A 133643, I/A 31 (6.11.18).

22 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. L. Asesor: CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 4075 , F 78, S 8, H A 133643, I/A30 (13.08.18).

09 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;DE LA TORRE MANJON FRANCISCO;RICO ALONSO CARLOSMANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;PEREZ FORNIES FRANCISCO;CANDELA PINA FRANCISCO. Apo.Manc.:PLAZA GONZALEZ FERNANDO;DE LA TORRE MANJON FRANCISCO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL;CA脩IZARES GONZALEZJOSE FERNANDO;PEREZ FORNIES FRANCISCO;CANDELA PINA FRANCISCO. Apo.Sol.: PLAZA GONZALEZFERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO. Apo.Manc.: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZJOSE FERNANDO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL;DE LA TORRE MANJON FRANCISCO. Apo.Sol.: PLAZA GONZALEZFERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;CANDELA PINA FRANCISCO;ZAVALA VALDES ALFREDO;PE脩ARANDAGONZALEZ-ROBATTO PEDRO;PEREZ ALONSO ROSA. Apo.Manc.: PEREZ ALONSO ROSA. Datos registrales. T 4075 , F 78, S 8,H A 133643, I/A 29 (27.04.18).

07 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: OSES MUGICA NURIA. Nombramientos. Consejero: EYRIES GARCIA DE VINUESA IGNACIO.Datos registrales. T 4075 , F 77, S 8, H A 133643, I/A 28 (28.02.18).

29 de Enero de 2018
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 6. Derechos de las acciones. Datos registrales. T 4075 , F 77, S 8, H A 133643, I/A 27(19.01.18).

04 de Enero de 2018
Ceses/Dimisiones. Presidente: CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE. Nombramientos. Presidente: ROBLES GARCIA RAMIRO.Consejero: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;ROBLES GARCIA RAMIRO;ZUDAIRE SAROBE JOSE MIGUEL BLAS;JUNCO DEMIGUEL RICARDO VALENTIN. Datos registrales. T 4075 , F 77, S 8, H A 133643, I/A 26 (26.12.17).

29 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4075 , F 77, S 8, H A 133643, I/A 25 (21.11.17).

16 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE;OSES MUGICA NURIA. Apo.Manc.: PLAZA GONZALEZFERNANDO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;PEREZ FORNIESFRANCISCO;CANDELA PINA FRANCISCO;PEREZ ALONSO ROSA. Apo.Sol.: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;RICO ALONSOCARLOS MANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;PEREZ FORNIES FRANCISCO;CANDELA PINAFRANCISCO;PEREZ ALONSO ROSA. Apo.Man.Soli: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;RICO ALONSO CARLOSMANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;PEREZ FORNIES FRANCISCO;CANDELA PINA FRANCISCO;PEREZALONSO ROSA. Apo.Manc.: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;RICO ALONSO CARLOSMANUEL;CANDELA PINA FRANCISCO. Apoderado: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZ JOSEFERNANDO;CANDELA PINA FRANCISCO;HERRERO LUCAS DANIEL. Apo.Manc.: HERRERO LUCAS DANIEL. Datos registrales.T 3667 , F 192, S 8, H A 133643, I/A 24 ( 7.11.17).

21 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: REALZA ASESORES SL;REALZA PARTNERS SL;REALZA CAPITAL SGECR SA. SecreNoConsj:BENITO SANCHEZ ROBERTO. VsecrNoConsj: RUIZ DE LARA RODRIGUEZ DAVID. Presidente: REALZA CAPITAL SGECR SA.Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZ CONTRERAS GONZALO. VsecrNoConsj: DIAZ GRIDILLA PABLO. Consejero:CENTELLES SATRUSTEGUI ENRIQUE;OSES MUGICA NURIA;HERRERO LUCAS DANIEL. Presidente: CENTELLESSATRUSTEGUI ENRIQUE. Datos registrales. T 3667 , F 192, S 8, H A 133643, I/A 23 (13.09.17).

28 de Junio de 2017
Revocaciones. Apoderado: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZJOSE FERNANDO;PLAZA GONZALEZ FERNANDO;PEREZ ALONSO ROSA;GARCIA MARTOS SUSANA;CARRILLO CARRASCOSONIA. Apo.Man.Soli: LOSADA CAMPA JOSE CARLOS. Datos registrales. T 3667 , F 192, S 8, H A 133643, I/A 22 (20.06.17).

23 de Junio de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ ALONSO ROSA. Apo.Manc.: PEREZ ALONSO ROSA. Datos registrales. T 3667 , F 191, S 8, H

21 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ SERRANO GUADALUPE. Apo.Man.Soli: LOPEZ SERRANO GUADALUPE. Datos registrales. T3667 , F 190, S 8, H A 133643, I/A 20 (13.03.17).

05 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ LUNA VICTORIA CESAR AUGUSTO. Datos registrales. T 3667 , F 189, S 8, H A 133643,I/A 19 (27.09.16).

31 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3667 , F 189, S 8, H A 133643, I/A 18 (22.08.16).

02 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA FERRER MARIA ISABEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANDELA GALLUD CLIO.Datos registrales. T 3667 , F 188, S 8, H A 133643, I/A 17 (24.02.16).

01 de Octubre de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3667 , F 188, S 8, H A 133643, I/A 16 (23.09.15).

27 de Julio de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.900.000,91 Euros. Resultante Suscrito: 5.800.994,68 Euros. Datos registrales. T 3667 ,F 188, S 8, H A 133643, I/A 14 (17.07.15).

23 de Junio de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.237.132,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.700.995,59 Euros. Datos registrales. T 3667 ,F 187, S 8, H A 133643, I/A 13 (16.06.15).

09 de Febrero de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3667 , F 187, S 8, H A 133643, I/A 12 ( 2.02.15).

22 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CONDE VI脩UELAS VICENTE. VsecrNoConsj: GOMEZ DE MIGUEL JAVIER. Nombramientos.SecreNoConsj: BENITO SANCHEZ ROBERTO. VsecrNoConsj: RUIZ DE LARA RODRIGUEZ DAVID. Datos registrales. T 3667 , F187, S 8, H A 133643, I/A 11 (14.01.15).

26 de Junio de 2014
Revocaciones. Apoderado: RUBIO MATEOS JOSE. Datos registrales. T 3667 , F 187, S 8, H A 133643, I/A 10 (19.06.14).

27 de Enero de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOSADA CAMPA JOSE CARLOS. Datos registrales. T 3667 , F 186, S 8, H A 133643, I/A 9(20.01.14).

08 de Enero de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3667 , F 186, S 8, H A 133643, I/A 8 (30.12.13).

07 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE ZAVALA VALDES ALFREDO. Presidente: DE ZAVALA VALDES ALFREDO. Nombramientos.Consejero: REALZA ASESORES SL. Presidente: REALZA CAPITAL SGECR SA. Datos registrales. T 3667 , F 186, S 8, H A 133643,I/A 7 (30.07.13).

14 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: APARICIO VALLS EMILIO;PROA脩O VICENTE ANGEL. Datos registrales. T 3667 , F 186, S 8, H A133643, I/A 5 ( 6.05.13).

11 de Abril de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;DE LA TORRE MANJON FRANCISCO;RICO ALONSO CARLOSMANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;PEREZ FORNIES FRANCISCO;CANDELA PINA FRANCISCO.Nombramientos. Apo.Sol.: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;DE LA TORRE MANJON FRANCISCO;RICO ALONSO CARLOSMANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;PEREZ FORNIES FRANCISCO;CANDELA PINA FRANCISCO. Apo.Manc.:PLAZA GONZALEZ FERNANDO;DE LA TORRE MANJON FRANCISCO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL;CA脩IZARES GONZALEZJOSE FERNANDO;PEREZ FORNIES FRANCISCO;CANDELA PINA FRANCISCO. Apo.Sol.: PLAZA GONZALEZFERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO. Apo.Manc.: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZJOSE FERNANDO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL;DE LA TORRE MANJON FRANCISCO. Apo.Sol.: PLAZA GONZALEZFERNANDO;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;CANDELA PINA FRANCISCO;DE ZAVALA VALDESALFREDO;PE脩ARANDA GONZALEZ-ROBATTO PEDRO. Datos registrales. T 3667 , F 184, S 8, H A 133643, I/A 4 ( 4.04.13).

13 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: REALZA CAPITAL SGECR SA. VsecrNoConsj: CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO.Nombramientos. SecreNoConsj: CONDE VI脩UELAS VICENTE. VsecrNoConsj: GOMEZ DE MIGUEL JAVIER. Datos registrales. T3667 , F 184, S 8, H A 133643, I/A 3 ( 5.03.13).

01 de Marzo de 2013
Cambio de domicilio social. AVDA DEPORTISTA MIRIAM BLASCO 1 BIS (ALICANTE). Datos registrales. T 3667 , F 184, S 8, H A133643, I/A 2 (20.02.13).

10 de Enero de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: JIMENEZ APARICIO JESUS;ALVAREZ AQUINO JUAN FRANCISCO;GUTIERREZ GARCIAJORGE;ESPARZA LARRAMENDI CESAR;CANO SANCHEZ LORENZO;EZQUIAGA DOMINGUEZ IGNACIO;VICU脩A CASTREJONJOSE MARIA;TORIBIO GARCIA CONSTANTINO;RUBIO GARCIA CRISTINA;HALPERN SERRA CARLOS FEDERICO;SANCHEZTEJEDA EUGENIO. Consejero: CORPORACION EMPRESARIAL CAJASOL SA;CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEAVILA;CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS;CORRAL DELGADO SERGIO;CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DEARAGON;HISCAN PATRIMONIO II SL;ROBLES GARCIA RAMIRO. Con.Delegado: ROBLES GARCIA RAMIRO. Consejero:RODRIGUEZ BRITO JESUS FRANCISCO;CORPORACION EMPRESARIAL CAJA RIOJA SAU;CAJA INSULAR DE AHORROS DECANARIAS;RUBIO GRACIA JOSE LUIS;INVERGESTION SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION SA;JULIA RIBOTLORENZO;RODRIGUEZ BAUTISTA ANTONIO;CAMIN DE LA MESA SA;PE脩A RUEDA SL;PEDRERO MARTINEZ JESUS;PROA脩O

Modificaciones estatutarias. SE APRUEBA UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 29583 , F 129, S 8, H M 217606, I/A 146 ( 2.01.13).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: NANSA CAPITAL SL. Datos registrales. T 29583 , F 131, S 8, H M 217606, I/A 147( 2.01.13).

24 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: PIANELO BURGOS JOSEFA. Datos registrales. T 29583 , F 127, S 8, H M 217606, I/A 143 (17.12.12).

Revocaciones. Apoderado: VICEDO TERRADEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 29583 , F 128, S 8, H M 217606, I/A 144(17.12.12).

14 de Septiembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: BAUSELA COLLANTES LUIS. Datos registrales. T 29583 , F 127, S 8, H M 217606, I/A 142

03 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29583 , F 127, S 8, H M 217606, I/A 141(24.07.12).

24 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Representan: CANTALICIO PANTOJA PABLO. Nombramientos. Representan: ALVAREZ AQUINO JUANFRANCISCO. Datos registrales. T 29583 , F 127, S 8, H M 217606, I/A 140 (12.07.12).

14 de Junio de 2012
Revocaciones. Apoderado: MONTERO PRIETO ANA ISABEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTERO PRIETO ANA ISABEL.Datos registrales. T 25010 , F 115, S 8, H M 217606, I/A 139 ( 4.06.12).

01 de Junio de 2012
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: PEREZ RUIZ TOMAS. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 134&, LAPUBLICACION DEL CESE COMO VICEPRESIDENTE DE TOMAS PEREZ RUIZ. Datos registrales. T 25010 , F 113, S 8, H M217606, I/A 134 ( 2.04.12).

31 de Mayo de 2012
Modificaciones estatutarias. 8. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 25010 , F 115, S 8, H M 217606, I/A 138(21.05.12).

30 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: BRI脩AS SANTAMARIA JOSE RAFAEL;CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA;CAJADE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA. Representan: GARCIA REDONDO MIGUEL ANGEL;MARTINEZSAMPEDRO FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Consejero: BAUSELA COLLANTES LUIS;CAMIN DE LA MESA SA;PE脩ARUEDA SL. Representan: HALPERN SERRA CARLOS FEDERICO;SANCHEZ TEJEDA EUGENIO. Otros conceptos: RATIFICADOPOR LA JUNTA GENERAL DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2012, EL NOMBRAMIENTO REALIZADO POR COOPTACION DE LAENTIDAD " BANCO MARE NOSTRUM SA " , COMO CONSEJERO Y PRESIDENTE DE LA MISMA.- Datos registrales. T 25010 , F114, S 8, H M 217606, I/A 136 (18.05.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALEU SANCHEZ ROBERTO. Nombramientos. Consejero: PEDRERO MARTINEZJESUS;PROA脩O VICENTE ANGEL. Datos registrales. T 25010 , F 115, S 8, H M 217606, I/A 137 (18.05.12).

29 de Mayo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: LUCAS HERNANDEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Representan: EZQUIAGA DOMINGUEZIGNACIO. Consejero: BANCO MARE NOSTRUM SA. Presidente: BANCO MARE NOSTRUM SA. Datos registrales. T 25010 , F 114,S 8, H M 217606, I/A 135 (18.05.12).

19 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ RUIZ TOMAS. Datos registrales. T 25010 , F 113, S 8, H M 217606, I/A 134 ( 2.04.12).

15 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES SA. Consejero: ANALISTAS FINANCIEROSINTERNACIONALES SA. Representan: MANZANO ROMERO DANIEL. Datos registrales. T 25010 , F 113, S 8, H M 217606, I/A 132( 5.03.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA. Representan: ESTEBARANZ CAMARDIEL ANGELMARIA. Datos registrales. T 25010 , F 113, S 8, H M 217606, I/A 133 ( 5.03.12).

14 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ MERA DOMINGO. Datos registrales. T 25010 , F 113, S 8, H M 217606, I/A 131 (2.03.12).

27 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Representan: CASTRO RODRIGUEZ RAIMUNDO. Nombramientos. Representan: RUBIO GARCIA CRISTINA.

15 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Representan: MARTINEZ HERRAY JOSE LUIS. Consejero: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA. Datosregistrales. T 25010 , F 113, S 8, H M 217606, I/A 129 ( 6.02.12).

09 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CORPORACION CAIXA GALICIA SA. Representan: DOMINGUEZ MARTINEZ FRANCISCO. Datosregistrales. T 25010 , F 112, S 8, H M 217606, I/A 128 (27.01.12).

07 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAM CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO. Presidente: CAM CAJA DE AHORROS DELMEDITERRANEO. Representan: LOPEZ ABAD ROBERTO. Datos registrales. T 25010 , F 112, S 8, H M 217606, I/A 127 (27.01.12).

05 de Agosto de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TEROL CANO MARIA JOSE. Datos registrales. T 25010 , F 111, S 8, H M 217606, I/A 126(26.07.11).

29 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Representan: ARMENTA GONZALEZ PALENZUELA AUGUSTO. Nombramientos. Representan: CANTALICIOPANTOJA PABLO. Datos registrales. T 25010 , F 111, S 8, H M 217606, I/A 125 (15.06.11).

07 de Junio de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25010 , F 111, S 8, H M 217606, I/A 124(26.05.11).

01 de Junio de 2011
Otros conceptos: SE RATIFICA COMO CONSEJER DE LA SOCIEDAD A CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEEXTREMADURA Y A SU REPRESENTANTE DON MIGUEL ANGEL GARCIA REDONDO. Datos registrales. T 25010 , F 111, S 8, HM 217606, I/A 123 (20.05.11).

12 de Mayo de 2011
Nombramientos. Consejero: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA. Representan: GARCIA REDONDOMIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 25010 , F 111, S 8, H M 217606, I/A 122 (29.04.11).

15 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: EZQUIAGA DOMINGUEZ IGNACIO RAMON;GARCIA REDONDO MIGUEL ANGEL. Vicepresid.:EZQUIAGA DOMINGUEZ IGNACIO RAMON. Datos registrales. T 25010 , F 110, S 8, H M 217606, I/A 121 ( 5.04.11).

10 de Marzo de 2011
Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA INDA AGUSTIN. Nombramientos. Representan: CANO SANCHEZ LORENZO. Datosregistrales. T 25010 , F 110, S 8, H M 217606, I/A 120 (28.02.11).

23 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA ESPA脩A DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS;DIAZ CRESPO JUAN MANUEL;DOLS

30 de Julio de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25010 , F 109, S 8, H M 217606, I/A 118 (20.07.10).

12 de Julio de 2010
Revocaciones. Apoderado: PLAZA GONZALEZ FERNANDO;DE LA TORRE MANJON FRANCISCO;RICO ALONSO CARLOSMANUEL;CA脩IZARES GONZALEZ JOSE FERNANDO;PEREZ FORNIES FRANCISCO. Apo.Sol.: DE LA TORRE MANJONFRANCISCO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL. Apoderado: CANDELA PINA FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Man.Soli:PLAZA GONZALEZ FERNANDO;DE LA TORRE MANJON FRANCISCO;RICO ALONSO CARLOS MANUEL;CA脩IZARES GONZALEZJOSE FERNANDO;PEREZ FORNIES FRANCISCO;CANDELA PINA FRANCISCO. Datos registrales. T 25010 , F 107, S 8, H M217606, I/A 117 (30.06.10).

04 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO. Reelecciones. Consejero: LUCAS HERNANDEZ JOSELUIS;RUBIO GRACIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 25010 , F 106, S 8, H M 217606, I/A 116 (22.04.10).

08 de Abril de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: SANTANA ROSA JOSE MANUEL. Nombramientos. Representan: TORIBIO GARCIACONSTANTINO. Datos registrales. T 25010 , F 106, S 8, H M 217606, I/A 115 (24.03.10).

08 de Octubre de 2009
Ceses/Dimisiones. Representan: BA脩ON IRUJO ALVARO. Nombramientos. Representan: ESPARZA LARRAMENDI CESAR.Datos registrales. T 25010 , F 106, S 8, H M 217606, I/A 114 (28.09.09).

02 de Octubre de 2009
Reelecciones. Representan: SANTANA ROSA JOSE MANUEL. Consejero: CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS. Datosregistrales. T 25010 , F 105, S 8, H M 217606, I/A 113 (22.09.09).

14 de Septiembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: MENDIETA ARJONA MANUEL. Datos registrales. T 25010 , F 105, S 8, H M 217606, I/A 112 (2.09.09).

10 de Agosto de 2009
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 4.329,78 Euros. Desembolsado: 4.329,78 Euros. Resultante Suscrito: 10.938.127,59 Euros.Resultante Desembolsado: 10.938.127,59 Euros. Datos registrales. T 25010 , F 104, S 8, H M 217606, I/A 111 (29.07.09).

22 de Julio de 2009
Reelecciones. Consejero: ALEU SANCHEZ ROBERTO;CORPORACION EMPRESARIAL CAJA RIOJA SAU. Datos registrales. T25010 , F 104, S 8, H M 217606, I/A 110 ( 9.07.09).

16 de Junio de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25010 , F 104, S 8, H M 217606, I/A 109 ( 4.06.09).

07 de Mayo de 2009
Revocaciones. Apoderado: PELLICER ROIG CLARA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA FERRER MARIA ISABEL. Datosregistrales. T 25010 , F 102, S 8, H M 217606, I/A 108 (27.04.09).

01 de Abril de 2009
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.421.147,81 Euros. Desembolsado: 3.421.147,81 Euros. Resultante Suscrito: 10.933.797,81 Euros.Resultante Desembolsado: 10.933.797,81 Euros. Datos registrales. T 25010 , F 101, S 8, H M 217606, I/A 107 (20.03.09).

23 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apoderado: ECHEVARRIA OLALDE IZASKUS. Datos registrales. T 25010 , F 99, S 8, H M 217606, I/A 106(11.03.09).

12 de Marzo de 2009
Revocaciones. Apoderado: VERDU VENDRELL SONIA. Datos registrales. T 25010 , F 95, S 8, H M 217606, I/A 104 ( 2.03.09).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ DOMENECH RAQUEL. Datos registrales. T 25010 , F 95, S 8, H M 217606, I/A 105 (2.03.09).

11 de Marzo de 2009
Nombramientos. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25010 , F 95, S 8, H M 217606, I/A 103 (25.02.09).

27 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Representan: CUNS RIAL ANDRES. Nombramientos. Representan: DOMINGUEZ MARTINEZ FRANCISCO.Datos registrales. T 25010 , F 95, S 8, H M 217606, I/A 102 (18.02.09).

20 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: TRUJILLO FERNANDEZ JOSE ANTONIO;MARTINEZ HERRAY JOSE LUIS. Nombramientos.Representan: MARTINEZ HERRAY JOSE LUIS. Consejero: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA;RODRIGUEZ BRITO JESUSFRANCISCO. Datos registrales. T 25010 , F 94, S 8, H M 217606, I/A 101 (10.02.09).

26 de Enero de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: APARICIO VALLS EMILIO;PROA脩O VICENTE ANGEL. Datos registrales. T 25010 , F 92, S 8, H M217606, I/A 100 (14.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n