Actos BORME de Gestion Y Desarrollo Del Conocimiento Sl
01 de Abril de 2022Nombramientos. Apoderado: MATEOS DEL NOZAL JUAN. Datos registrales. T 1406 , F 145, S 8, H VA 10770, I/A 19 (25.03.22).
Nombramientos. Apoderado: DE LA CALLE ORTEGA MARIA FELISA. Datos registrales. T 1406 , F 145, S 8, H VA 10770, I/A 20(25.03.22).
Revocaciones. Apoderado: PEREZ MARTINEZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 1406 , F 146, S 8, H VA 10770, I/A 21(28.03.22).
23 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: DE LA CALLE ORTEGA MARIA FELISA. Datos registrales. T 1406 , F 145, S 8, H VA 10770, I/A 18(16.11.21).
24 de Septiembre de 2019Cambio de domicilio social. C/ ENRIQUE CUBERO 9 (VALLADOLID). Datos registrales. T 1406 , F 140, S 8, H VA 10770, I/A 17(17.09.19).
22 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: MORALES AGUADO JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 1406 , F 140, S 8, H VA 10770, I/A 16(15.02.19).
27 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: MORALES AGUADO JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 1406 , F 139, S 8, H VA 10770, I/A 15(20.06.17).
22 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: REDONDO ESTEBAN DANIEL;MORALES AGUADO JUAN IGNACIO. Nombramientos. Adm.Unico: DOMINIO LA ENCINA SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 1406 , F 139, S 8, H VA 10770, I/A 14 (10.05.17).
13 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: PEREZ MARTINEZ JOSE CARLOS. Datos registrales. T 1406 , F 138, S 8, H VA 10770, I/A 13 (7.09.16).
19 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ MARIA NIEVES. Datos registrales. T 1406 , F 138, S 8, H VA 10770, I/A 12(12.02.15).
19 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: REDONDO ESTEBAN DANIEL;CRESPO RIVERO JUAN ANTONIO;MORALES AGUADO JUANIGNACIO. Presidente: REDONDO ESTEBAN DANIEL. Secretario: CRESPO RIVERO JUAN ANTONIO. Cons.Del.Sol: CRESPORIVERO JUAN ANTONIO;REDONDO ESTEBAN DANIEL. Nombramientos. Adm. Solid.: REDONDO ESTEBAN DANIEL;MORALESAGUADO JUAN IGNACIO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 1406 , F 138, S 8, H VA 10770, I/A 11 (12.12.14).
23 de Agosto de 2012Revocaciones. Apoderado: MEDINA CUARESMA MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 1406 , F 138, S 8, H VA 10770, I/A10 (14.08.12).
09 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apoderado: GOMEZ VILLA LUZ FELISA. Datos registrales. T 1406 , F 138, S 8, H VA 10770, I/A 8 (28.11.11).
Revocaciones. Apoderado: FONTURBEL PORRAS ALBERTO ENRIQUE. Datos registrales. T 1406 , F 138, S 8, H VA 10770, I/A 9(28.11.11).
03 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: FONTURBEL PORRAS ALBERTO ENRIQUE. Datos registrales. T 862 , F 225, S 8, H VA 10770, I/A7 (19.04.11).