Buscador CIF Logo

Actos BORME Gestion Y Transporte De Carburantes Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gestion Y Transporte De Carburantes Sociedad Limitada

Actos BORME Gestion Y Transporte De Carburantes Sociedad Limitada - B46341368

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Gestion Y Transporte De Carburantes Sociedad Limitada con CIF B46341368

馃敊 Perfil de Gestion Y Transporte De Carburantes Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Gestion Y Transporte De Carburantes Sociedad Limitada

09 de Diciembre de 2022
Otros conceptos: Se acuerda la suspensi贸n de los acuerdos adoptados en la junta de 25 de febrero de 2022, que no constaninscritos. Datos registrales. T 3751, L 1063, F 180, S 8, H V 14559, I/A A (30.11.22).

15 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTIAGO ZAMORA JUAN JULIAN;GARCIA ESTEBAN MANUEL;GARCIA ESTEBANVICENTE;PRATS CUEVAS JUAN MIGUEL;SANTIAGO ZAMORA FAUSTINO;PRATS CUEVAS MARIA ELENA. Cons.Del.Man:GARCIA ESTEBAN MANUEL. Secretario: PRATS CUEVAS JUAN MIGUEL. Cons.Del.Man: PRATS CUEVAS JUAN MIGUEL.Presidente: SANTIAGO ZAMORA FAUSTINO. Cons.Del.Man: SANTIAGO ZAMORA FAUSTINO. Nombramientos. Consejero:SANTIAGO ZAMORA FAUSTINO;GARCIA ESTEBAN MANUEL;GARCIA ESTEBAN VICENTE;PRATS CUEVAS MARIAELENA;SANTIAGO ALBELDA PEDRO TOMAS;PRATS OLLER GLORIA. Presidente: SANTIAGO ZAMORA FAUSTINO. Secretario:PRATS OLLER GLORIA. Con.Delegado: SANTIAGO ALBELDA PEDRO TOMAS. Datos registrales. T 3751, L 1063, F 179, S 8, H V14559, I/A 21 ( 8.02.21).

09 de Marzo de 2018
Nombramientos. Auditor: EUDITA CJC AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3751, L 1063, F 179, S 8, H V 14559, I/A 20 (2.03.18).

10 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN LATORRE SALVADOR. Datos registrales. T 3751, L 1063, F 179, S 8, H V 14559, I/A 19 (3.03.17).

14 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: SANTIAGO ALBELDA PEDRO TOMAS. Datos registrales. T 3751, L 1063, F 178, S 8, H V 14559, I/A18 ( 6.10.15).

10 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Apo.Sol.: GISBERT CUENCA TOMAS FRANCISCO. Datos registrales. T 3751, L 1063, F 178, S 8, H V 14559,I/A 17 ( 3.08.15).

15 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN LATORRE FRANCISCO ANGEL. Cons.Del.Man: JUAN LATORRE FRANCISCO ANGEL.Datos registrales. T 3751, L 1063, F 178, S 8, H V 14559, I/A 16 ( 8.07.15).

18 de Enero de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: BRU RODRIGUEZ VICENTE JAVIER. Datos registrales. T 3751, L 1063, F 177, S 8, H V 14559, I/A 15(11.01.13).

10 de Julio de 2012
Nombramientos. Apoderado: SANTIAGO ZAMORA JUAN JULIAN. Datos registrales. T 3751, L 1063, F 177, S 8, H V 14559, I/A 14(29.06.12).

30 de Abril de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTIAGO ZAMORA FAUSTINO;PRATS CUEVAS JUAN MIGUEL;GARCIA ESTEBANMANUEL;SANTIAGO ZAMORA JUAN JULIAN;JUAN LATORRE SALVADOR;JUAN LATORRE FRANCISCO ANGEL;PRATS CUEVASMARIA ELENA;COLLADO LAMBEA JOSE GUILLERMO. Presidente: SANTIAGO ZAMORA FAUSTINO. Secretario: PRATS CUEVASJUAN MIGUEL. Cons.Del.Man: SANTIAGO ZAMORA FAUSTINO;PRATS CUEVAS JUAN MIGUEL;JUAN LATORRE FRANCISCOANGEL;GARCIA ESTEBAN MANUEL. Nombramientos. Consejero: GARCIA ESTEBAN MANUEL;GARCIA ESTEBANVICENTE;PRATS CUEVAS JUAN MIGUEL;JUAN LATORRE FRANCISCO ANGEL;SANTIAGO ZAMORA FAUSTINO;SANTIAGOZAMORA JUAN JULIAN;PRATS CUEVAS MARIA ELENA;JUAN LATORRE SALVADOR. Presidente: SANTIAGO ZAMORAFAUSTINO. Secretario: PRATS CUEVAS JUAN MIGUEL. Cons.Del.Man: SANTIAGO ZAMORA FAUSTINO;PRATS CUEVAS JUANMIGUEL;GARCIA ESTEBAN MANUEL;JUAN LATORRE FRANCISCO ANGEL. Datos registrales. T 3751, L 1063, F 176, S 8, H V14559, I/A 13 (21.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n