Actos BORME de Gestora Chamberi Sl
02 de Octubre de 2023Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35142 , F 40, S 8, H M 631969, I/A 13 (22.09.23).
18 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: CARPINTERO MOLINA CRISTINA;ERBURU ZAZPE CARLOS. Datos registrales. T 35142 , F 39, S 8, HM 631969, I/A 11 (11.11.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: CARPINTERO MOLINA CRISTINA. Datos registrales. T 35142 , F 39, S 8, H M 631969, I/A 12(11.11.22).
15 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: ROMERO QUESADA JESUS;ERBURU ZAZPE CARLOS;SANCEDON RODRIGUEZ CRISTINAISABEL. Datos registrales. T 35142 , F 38, S 8, H M 631969, I/A 10 ( 8.02.22).
24 de Enero de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: POLA ROJO PALOMA. Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ SANCHEZ PEDRO;LEAL RUIZEMILIO;LLANSO FELGUEROSO CARLOS;LOPEZ GONZALEZ CARLOS. Datos registrales. T 35142 , F 37, S 8, H M 631969, I/A 9(17.01.22).
20 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: LLANSO FELGUEROSO CARLOS;MU脩OZ SANCHEZ PEDRO;LEAL RUIZ EMILIO;ARRIBASHERNAEZ FERNANDO. Datos registrales. T 35142 , F 37, S 8, H M 631969, I/A 8 (13.01.22).
29 de Noviembre de 2018Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 6陋 EL NOMBRAMIENTO DE DIAZ ETIENNE MABELA COMOADMINISTRADOR UNICO, SIENDO LO CORRECTO ADMINISTRADOR SOLIDARIO. Datos registrales. T 35142 , F 36, S 8, H M631969, I/A 6 (30.07.18).
02 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: GASTON MAGGI BESCOS GONZALO. Nombramientos. Apoderado: ROMERO QUESADAJESUS;SANCEDON RODRIGUEZ CRISTINA ISABEL. Datos registrales. T 35142 , F 37, S 8, H M 631969, I/A 7 (25.09.18).
06 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: DIAZ ESTRADA JORGE JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: DIAZ ETIENNE MABELA.Reelecciones. Adm. Solid.: DIAZ ETIENNE ALONSO. Datos registrales. T 35142 , F 36, S 8, H M 631969, I/A 6 (30.07.18).
11 de Diciembre de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 510.000,00 Euros. Datos registrales. T 35142 , F 36, S 8, HM 631969, I/A 5 (29.11.17).
03 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO QUESADA JESUS;GASTON MAGGI BESCOS GONZALO. Datos registrales. T 35142 , F35, S 8, H M 631969, I/A 4 (25.09.17).
07 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: MU脩OZ SANCHEZ PEDRO;LEAL RUIZ EMILIO;POLA ROJO PALOMA. Datos registrales. T 35142 ,F 35, S 8, H M 631969, I/A 3 (28.11.16).
24 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DIAZ ESTRADA JORGE JAVIER. Nombramientos. Adm. Solid.: DIAZ ESTRADA JORGEJAVIER;DIAZ ETIENNE ALONSO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradoressolidarios. Datos registrales. T 35142 , F 34, S 8, H M 631969, I/A 2 (14.10.16).
28 de Septiembre de 2016Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 19.07.16. Objeto social: a) La explotaci贸n de hoteles y alojamientos similares, servicioshoteleros, hosteleros, discotecas y otros relacionados con la restauraci贸n gastron贸mica y los espect谩culos p煤blicos. Alojamientostur铆sticos y otros alojamientos de corta estancia, explotaci贸n de apartamentos privados directamente,. Domicilio: C/ PEDRO DEVALDIVIA 31 (MADRID). Capital: 10.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: EXACORP ONE SL.Nombramientos. Adm. Unico: DIAZ ESTRADA JORGE JAVIER. Datos registrales. T 35142 , F 32, S 8, H M 631969, I/A 1(20.09.16).