Actos BORME de Gestora Comercial Internacional Sl
20 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: CARRIEDO CUESTA MARIA DEL CARMEN;ACOSTA GIL MARIA MONICA. Apo.Sol.: ACOSTA GILMARIA MONICA. Apo.Manc.: ACOSTA GIL MARIA MONICA. Apo.Sol.: ACOSTA GIL ANTONIO-JESUS. Apo.Manc.: BARBERO DELMORAL JUAN. Datos registrales. T 4182, L 4182, F 57, S 8, H PO 61499, I/A 11 ( 9.11.23).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: TRI-WALL EUROPE HOLDING LIMITED. Datos registrales. T4182, L 4182, F 57, S 8, H PO 61499, I/A 12 ( 9.11.23).
17 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CATALOGO VIRTUAL SA. Nombramientos. Consejero: HORI HIROFUMI;SUZUKI YUJI;OZGENEMRAH. Presidente: OZGEN EMRAH. SecreNoConsj: TATAY LOPEZ LUIS. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T 4182, L 4182, F 57, S 8, H PO 61499, I/A 10 (9.11.23).
06 de Noviembre de 2023Nombramientos. Aud.C.Con.: CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL. Datos registrales. T 4182, L 4182, F 56, S 8, H PO61499, I/A 8 (27.10.23).
Reelecciones. Auditor: CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL. Datos registrales. T 4182, L 4182, F 56, S 8, H PO 61499,I/A 9 (27.10.23).
23 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: TORNEIRO ABUIN PABLO. Datos registrales. T 4182, L 4182, F 54, S 8, H PO 61499, I/A 7(11.10.23).
05 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL. Datos registrales. T 4182, L 4182, F 54, S 8, H PO 61499,I/A 6 (28.01.21).
18 de Junio de 2018Revocaciones. Apoderado: LOPEZ CUEVAS MARIA DE LA PALOMA. Datos registrales. T 4182, L 4182, F 54, S 8, H PO 61499,I/A 5 ( 7.06.18).
04 de Diciembre de 2017Nombramientos. Auditor: CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL. Datos registrales. T 4182, L 4182, F 54, S 8, H PO61499, I/A 4 (24.11.17).
27 de Octubre de 2017Ampliacion del objeto social. e) Transporte terrestre, aéreo y marítimo de todo tipo de mercancías en todo tipo de contenedores porcuenta propia o ajena en forma regular o discrecional dentro y fuera del territorio nacional. Datos registrales. T 4182, L 4182, F 54, S8, H PO 61499, I/A 3 (20.10.17).
14 de Febrero de 2017Cambio de domicilio social. CTRA ESTRADA REDONDELA PEINADOR 91 (REDONDELA). Datos registrales. T 4182, L 4182, F1, S 8, H PO 61499, I/A 1 ( 3.02.17).
Otros conceptos: MODIFICADO el artículo 4 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Cambio de objetosocial. a) Empaquetado, enfajado, emblistado, ensobrado y embalado en plástico, cartón u otros materiales, así como encolado,etiquetado, marcaje, direccionado y cualquier otra manipulación y revisión de un producto propiedad de terceros. b) Diseño, compra,venta y montaje de cualquier tipo de producto de e. Datos registrales. T 4182, L 4182, F 53, S 8, H PO 61499, I/A 2 ( 3.02.17).
26 de Agosto de 2015Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DE LA FUENTE CAROLINA;FERNANDEZ DE LA FUENTE CAROLINA. Datosregistrales. T 13396 , F 225, S 8, H M 92513, I/A 65 (17.08.15).
26 de Enero de 2015Reelecciones. Auditor: AGUILAR CABALLERO MATILDE. Aud.Supl.: GTC AUDITORES SL. Datos registrales. T 13396 , F 225, S8, H M 92513, I/A 64 (19.01.15).
13 de Septiembre de 2013Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.. Artículo de los estatutos: 2.Objeto.- MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL.. Cambio de domicilio social. AVDA DEL HOTEL - NUMERO 13, POLIGONOINDUSTRIAL L (VALDEMORO). Cambio de objeto social. EMPAQUETADO, ENFAJADO, EMBLISTADO, ENSOBRADO YEMBALADO EN PLASTICO, CARTON U OTROS MATERIALES, ASI COMO ENCOLADO, ETIQUETADO, MARCAJE,DIRECCIONADO Y CUALQUIER OTRA MANIPULACION Y REVISION DE UN PRODUCTO PROPIEDAD DE TERCEROS.- DISEÑO,COMPRA, VENTA Y MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO... Datos registrales. T 13396 , F 224, S 8, H M 92513, I/A 63( 5.09.13).
20 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARDIVINSER SL. Representan: ACOSTA GIL MARIA MONICA. Nombramientos. Adm. Unico:CATALOGO VIRTUAL SA. Representan: ACOSTA GIL MARIA MONICA. Datos registrales. T 13396 , F 224, S 8, H M 92513, I/A 62 (6.11.12).
29 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: MARTIN RIVERA FRANCISCO. Datos registrales. T 13396 , F 223, S 8, H M 92513, I/A 61(20.06.12).
05 de Enero de 2012Nombramientos. Auditor: AGUILAR CABALLERO MATILDE. Aud.Supl.: GTC AUDITORES SL. Datos registrales. T 13396 , F 223,S 8, H M 92513, I/A 60 (26.12.11).
21 de Diciembre de 2010Reelecciones. Auditor: RIVERO ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 13396 , F 223, S 8, H M 92513, I/A 59 ( 9.12.10).
29 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Representan: ACOSTA YEPES JULIO. Nombramientos. Representan: ACOSTA GIL MARIA MONICA. Datosregistrales. T 13396 , F 223, S 8, H M 92513, I/A 58 (19.01.10).
11 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: RIVERO ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 13396 , F 223, S 8, H M 92513, I/A 57 (30.10.09).
08 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: CARRIEDO CUESTA MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 13396 , F 221, S 8, H M 92513, I/A54 (27.03.09).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DE LA FUENTE CAROLINA. Datos registrales. T 13396 , F 221, S 8, H M 92513, I/A 55(27.03.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: ACOSTA GIL MARIA MONICA;ACOSTA GIL ANTONIO-JESUS. Datos registrales. T 13396 , F 223, S 8,H M 92513, I/A 56 (27.03.09).