Buscador CIF Logo

Actos BORME Gestora De Infraestructuras Sanitarias De La Comunidad Autonoma De La Region De Murcia Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gestora De Infraestructuras Sanitarias De La Comunidad Autonoma De La Region De Murcia Sa

Actos BORME Gestora De Infraestructuras Sanitarias De La Comunidad Autonoma De La Region De Murcia Sa - A73339053

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Gestora De Infraestructuras Sanitarias De La Comunidad Autonoma De La Region De Murcia Sa con CIF A73339053

馃敊 Perfil de Gestora De Infraestructuras Sanitarias De La Comunidad Autonoma De La Region De Murcia Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Gestora De Infraestructuras Sanitarias De La Comunidad Autonoma De La Region De Murcia Sa

23 de Diciembre de 2013
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SERVICIO MURCIANO DE SALUD. Datos registrales. T 2672 , F203, S 8, H MU 49555, I/A 26 (16.12.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIA ANGELES PALACIOS SANCHEZ. Presidente: MARIA ANGELES PALACIOS SANCHEZ.Consejero: MARTIN QUI脩ONERO SANCHEZ;JOSE ANTONIO ALARCON GONZALEZ. Vicepresid.: MARTIN QUI脩ONEROSANCHEZ. Consejero: JOSE ANTONIO GARCIA CORDOBA. Secretario: JOSE ANTONIO GARCIA CORDOBA. Consejero: MIGUEL-ANGEL BLANES PASCUAL;ANDRES CARRILLO GONZALEZ;LEOPOLDO NAVARRO QUILEZ. Cesi贸n global de activo y pasivo.Beneficiarias de la cesi贸n: SERVICIO MURCIANO DE SALUD. Disoluci贸n. Cesi贸n global de activo y pasivo. Extinci贸n. Datosregistrales. T 2672 , F 203, S 8, H MU 49555, I/A 27 (16.12.13).

16 de Mayo de 2012
Modificaci贸n de poderes. Apoderado: JOSE-ANTONIO GARCIA TORRES. Datos registrales. T 2672 , F 203, S 8, H MU 49555, I/A25 ( 4.05.12).

03 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO SERGIO LOPEZ SANCHEZ SOLIS DE QUEROL;ESTHER ORTIZ MARTINEZ.Nombramientos. Consejero: MIGUEL-ANGEL BLANES PASCUAL;ANDRES CARRILLO GONZALEZ. Datos registrales. T 2672 , F201, S 8, H MU 49555, I/A 24 (26.03.12).

27 de Octubre de 2011
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2672 , F 201, S 8, H MU 49555, I/A 23 (18.10.11).

16 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: LEOPOLDO NAVARRO QUILEZ;MARIA ANGELES PALACIOS SANCHEZ;JOSE LUIS GILNICOLAS;LUIS ALFONSO MARTINEZ ATIENZA;JOSE ANTONIO GARCIA CORDOBA;MARIA DOLORES GOMARIZ MARIN.Presidente: MARIA ANGELES PALACIOS SANCHEZ. Vicepresid.: JOSE LUIS GIL NICOLAS. Secretario: JOSE ANTONIO GARCIACORDOBA. Consejero: JOSE ANTONIO ALARCON GONZALEZ. Nombramientos. Consejero: MARIA ANGELES PALACIOSSANCHEZ. Presidente: MARIA ANGELES PALACIOS SANCHEZ. Consejero: MARTIN QUI脩ONERO SANCHEZ;JOSE ANTONIOALARCON GONZALEZ;ANTONIO SERGIO SANCHEZ SOLIS DE QUEROL;ESTHER ORTIZ MARTINEZ. Vicepresid.: MARTINQUI脩ONERO SANCHEZ. Consejero: JOSE ANTONIO GARCIA CORDOBA. Secretario: JOSE ANTONIO GARCIA CORDOBA. Datosregistrales. T 2672 , F 201, S 8, H MU 49555, I/A 21 ( 6.09.11).

Revocaciones. Apoderado: INOCENCIA GOMEZ FERNANDEZ. Nombramientos. Apoderado: JOSE-ANTONIO GARCIA TORRES.Datos registrales. T 2672 , F 201, S 8, H MU 49555, I/A 22 ( 6.09.11).

01 de Julio de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE MANUEL ALLEGUE GALLEGO. Nombramientos. Consejero: JOSE ANTONIO ALARCONGONZALEZ. Datos registrales. T 2672 , F 201, S 8, H MU 49555, I/A 20 (22.06.10).

06 de Mayo de 2010
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 15.008.000,00 Euros. Desembolsado: 15.008.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 65.408.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 65.408.000,00 Euros. Datos registrales. T 2672 , F 201, S 8, H MU 49555, I/A 19 (27.04.10).

23 de Diciembre de 2009
Revocaciones. Apoderado: INOCENCIA GOMEZ FERNANDEZ. Nombramientos. Apoderado: INOCENCIA GOMEZ FERNANDEZ.Datos registrales. T 2672 , F 200, S 8, H MU 49555, I/A 18 (14.12.09).

19 de Mayo de 2009
Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 4 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES REFERENTE AL OBJETO SOCIAL.- Datosregistrales. T 2167 , F 34, S 8, H MU 49555, I/A 17 ( 6.05.09).

14 de Abril de 2009
Revocaciones. Apoderado: INOCENCIA GOMEZ FERNANDEZ. Nombramientos. Apoderado: INOCENCIA GOMEZ FERNANDEZ.Datos registrales. T 2167 , F 33, S 8, H MU 49555, I/A 16 ( 1.04.09).

10 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIA ANGELES PALACIOS SANCHEZ;JUAN ANTONIO MORALES RODRIGUEZ. Vicepresid.:JOSE LUIS GIL NICOLAS. Secretario: CASIMIRO JIMENEZ GUILLEN. Consejero: ISABEL MARTINEZ CONESA;JOSE LUIS GILNICOLAS;CASIMIRO JIMENEZ GUILLEN. Presidente: MARIA ANGELES PALACIOS SANCHEZ. Nombramientos. Consejero:MARIA ANGELES PALACIOS SANCHEZ;JOSE LUIS GIL NICOLAS;LUIS ALFONSO MARTINEZ ATIENZA;JOSE ANTONIO GARCIACORDOBA;MARIA DOLORES GOMARIZ MARIN. Presidente: MARIA ANGELES PALACIOS SANCHEZ. Vicepresid.: JOSE LUIS GILNICOLAS. Secretario: JOSE ANTONIO GARCIA CORDOBA. Reelecciones. Consejero: JOSE MANUEL ALLEGUEGALLEGO;LEOPOLDO NAVARRO QUILEZ. Datos registrales. T 2167 , F 33, S 8, H MU 49555, I/A 15 (30.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n