Actos BORME de Gev Recambios De Hosteleria Sl
17 de Abril de 2023Cambio de denominaci贸n social. REPA IBERIA S.L. Datos registrales. T 47426 , F 216, S 8, H B 407619, I/A 19 ( 7.04.23).
10 de Mayo de 2022Nombramientos. APODERAD.SOL: SERRANO BATET FRANCESC XAVIER. Datos registrales. T 47426 , F 215, S 8, H B 407619,I/A 18 ( 2.05.22).
19 de Abril de 2022Revocaciones. APODERAD.SOL: FRAILE GARCIA VICTOR. Datos registrales. T 47426 , F 215, S 8, H B 407619, I/A 17 ( 5.04.22).
18 de Enero de 2021Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: LF REPUESTOS HORECA SL. Datos registrales. T 47426 , F 213, S 8, H B407619, I/A 16 (11.01.21).
15 de Enero de 2021Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 42424 , F 161, S 8, H B407619, I/A 15 ( 7.01.21).
25 de Noviembre de 2020Revocaciones. APODERAD.SOL: MU脩OZ SANCHEZ MIGUEL. Datos registrales. T 42424 , F 161, S 8, H B 407619, I/A 14(17.11.20).
24 de Marzo de 2020Revocaciones. APODERAD.SOL: LAMARCA CAPA JOSE MARIA;ESCARTIN GUIRAL EVA;GONZALEZ SANCHEZ GONZALO.
25 de Noviembre de 2019Nombramientos. APODERAD.SOL: TORRES PUGES MARTA. Datos registrales. T 42424 , F 160, S 8, H B 407619, I/A 12(18.11.19).
30 de Octubre de 2019Nombramientos. APODERAD.SOL: MU脩OZ SANCHEZ MIGUEL;FRAILE GARCIA VICTOR. Datos registrales. T 42424 , F 160, S8, H B 407619, I/A 11 (23.10.19).
28 de Octubre de 2019Cambio de domicilio social. CL ENERGIA NUM.39-41 PG.IND.FAMADES (CORNELLA DE LLOBREGAT). Datos registrales. T42424 , F 160, S 8, H B 407619, I/A 10 ( 9.10.19).
02 de Noviembre de 2016Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO:GEV GROSSKUCHEN ERSATZTEIL VERTRIEBGMBH. Datos registrales. T 42424 , F 160, S 8, H B 407619, I/A 9 (25.10.16).
27 de Septiembre de 2016Revocaciones. APODERADO: ADMINEX SPAIN SL. Datos registrales. T 42424 , F 159, S 8, H B 407619, I/A 8 (19.09.16).
19 de Enero de 2016Nombramientos. APODERAD.SOL: LAMARCA CAPA JOSE MARIA;ESCARTIN GUIRAL EVA;GONZALEZ SANCHEZ GONZALO.Datos registrales. T 42424 , F 158, S 8, H B 407619, I/A 7 (11.01.16).
04 de Febrero de 2014Cambio de domicilio social. AV BAIX LLOBREGAT Num.77 P.BJ (SANTA COLOMA DE CERVELLO). Datos registrales. T 42424 ,F 158, S 8, H B 407619, I/A 6 (27.01.14).
19 de Agosto de 2013Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: ROMAGOSA QUERALTO JORDI. Nombramientos. ADM.UNICO: ALEXANDER KART FRANZWIEGAND. Datos registrales. T 42424 , F 158, S 8, H B 407619, I/A 5 ( 8.08.13).
12 de Junio de 2013Nombramientos. APODERADO: ROMAGOSA QUERALT JORDI. Datos registrales. T 42424 , F 157, S 8, H B 407619, I/A 4 (5.06.13).
13 de Septiembre de 2012Cambio de domicilio social. AV RIERA ROJA,1,LOCAL 21,EDIFICI CENTRE SERVEIS (SANT BOI DE LLOBREGAT). Datosregistrales. T 42424 , F 157, S 8, H B 407619, I/A 3 ( 3.09.12).
04 de Mayo de 2011Nombramientos. APODERADO: ADMINEX SPAIN SL. Datos registrales. T 42424 , F 156, S 8, H B 407619, I/A 2 (15.04.11).
24 de Marzo de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 21.02.11. Objeto social: EL COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE TODOTIPO DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA DESTINADA A LA HOSTELERIA,RESTAURACION Y ALIMENTACION.Domicilio: AV RIERA ROJA, 1, LOCAL 8 EDIFICI CENTRESERVEIS (SANT BOI DE LLOBREGAT). Capital: 3.100,00 Euros.Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: WIEGAND ALEXANDER KART FRANZ;ROMAGOSA QUERALTO JORDI. Datos registrales. T42424 , F 155, S 8, H B 407619, I/A 1 (14.03.11).