Actos BORME de Gfi Levante Sl
26 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL. Apo.Manc.: PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL;PARGADACAYUELA JOSE MIGUEL;PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL;PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL. Apo.Sol.: PARGADACAYUELA JOSE MIGUEL. Apo.Manc.: PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL;PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL;PARGADACAYUELA JOSE MIGUEL;PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL;PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL. Apo.Sol.: PARGADACAYUELA JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 4400 , F 73, S 8, H A 37226, I/A 47 (18.10.22).
28 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ GIL DAVID JAVIER. Datos registrales. T 4400 , F 73, S 8, H A 37226, I/A 46(20.07.22).
03 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: VASSALLO SAAVEDRA JUAN LUIS;VASSALLO SAAVEDRA JUAN LUIS;VASSALLO SAAVEDRA JUANLUIS;VASSALLO SAAVEDRA JUAN LUIS;VASSALLO SAAVEDRA JUAN LUIS. Apo.Sol.: VASSALLO SAAVEDRA JUAN LUIS.Apo.Manc.: VASSALLO SAAVEDRA JUAN LUIS. Datos registrales. T 4400 , F 73, S 8, H A 37226, I/A 45 (21.04.22).
18 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARROYO CREJO MARIA TELVA. Datos registrales. T 4400 , F 73, S 8, H A 37226, I/A 44 (6.04.22).
07 de Abril de 2022Nombramientos. Apoderado: ALONSO PASCUAL ANGEL MATIAS. Datos registrales. T 4400 , F 72, S 8, H A 37226, I/A 43(30.03.22).
06 de Abril de 2022Nombramientos. Apoderado: ARROYO CREJO MARIA TELVA. Datos registrales. T 4400 , F 71, S 8, H A 37226, I/A 42 (29.03.22).
05 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: GARCIA PE脩ALVER LUCRECIA;GARCIA PE脩ALVER LUCRECIA. Apo.Manc.: GARCIA PE脩ALVERLUCRECIA;GARCIA PE脩ALVER LUCRECIA;GARCIA PE脩ALVER LUCRECIA;GARCIA PE脩ALVER LUCRECIA;GARCIA PE脩ALVERLUCRECIA;GARCIA PE脩ALVER LUCRECIA. Apo.Sol.: GARCIA PE脩ALVER LUCRECIA. Datos registrales. T 4400 , F 71, S 8, H A37226, I/A 41 (28.03.22).
04 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: DE LA FUENTE RODRIGUEZ ADOLFO. Datos registrales. T 4400 , F 71, S 8, H A 37226, I/A 40(27.12.21).
17 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: BALBOA TORIBIO JOSE MARIA. Datos registrales. T 4400 , F 70, S 8, H A 37226, I/A 39 ( 9.12.21).
14 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: ROUAIX VINCENT;MU脩OZ PEREZ CARLOS MARIA;CRESPO ZARAGOZA JUAN CARLOS;MALHERCYRIL;DE LA FUENTE RODRIGUEZ ADOLFO;PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL;DIEUDE AURELIA CATROUX;LUENGOZAMORANO LUIS MIGUEL. Apo.Manc.: ROUAIX VINCENT;MU脩OZ PEREZ CARLOS MARIA;CRESPO ZARAGOZA JUANCARLOS;MALHER CYRIL;DE LA FUENTE RODRIGUEZ ADOLFO;PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL;DIEUDE AURELIACATROUX;LUENGO ZAMORANO LUIS MIGUEL;VASSALLO SAAVEDRA JUAN LUIS;GARCIA PE脩ALVER LUCRECIA;MALHERCYRIL;DE LA FUENTE RODRIGUEZ ADOLFO;PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL;DIEUDE AURELIA CATROUX;LUENGO
20 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: HERRERO FERNANDEZ MONICA. Datos registrales. T 4400 , F 69, S 8, H A 37226, I/A 37(12.08.21).
19 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: GARCIA PE脩ALVER LUCRECIA. Datos registrales. T 4238 , F 57, S 8, H A 37226, I/A 36 (12.08.21).
27 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA SA. Nombramientos. Adm. Unico: INETUMESPA脩A SA. Datos registrales. T 4238 , F 57, S 8, H A 37226, I/A 35 (16.04.21).
26 de Abril de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: INETUM ESPA脩A SA. Datos registrales. T 4238 , F 57, S 8, H A37226, I/A 34 (16.04.21).
28 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: PRIETO MARTIN FELIPE. Datos registrales. T 4238 , F 56, S 8, H A 37226, I/A 33 (20.11.19).
26 de Noviembre de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4238 , F 56, S 8, H A 37226, I/A 32 (18.11.19).
08 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTIN DESIDERIO SYLVIA. Datos registrales. T 4238 , F 56, S 8, H A 37226, I/A 31 (30.09.19).
27 de Agosto de 2019Nombramientos. Apoderado: ECHAZARRA HUGUET JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2860 , F 39, S 8, H A 37226, I/A 30(19.08.19).
12 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2860 , F 39, S 8, H A 37226, I/A 29 ( 3.01.17).
26 de Febrero de 2014Revocaciones. Apoderado: URIARTE MARTINEZ JAVIER. Datos registrales. T 2860 , F 39, S 8, H A 37226, I/A 28 (18.02.14).
24 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: COCA GRADIN JESUS. Datos registrales. T 2860 , F 39, S 8, H A 37226, I/A 27 (13.02.14).
20 de Junio de 2013Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL CAMINO. Datos registrales. T 2860 , F 39, S 8, H A 37226, I/A26 (12.06.13).
19 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: URIARTE MARTINEZ JAVIER. Datos registrales. T 2860 , F 39, S 8, H A 37226, I/A 25 (11.06.13).
22 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL CAMINO. Datos registrales. T 2860 , F 38, S 8, H A 37226, I/A24 (10.03.11).
16 de Febrero de 2011Revocaciones. Apoderado: CRISPIN MEJUTO FELIPE. Datos registrales. T 2860 , F 38, S 8, H A 37226, I/A 23 ( 4.02.11).
18 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apoderado: ALBA LOPEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 2860 , F 38, S 8, H A 37226, I/A 22 ( 8.11.10).
08 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: GARCIA PE脩ALVER LUCRECIA. Datos registrales. T 2860 , F 38, S 8, H A 37226, I/A 21 (26.10.10).
05 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ SERRANO JOAQUIN MANUEL. Datos registrales. T 2860 , F 38, S 8, H A 37226, I/A 20(26.10.10).
25 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: SAENZ COHU JUAN RAIMUNDO;PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL. Presidente: SAENZ COHUJUAN RAIMUNDO. Secretario: PARGADA CAYUELA JOSE MIGUEL. Con.Delegado: SAENZ COHU JUAN RAIMUNDO. Consejero:MU脩OZ PEREZ CARLOS MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA SA.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 2860 , F 38, S 8, H A 37226, I/A 19 (13.02.09).