Buscador CIF Logo

Actos BORME Gibarfred Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gibarfred Sociedad Limitada

Actos BORME Gibarfred Sociedad Limitada - B17515339

Tenemos registrados 11 Actos BORME del Registro Mercantil de Girona para Gibarfred Sociedad Limitada con CIF B17515339

馃敊 Perfil de Gibarfred Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Girona

Actos BORME de Gibarfred Sociedad Limitada

12 de Diciembre de 2023
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: JOSEP MARIA CALDERS PIDEMUNT. Modificaciones estatutarias.Modificado el art铆culo 8潞 de los estatutos sociales relativo a la transmisi贸n de participaciones sociales. Datos registrales. T 1060 , F132, S 8, H GI 19400, I/A 19 ( 1.12.23).

25 de Febrero de 2020
Nombramientos. Cons.Del.Sol: JOSEP PONS FONT;MARC FRIGOLA FERNANDEZ;LAURA CAMPS GAY. Reelecciones.Consejero: JOSEP PONS FONT. Presidente: JOSEP PONS FONT. Consejero: MARC FRIGOLA FERNANDEZ. Secretario: MARCFRIGOLA FERNANDEZ. Consejero: LAURA CAMPS GAY. Vicesecret.: LAURA CAMPS GAY. Datos registrales. T 1060 , F 132, S 8,H GI 19400, I/A 18 (18.02.20).

24 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: JOSEP PONS FONT. Datos registrales. T 1060 , F 132, S 8, H GI 19400, I/A 17 (17.10.17).

24 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE MANUEL FORERO MATEO. Vicepresid.: JOSE MANUEL FORERO MATEO. Datosregistrales. T 1060 , F 131, S 8, H GI 19400, I/A 14 (20.02.17).

Revocaciones. Apo.Sol.: JOSE MANUEL FORERO MATEO. Datos registrales. T 1060 , F 131, S 8, H GI 19400, I/A 15 (20.02.17).

Nombramientos. Apoderado: LAURA CAMPS GAY. Datos registrales. T 1060 , F 131, S 8, H GI 19400, I/A 16 (20.02.17).

06 de Noviembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN GIMENEZ ALVARO;FRANCISCO RIVAS FERNANDEZ;JOSEP FRIGOLA FONT;LLORENCCAMPS FREIXAS;JOAN VILAVEDRA RIQUE. Presidente: JOSE MANUEL FORERO MATEO. Secretario: JOSEP PONS FONT.Vicesecret.: MARC FRIGOLA FERNANDEZ. Nombramientos. Presidente: JOSEP PONS FONT. Vicepresid.: JOSE MANUELFORERO MATEO. Secretario: MARC FRIGOLA FERNANDEZ. Vicesecret.: LAURA CAMPS GAY. Datos registrales. T 1060 , F 131,S 8, H GI 19400, I/A 13 (31.10.14).

13 de Agosto de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 792,30 Euros. Resultante Suscrito: 113.400,00 Euros. Datos registrales. T 1060 , F 130,S 8, H GI 19400, I/A 12 ( 2.08.12).

19 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: JOSEP FRIGOLA FONT. Vicesecret.: JOSEP PONS FONT. Secretario: JOSE MANUEL FOREROMATEO. Revocaciones. Apo.Sol.: LLORENC CAMPS FREIXAS;JOSEP FRIGOLA FONT. Nombramientos. Presidente: JOSEMANUEL FORERO MATEO. Secretario: JOSEP PONS FONT. Vicesecret.: MARC FRIGOLA FERNANDEZ. Datos registrales. T1060 , F 130, S 8, H GI 19400, I/A 10 ( 8.04.11).

Nombramientos. Apoderado: MARC FRIGOLA FERNANDEZ. Datos registrales. T 1060 , F 130, S 8, H GI 19400, I/A 11 ( 8.04.11).

07 de Diciembre de 2009
Reelecciones. Presidente: JOSEP FRIGOLA FONT. Vicepresid.: LLORENC CAMPS FREIXAS. Vicesecret.: JOSEP PONS FONT.Consejero: JUAN GIMENEZ ALVARO;LAURA CAMPS GAY;FRANCISCO RIVAS FERNANDEZ;MARC FRIGOLA FERNANDEZ.Secretario: JOSE MANUEL FORERO MATEO. Consejero: JOAN VILAVEDRA RIQUE. Otros conceptos: Actualizaci贸n del domiciliosocial por adquisici贸n de nomenclatura, pasando a ser el mismo en RIUDELLOTS DE LA SELVA, Pol铆gono Industrial, calle Onyar,n煤mero 98. Cambio de domicilio social. C/ 0NYAR 98 (RIUDELLOTS DE LA SELVA). Datos registrales. T 1060 , F 129, S 8, H GI19400, I/A 9 (26.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n