Buscador CIF Logo

Actos BORME Giez Berri Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Giez Berri Sl

Actos BORME Giez Berri Sl - B20613725

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Guipuzcoa para Giez Berri Sl con CIF B20613725

馃敊 Perfil de Giez Berri Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Guipuzcoa

Actos BORME de Giez Berri Sl

02 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Consejero: GARCIA LLARENA ALFREDO;LIZARRALDE DEL VALLE FERNANDO;OSTOLAZA ANSOLA JOSEANTONIO;ARREGI LANDA IGNACIO JAVIER;GANUZA LEZAUN JAVIER. Secretario: OSTOLAZA ANSOLA JOSE ANTONIO.Vicesecret.: GANUZA LEZAUN JAVIER. Presidente: GARCIA LLARENA ALFREDO. Vicepresid.: LIZARRALDE DEL VALLEFERNANDO. Datos registrales. T 1678 , F 104, S 8, H SS 13822, I/A 14 (26.11.21).

Ceses/Dimisiones. Gerente: ARBULU BERGERA ANDER. Nombramientos. Apoderado: SENDON ARZAMENDI AITOR. Gerente:SENDON ARZAMENDI AITOR. Datos registrales. T 1678 , F 104, S 8, H SS 13822, I/A 15 (26.11.21).

21 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Gerente: ARBULU BERGERA ANDER. Datos registrales. T 1678 , F 103, S 8, H SS 13822, I/A 13 (13.12.18).

24 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Consejero: GARCIA LLARENA ALFREDO;LIZARRALDE DEL VALLE FERNANDO;OSTOLAZA ANSOLA JOSEANTONIO;GANUZA LEZAUN JAVIER;ARREGI LANDA IGNACIO JAVIER. Presidente: GARCIA LLARENA ALFREDO. Vicepresid.:LIZARRALDE DEL VALLE FERNANDO. Secretario: OSTOLAZA ANSOLA JOSE ANTONIO. Vicesecret.: GANUZA LEZAUN JAVIER.Datos registrales. T 1678 , F 103, S 8, H SS 13822, I/A 12 (13.11.17).

08 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Gerente: IJURCO SALVADOR JUAN RAMON. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA LLARENAALFREDO;EGA脩A ARRUTI MARIA ANGELES. Datos registrales. T 1678 , F 103, S 8, H SS 13822, I/A 11 (30.12.14).

01 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: SERRANO FERNANDEZ ROBERTO;GARCIA LLARENA ALFREDO. Secretario: GARCIA LLARENAALFREDO. Consejero: LIZARRALDE DEL VALLE FERNANDO. Vicesecret.: LIZARRALDE DEL VALLE FERNANDO. Consejero:GANUZA LEZAUN JAVIER. Vicepresid.: GANUZA LEZAUN JAVIER. Consejero: OSTOLAZA ANSOLA JOSE ANTONIO. Presidente:OSTOLAZA ANSOLA JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: GARCIA LLARENA ALFREDO. Presidente: GARCIA LLARENAALFREDO. Consejero: LIZARRALDE DEL VALLE FERNANDO;OSTOLAZA ANSOLA JOSE ANTONIO. Vicepresid.: LIZARRALDE DELVALLE FERNANDO. Secretario: OSTOLAZA ANSOLA JOSE ANTONIO. Consejero: GANUZA LEZAUN JAVIER. Vicesecret.: GANUZALEZAUN JAVIER. Consejero: ARREGI LANDA IGNACIO JAVIER. Otros conceptos: Modificaci贸n del Apartado 1) del Art铆culo 14潞 delos Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de la Junta General, y adicion del Apartado k) en el Art铆culo 23潞 de los mismos,relativoa los derechos de los socios.- Datos registrales. T 1678 , F 102, S 8, H SS 13822, I/A 10 (23.07.12).

25 de Abril de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.096,80 Euros. Resultante Suscrito: 334.636,80 Euros. Datos registrales. T 1678 , F 102, S 8, HSS 13822, I/A 9 (13.04.11).

03 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Gerente: AIZPURUA AGIRRE MARTXELIN. Nombramientos. Gerente: IJURCO SALVADOR JUAN RAMON.Datos registrales. T 1678 , F 101, S 8, H SS 13822, I/A 8 (22.02.10).

14 de Septiembre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 135.585,60 Euros. Resultante Suscrito: 321.655,20 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.884,80Euros. Resultante Suscrito: 324.540,00 Euros. Datos registrales. T 1678 , F 100, S 8, H SS 13822, I/A 7 ( 4.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n