Actos BORME de Gifies Sl
17 de Julio de 2023Cambio de domicilio social. CR DE L'HOSPITALET,147,CITY PARK,EDIF.LONDRES,P3 (CORNELLA DE LLOBREGAT). Datosregistrales. T 48773 , F 134, S 8, H B 279281, I/A 18 ( 9.07.23).
21 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. CL DIPUTACIO Num.260 P.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 36162 , F 29, S 8, H B 279281, I/A12 (10.11.17).
14 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: MARIA BOREN TERAN;ALEJANDRA DE AGUSTIN VALDES;FRANCESC CABOT SETO. Datosregistrales. T 2691 , F 51, S 8, H GI 47158, I/A 11 ( 7.08.17).
15 de Febrero de 2017Revocaciones. Apoderado: JEAN PIERRE FRANCONIE. Apo.Sol.: FRANCESC MARTI QUERALT;JUDITH ROQUE ESCUDE.Nombramientos. Apo.Manc.: FRANK ALLARD;PIERRE EMMANUEL LUDOVIC BALLARD. Apo.Sol.: FRANK ALLARD;PIERREEMMANUEL LUDOVIC BALLARD. Datos registrales. T 2691 , F 50, S 8, H GI 47158, I/A 10 ( 9.02.17).
23 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: JEAN PIERRE FRANCONIE. Nombramientos. Adm. Unico: THIERRY BOUKHARI. Datosregistrales. T 2691 , F 50, S 8, H GI 47158, I/A 9 (15.12.14).
07 de Abril de 2014Cambio de domicilio social. C/ EMPORDA 78 (FIGUERES). Datos registrales. T 2691 , F 50, S 8, H GI 47158, I/A 8 (31.03.14).
26 de Enero de 2012Nombramientos. APODERADO: PATRICIA CHANTAL RABOT. Datos registrales. T 36162 , F 26, S 8, H B 279281, I/A 7(16.01.12).
01 de Julio de 2011Cambio de domicilio social. CL COLOM 476,POLIGONO DE SANTA MARGARITA (TERRASSA). Datos registrales. T 36162 , F26, S 8, H B 279281, I/A 6 (21.06.11).