Actos BORME de Gisco Sl
31 de Julio de 2020Revocaciones. APODERADO: ASENJO MIGUEL JOSE LUIS. ADM.SOLIDAR.: ASENJO GOMEZ JORDI;ASENJO MIGUEL JOSELUIS. Nombramientos. ADM.UNICO: ASENJO GOMEZ JORDI. Datos registrales. T 22526 , F 13, S 8, H B 38459, I/A 14(23.07.20).
29 de Julio de 2020Fe de erratas: En el BORME no.59/2014 y con referencia 135212 SE RECTIFICA EN CUANTO AL SEGUNDO APELLIDO DELADMINISTRADOR SOLIDARIO JOSE LUIS ASENJO, DONDE SE LEE "GOMEZ" DEBE LEERSE "MIGUEL". Datos registrales. T22526 , F 11, S 8, H B 38459, I/A 12 (17.03.14).
26 de Mayo de 2014Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 22526 ,F 12, S 8, H B 38459, I/A 13 (19.05.14).
26 de Marzo de 2014Revocaciones. ADM.UNICO: ASENJO MIGUEL JOSE LUIS. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: ASENJO GOMEZ JORDI;ASENJOGOMEZ JOSE LUIS. Modificaciones estatutarias. ART.12: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACIONSOCIAL. Datos registrales. T 22526 , F 11, S 8, H B 38459, I/A 12 (17.03.14).
12 de Julio de 2013Revocaciones. ADMINISTR.: GOMEZ PARENTE ESTHER. Nombramientos. ADM.UNICO: ASENJO MIGUEL JOSE LUIS.Ampliaci贸n de capital. Capital: 570.961,59 Euros. Resultante Suscrito: 601.012,20 Euros. Datos registrales. T 22526 , F 11, S 8, HB 38459, I/A 11 ( 4.07.13).