Actos BORME de Giverola Gestion Sl
22 de Septiembre de 2022Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3338 , F 52, S 8, H GI 44127, I/A 30 (14.09.22).
15 de Febrero de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUSTI CODINA NEGRE;DAVID MALDONADO GUTIERREZ. Apo.Manc.: AGUSTI BOSCH ILLA.Datos registrales. T 3338 , F 51, S 8, H GI 44127, I/A 28 ( 8.02.22).
Nombramientos. Apoderado: LIDIA ALDEGUER COROMINAS. Datos registrales. T 3338 , F 51, S 8, H GI 44127, I/A 29 ( 8.02.22).
17 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: MED PLAYA MANAGEMENT SL. Datos registrales. T 3338 , F 48, S 8, H GI 44127, I/A 25 (11.11.21).
Nombramientos. Apoderado: PERE TUBAU FORTEA. Datos registrales. T 3338 , F 49, S 8, H GI 44127, I/A 26 (11.11.21).
Nombramientos. Apoderado: SMART HOPER SL. Datos registrales. T 3338 , F 49, S 8, H GI 44127, I/A 27 (11.11.21).
12 de Agosto de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: LUIS FRANCISCO MARIMON GARNIER;ANTONIO MARIMON PRATS;LUIS FRANCISCO MARIMONPRATS;ESTHER NAVAS TRAVER. Apo.Man.Soli: PATRICK FLUCKIGER;MARTA FABREGAS PAGES. Apo.Manc.: ANTONIO JUANMORENO DURAN. Apo.Sol.: MARTA FABREGAS PAGES. Datos registrales. T 3338 , F 47, S 8, H GI 44127, I/A 23 ( 6.08.21).
10 de Agosto de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: AZORA EUROPEAN HOTEL LODGING FCR. Ceses/Dimisiones.SecreNoConsj: ANTONIO MARIMON PRATS. Consejero: ANNE CHESEAUX;EVA BEATRIZ MONTE HEVIA. Presidente: ANNECHESEAUX. Consejero: DARINE FARES YAMMINE. Nombramientos. Adm. Unico: AZORA CAPITAL SL. Modificacionesestatutarias. Refundici贸n del texto 铆ntegro de los estatutos sociales. . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 2736 , F 114, S 8, H GI 44127, I/A 22 ( 4.08.21).
13 de Mayo de 2021Modificaciones estatutarias. 20, de la gratuidad del cargo de Administrador.. Datos registrales. T 2736 , F 113, S 8, H GI 44127,I/A 19 ( 6.05.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: MAR GONZALEZ DIEZ. Datos registrales. T 2736 , F 113, S 8, H GI 44127, I/A 20 ( 6.05.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: MAR GONZALEZ DIEZ. Datos registrales. T 2736 , F 113, S 8, H GI 44127, I/A 21 ( 6.05.21).
01 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MARKUS LEO KRAUS. Datos registrales. T 2736 , F 113, S 8, H GI 44127, I/A 17 (22.02.21).
Nombramientos. Consejero: DARINE FARES YAMMINE. Datos registrales. T 2736 , F 113, S 8, H GI 44127, I/A 18 (22.02.21).
04 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: NICOLAS ROGER RIEDO. Presidente: NICOLAS ROGER RIEDO. Consejero: JOHANNA MARIERUSCA. Nombramientos. Consejero: MARKUS LEO KRAUS;EVA BEATRIZ MONTE HEVIA. Presidente: ANNE CHESEAUX. Datosregistrales. T 2736 , F 112, S 8, H GI 44127, I/A 16 (27.11.19).
14 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMAN CHRISTIAN HOFER. Nombramientos. Consejero: ANNE CHESEAUX. Datos registrales.
10 de Abril de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CONO SARL. Ceses/Dimisiones. Consejero: FELIX HERMANNRUTSCHMANN. Presidente: FELIX HERMANN RUTSCHMANN. Consejero: HUGO GERBER. Nombramientos. Consejero:NICOLAS ROGER RIEDO. Presidente: NICOLAS ROGER RIEDO. Consejero: JOHANNA MARIE RUSCA. Datos registrales. T 2736, F 112, S 8, H GI 44127, I/A 14 ( 3.04.18).
16 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MICHAEL LUTHI. Nombramientos. Consejero: ROMAN CHRISTIAN HOFER. Datos registrales. T2736 , F 111, S 8, H GI 44127, I/A 12 ( 8.11.16).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ANDRE DANIEL BAUMANN. Apoderado: ROMAN CHRISTIAN HOFER. Nombramientos. Apo.Sol.:MARTA FABREGAS PAGES. Datos registrales. T 2736 , F 112, S 8, H GI 44127, I/A 13 ( 8.11.16).
10 de Junio de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: GREGOR ALEXANDER WALTHERT. Nombramientos. Apoderado: ROMAN CHRISTIAN HOFER.Datos registrales. T 2736 , F 111, S 8, H GI 44127, I/A 11 ( 2.06.16).
24 de Julio de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: WERNER BILL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GREGOR ALEXANDER WALTHERT. Datos
24 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ESTHER SCHAWALDER BRIGUET. Nombramientos. Consejero: HUGO GERBER. Datosregistrales. T 2736 , F 110, S 8, H GI 44127, I/A 9 (17.06.15).
18 de Febrero de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: WERNER BILL;ANDRE DANIEL BAUMANN. Datos registrales. T 2736 , F 109, S 8, H GI 44127,I/A 8 (10.02.14).
07 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: KEVIN PATRICK KUNZ. Nombramientos. Consejero: MICHAEL LUTHI. Datos registrales. T 2736, F 109, S 8, H GI 44127, I/A 7 (28.02.13).
16 de Noviembre de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: MARTA FABREGAS PAGES;JUAN NARCISO ROBERT. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PATRICKFLUCKIGER;MARTA FABREGAS PAGES. Apo.Manc.: ANTONIO JUAN MORENO DURAN. Datos registrales. T 2590 , F 161, S 8,H GI 44127, I/A 6 ( 4.11.09).