Actos BORME de Glassdv Tierra Del Duero Sl
31 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ HERNANDEZ ANA. Nombramientos. Liquidador: SANCHEZ HERNANDEZ ANA.Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 477 , F 113, S 8, H SA 16620, I/A 5 (17.01.19).
29 de Marzo de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SANCHEZ HERNANDEZ ANA. Datos registrales. T 477 , F 113, S8, H SA 16620, I/A 3 (24.02.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PALA CASTELLA GABRIEL;GARCIA SANZ RICARDO. Datos registrales. T 477 , F 113, S 8, H SA16620, I/A 4 (24.02.17).
06 de Marzo de 2017Cambio de domicilio social. C/ ABAJO 18 2潞 D (SALAMANCA). Datos registrales. T 477 , F 113, S 8, H SA 16620, I/A 2 (23.02.17).
30 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: SURET NICOLAS;FERREIRA NUNES LICINIO GILBERTO;SCOTTI GIANNI. Con.Delegado: SCOTTIGIANNI. Presidente: SCOTTI GIANNI. Secretario: PALA CASTELLA GABRIEL. Nombramientos. Adm. Unico: SANCHEZHERNANDEZ ANA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 32300 , F 105, S 8, H M 581395, I/A 10 (23.01.17).
07 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DE RAMON GARCIA RICARDO. Presidente: DE RAMON GARCIA RICARDO. Con.Delegado: DERAMON GARCIA RICARDO. Nombramientos. Consejero: SCOTTI GIANNI. Con.Delegado: SCOTTI GIANNI. Presidente: SCOTTIGIANNI. Cambio de domicilio social. C/ INDUSTRIAS 4 - PLANTA 00, PUERTA 12 (ALCORCON). Datos registrales. T 32300 , F105, S 8, H M 581395, I/A 9 (26.02.16).
27 de Noviembre de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LUNARED GLASSDRIVE SL. Datos registrales. T 32300 , F 101, S 8, H M 581395,I/A 5 (19.11.15).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AMBIT LEMUS RAUL. Nombramientos. Consejero: DE RAMON GARCIA RICARDO;SURETNICOLAS;FERREIRA NUNES LICINIO GILBERTO. Presidente: DE RAMON GARCIA RICARDO. Con.Delegado: DE RAMON GARCIARICARDO. Secretario: PALA CASTELLA GABRIEL. Datos registrales. T 32300 , F 101, S 8, H M 581395, I/A 6 (19.11.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PALA CASTELLA GABRIEL. Datos registrales. T 32300 , F 101, S 8, H M 581395, I/A 7 (19.11.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA SANZ RICARDO. Datos registrales. T 32300 , F 103, S 8, H M 581395, I/A 8 (19.11.15).
22 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ CASTRILLON MARIA ISABEL. Datos registrales. T 32300 , F 100, S 8, H M 581395, I/A 4(14.09.15).
29 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ ARMARIO RUBEN;FERNANDEZ ARMARIO ANTONIO JOSE;GIL CALVO MARIACONCEPCION. Presidente: FERNANDEZ ARMARIO RUBEN. Secretario: GIL CALVO MARIA CONCEPCION. Nombramientos.Adm. Unico: AMBIT LEMUS RAUL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 32300 , F 100, S 8, H M 581395, I/A 2 (18.06.15).
Revocaciones. Apo.Sol.: GIL CALVO MARIA CONCEPCION;AMBIT LEMUS RAUL;FERNANDEZ ARMARIO ANTONIOJOSE;FERNANDEZ ARMARIO RUBEN. Datos registrales. T 32300 , F 100, S 8, H M 581395, I/A 3 (18.06.15).
27 de Mayo de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 23.04.14. Objeto social: La realizaci贸n de todo tipo de operaciones relacionadas con elSector de los veh铆culos autom贸viles: la compra, venta, intermediaci贸n, tanto como comitente, como comisionista, de veh铆culosautom贸viles en general y de todos aquellos repuestos y accesorios relacionados con el sector... Domicilio: C/ PROLONGACION DEEMBAJADORES S/N (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ ARMARIORUBEN;FERNANDEZ ARMARIO ANTONIO JOSE;GIL CALVO MARIA CONCEPCION. Presidente: FERNANDEZ ARMARIO RUBEN.Secretario: GIL CALVO MARIA CONCEPCION. Apo.Sol.: GIL CALVO MARIA CONCEPCION;AMBIT LEMUS RAUL;FERNANDEZARMARIO ANTONIO JOSE;FERNANDEZ ARMARIO RUBEN. Datos registrales. T 32300 , F 98, S 8, H M 581395, I/A 1 (20.05.14).