Buscador CIF Logo

Actos BORME Global Borealis Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Global Borealis Sl

Actos BORME Global Borealis Sl - B87139119

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Global Borealis Sl con CIF B87139119

馃敊 Perfil de Global Borealis Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Global Borealis Sl

01 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33146 , F 12, S 8, H M 591044, I/A 22 (24.11.22).

15 de Junio de 2022
Ampliaci贸n de capital. Capital: 580.330,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.143.795,00 Euros. Datos registrales. T 33146 , F 10, S 8,H M 591044, I/A 21 ( 8.06.22).

19 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: DE LA LASTRA GOMEZ-BAEZA JOSE-ANTONIO. Nombramientos. Representan: SANCHEZMIER OVIDIO. Datos registrales. T 33146 , F 10, S 8, H M 591044, I/A 20 ( 8.04.22).

09 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Secretario: RODRIGUEZ ESCUDERO VAZQUEZ ALMUDENA. VsecrNoConsj: GOLLONET BAUTISTA JOSEANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: LOPEZ OLMOS DAVID. VsecrNoConsj: MARTINEZ GARCIA AITOR. Datosregistrales. T 33146 , F 9, S 8, H M 591044, I/A 19 ( 2.03.22).

18 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: DIF INFRA 3 ESP BV. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 18陋 el cese comoVicesecretario de DIF INFRA 3 ESP BV. Datos registrales. T 33146 , F 8, S 8, H M 591044, I/A 18 (31.07.20).

07 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIF MANAGEMENT FRANCE SARL;DIF INFRA 3 ESP BV;DIF MANAGEMENT SPAIN SL.Presidente: DIF MANAGEMENT SPAIN SL. Cons.Del.Man: DIF MANAGEMENT SPAIN SL. Representan: MICHELSTEENBERGEN;BARRUECO GONZALEZ RAUL;MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO. Vicesecret.: DIF INFRA 3 ESP BV.Cons.Del.Man: DIF MANAGEMENT FRANCE SARL. Nombramientos. Consejero: MONTESI GABRIELE;ZAMARRIEGOFERNANDEZ ALFREDO;ORTIZ FELIPE. Presidente: ZAMARRIEGO FERNANDEZ ALFREDO. Cons.Del.Man: MONTESIGABRIELE;ZAMARRIEGO FERNANDEZ ALFREDO. VsecrNoConsj: GOLLONET BAUTISTA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T33146 , F 8, S 8, H M 591044, I/A 18 (31.07.20).

21 de Enero de 2020
Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33146 , F 8, S 8, HM 591044, I/A 17 (14.01.20).

22 de Agosto de 2018
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33146 , F 8, S 8, H M 591044, I/A 16 (14.08.18).

21 de Marzo de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: GRANDE ROYO-VILANOVA EMILIO. Nombramientos. Representan: DE LA LASTRA GOMEZ-BAEZA JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 33146 , F 8, S 8, H M 591044, I/A 15 (13.03.18).

04 de Agosto de 2017
Nombramientos. Cons.Del.Man: DIF MANAGEMENT FRANCE SARL;DIF MANAGEMENT SPAIN SL;IRIDIUM CONCESIONES DEINFRAESTRUCTURAS SA;DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIAS UNO SL. Datos registrales. T 33146 , F 7, S 8, H M591044, I/A 14 (28.07.17).

02 de Diciembre de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.069.370,00 Euros. Resultante Suscrito: 18.563.465,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: SERVICIOS TRANSPORTES Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS SL. Datos registrales. T 33146 , F 3, S 8, H M 591044,I/A 13 (22.11.16).

26 de Abril de 2016
Modificaciones estatutarias. CREACION DE UN DIVIDENDO PREFERENTE Y MODIFICACION DEL ARTICULO 5潞 DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 33146 , F 2, S 8, H M 591044, I/A 12 (19.04.16).

14 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA SALVADOR SANTIAGO. Nombramientos. Representan: GRANDE ROYO-VILANOVAEMILIO. Datos registrales. T 33146 , F 2, S 8, H M 591044, I/A 11 ( 3.12.15).

03 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Consejero: DIF MANAGEMENT FRANCE SARL. Datos registrales. T 33146 , F 2, S 8, H M 591044, I/A 9(22.10.15).

Nombramientos. Representan: BARRUECO GONZALEZ RAUL. Datos registrales. T 33146 , F 2, S 8, H M 591044, I/A 10(22.10.15).

24 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRUECO GONZALEZ RAUL;BENHAMOU STHEPANIE;KREMER MARKO. Presidente: KREMERMARKO. Vicesecret.: BARRUECO GONZALEZ RAUL. Nombramientos. Consejero: DIF MANAGEMENT SPAIN SL. Presidente: DIFMANAGEMENT SPAIN SL. Consejero: DIF INFRA 3 ESP BV. Vicesecret.: DIF INFRA 3 ESP BV. Datos registrales. T 33146 , F 1, S8, H M 591044, I/A 6 (16.06.15).

Nombramientos. Representan: MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO. Datos registrales. T 33146 , F 1, S 8, H M 591044, I/A 7(16.06.15).

Nombramientos. Representan: MICHEL STEENBERGEN. Datos registrales. T 33146 , F 1, S 8, H M 591044, I/A 8 (16.06.15).

06 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: SANTAMARIA CASES JUAN. Adm. Unico: IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURASSA. Nombramientos. Representan: CANCIO DIAZ EDGAR;GARCIA SALVADOR SANTIAGO. Secretario: RODRIGUEZ ESCUDEROVAZQUEZ ALMUDENA. Consejero: DESARROLLO DE CONCESIONES VIARIAS UNO SL;IRIDIUM CONCESIONES DEINFRAESTRUCTURAS SA;BARRUECO GONZALEZ RAUL;BENHAMOU STHEPANIE;KREMER MARKO. Presidente: KREMERMARKO. Vicepresid.: IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA. Vicesecret.: BARRUECO GONZALEZ RAUL.Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 32835 , F 135, S 8, H M 591044,I/A 4 (25.02.15).

Nombramientos. Apoderado: ARTILES HERRERA LIVIA MARINA. Datos registrales. T 32835 , F 141, S 8, H M 591044, I/A 5(26.02.15).

09 de Enero de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 12.490.495,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.494.095,00 Euros. Datos registrales. T 32835 , F 133,S 8, H M 591044, I/A 3 (29.12.14).

05 de Enero de 2015
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANTIAGO PEREZ ANTONIO. Nombramientos. Adm.Unico: IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA. Representan: SANTAMARIA CASES JUAN. Cambio de domiciliosocial. AVDA DEL CAMINO DE SANTIAGO 50 (MADRID). Cambio de objeto social. LA TENENCIA DE PARTICIPACIONES ENENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, CUYO OBJETO SOCIAL SEA LA GESTION . EXPLOTACION, OPERACION ,CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS.- Datos registrales. T 32835 , F 132, S 8, HM 591044, I/A 2 (24.12.14).

01 de Diciembre de 2014
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 13.11.14. Objeto social: La adquisici贸n, administraci贸n y gesti贸n de patrimonio mobiliario,cartera de valores e inversiones, todo ello por cuenta propia. Este objeto social no podr谩 ser desarrollado cuando incida en lalegislaci贸n de inversiones colectivas. Domicilio: C/ PRADILLO 5 - BAJO EXTERIOR DERECHA (MADRID). Capital: 3.600,00 Euros.Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL. Nombramientos. Adm. Unico:SANTIAGO PEREZ ANTONIO. Datos registrales. T 32835 , F 131, S 8, H M 591044, I/A 1 (21.11.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n