Buscador CIF Logo

Actos BORME Global Merchandising Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Global Merchandising Sl

Actos BORME Global Merchandising Sl - B86345212

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Global Merchandising Sl con CIF B86345212

馃敊 Perfil de Global Merchandising Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Global Merchandising Sl

31 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ALONSO DREGI RAFAEL. VsecrNoConsj: CA脩ADAS BOUWEN ANTONIO. Consejero: POCINOYEAMANS CAREN;MACK F DOUGLAS;DAVIS STEVE CHAD. Presidente: POCINO YEAMANS CAREN. Consejero: CHANDLEEMICHENER BELL. Revocaciones. Apoderado: WEIMANN GOMEZ MONICA;SANCHEZ WEICKGENANNT CRISTINA;SCHAARORIVE SAMARA. Apo.Sol.: MURPHY RIA. Nombramientos. Liquidador: CHANDLEE MICHENER BELL. Disoluci贸n. Voluntaria.Extinci贸n. Datos registrales. T 29402 , F 122, S 8, H M 529206, I/A 18 (24.01.23).

25 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: QUIRANTES MARTINEZ DE TEJADA ANA-MARIA;MANUEL GARZON MATEOS. Datos registrales. T29402 , F 122, S 8, H M 529206, I/A 17 (18.11.21).

21 de Junio de 2021
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 29402 , F 122, S 8, H M 529206, I/A 16 (14.06.21).

12 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: COOKS LEVITAN LAUREN. Nombramientos. Consejero: CHANDLEE MICHENER BELL. Datosregistrales. T 29402 , F 120, S 8, H M 529206, I/A 13 ( 5.06.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BERISTAIN BORRA IGNACIO. Con.Delegado: BERISTAIN BORRA IGNACIO. Datos registrales. T29402 , F 120, S 8, H M 529206, I/A 14 ( 5.06.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: MURPHY RIA. Datos registrales. T 29402 , F 120, S 8, H M 529206, I/A 15 ( 5.06.20).

21 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 29402 , F 120, S 8, H M 529206, I/A 12 (14.11.19).

14 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apoderado: QUIRANTES MARTINEZ DE TEJADA ANA-MARIA;MANUEL GARZON MATEOS. Datos registrales.T 29402 , F 119, S 8, H M 529206, I/A 11 ( 8.05.19).

13 de Mayo de 2019
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: FANATICS RETAIL SPAIN SL. Ceses/Dimisiones. Consejero:MAYER CLAUS PETER;JENSEN JENS NICOLAAS MARTIJN JACOBSEN;BUETTNER TORSTEN. Presidente: MAYER CLAUSPETER. Con.Delegado: MAYER CLAUS PETER. Secretario: GARZON MATEOS MANUEL. Revocaciones. Apo.Manc.: QUIRANTESMARTINEZ DE TEJADA ANA-MARIA;GARZON MATEOS MANUEL;BERISTAIN BORRA IGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj:ALONSO DREGI RAFAEL. Consejero: POCINO YEAMANS CAREN;MACK F DOUGLAS;COOKS LEVITAN LAUREN;DAVIS STEVECHAD;BERISTAIN BORRA IGNACIO. Presidente: POCINO YEAMANS CAREN. Con.Delegado: BERISTAIN BORRA IGNACIO.VsecrNoConsj: CA脩ADAS BOUWEN ANTONIO. Apoderado: WEIMANN GOMEZ MONICA;SANCHEZ WEICKGENANNTCRISTINA;SCHAAR ORIVE SAMARA. Datos registrales. T 29402 , F 117, S 8, H M 529206, I/A 10 ( 6.05.19).

17 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Con.Delegado: MAYER CLAUS PETER. Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Modificacionesestatutarias. Modificado el art铆culo 13 de los estatutos.. Datos registrales. T 29402 , F 117, S 8, H M 529206, I/A 9 (10.12.18).

16 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BERISTAIN BORRA IGNACIO. Nombramientos. Secretario: GARZON MATEOS MANUEL.Consejero: MAYER CLAUS PETER;JENSEN JENS NICOLAAS MARTIJN JACOBSEN;BUETTNER TORSTEN. Presidente: MAYERCLAUS PETER. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 29402 , F 116, S 8, H M 529206, I/A 8 ( 7.11.18).

27 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 29402 , F 116, S 8, H M 529206, I/A 7 (17.11.17).

11 de Abril de 2016
Modificaciones estatutarias. 13. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 29402 , F 116, S 8, H M 529206, I/A 6 (4.04.16).

21 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: ZEITLER ELVIRA. Datos registrales. T 29402 , F 115, S 8, H M 529206, I/A 5 (14.03.16).

02 de Marzo de 2015
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 29402 , F 115, S 8, H M 529206, I/A 4 (20.02.15).

13 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: QUIRANTES MARTINEZ DE TEJADA ANA-MARIA;GARZON MATEOS MANUEL;ZEITLERELVIRA;BERISTAIN BORRA IGNACIO. Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 95 3& (MADRID). Datosregistrales. T 29402 , F 114, S 8, H M 529206, I/A 3 (29.10.12).

04 de Mayo de 2012
Cambio de domicilio social. C/ PROFESOR WAKSMAN, 5, 10 D. (MADRID). Datos registrales. T 29402 , F 114, S 8, H M 529206,I/A 2 (20.04.12).

26 de Diciembre de 2011
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 18.11.11. Objeto social: FABRICACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DEPRENDAS DE VESTIR, ARTICULOS DEPORTIVOS, DECORATIVOS Y DE REGALO. GESTION Y EXPLOTACION DE DERECHOSDE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LOS MISMOS, INCLUYENDO EL OTORGAMIENTO DELICENCIAS. ETC. Domicilio: C/ CONCHA ESPINA, 1, ESTADIO SANTIAGO BERNABEU, PU (MADRID). Capital: 3.100,00 Euros.Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ADIDAS INTERNATIONAL BV. Nombramientos. Adm. Unico: BERISTAIN BORRAIGNACIO. Datos registrales. T 29402 , F 113, S 8, H M 529206, I/A 1 (15.12.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n