Actos BORME de Global Rosetta Sl
06 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: VILASECA GRAU JOAN;GARCIA MARTIN LAURA;DE PRADO LOPEZ YOLANDA. Datos registrales. T35119 , F 210, S 8, H M 569517, I/A 52 (29.10.23).
27 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLANCO ROMANILLOS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 35119 , F 208, S 8, H M569517, I/A 51 (22.10.23).
30 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 35119 , F 208, S 8, H M 569517, I/A 50 (23.01.23).
11 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ ZAMORA AINARA;RUIZ POZA JOSEP ORIOL;GOMEZ ZAMORA AINARA. Apoderado:GOMEZ ZAMORA AINARA. Datos registrales. T 35119 , F 207, S 8, H M 569517, I/A 49 ( 4.10.22).
04 de Abril de 2022Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 35119 , F 207, S 8, H M 569517, I/A 48 (28.03.22).
25 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: TERCERO BRAO EMILIO. Datos registrales. T 35119 , F 207, S 8, H M 569517, I/A 47 (18.02.22).
29 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: BADIA LIBERAL IGNACIO;GARCIA MARTIN LAURA;VILASECA GRAU JOAN;GOMEZ ZAMORAAINARA;RICO MORA ANA MARIA;LOPEZ GARCIA ANA MARIA;GARCIA ORTIZ ESTIBALIZ;GARCIA RUIZ ANTONIO;ALVAREZFERNANDEZ BEGO脩A;MANTILLA GUTIERREZ DAVID;TERCERO BRAO EMILIO;RODRIGUEZ LIZUNDIA I脩IGOROBERTO;MARCER GONZALEZ JOAN;ROMERO PEDROCHE ANTONIO JOSE;GARCIA MORGADO ANA ISABEL;PAGOLA VALANA MARIA. Datos registrales. T 35119 , F 200, S 8, H M 569517, I/A 46 (22.06.21).
18 de Mayo de 2021Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 35119 , F 199, S 8, H M 569517, I/A 45 (11.05.21).
27 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: RECTON DIDIER ERIC;SAEZ BARRIO FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: REBOTO ESCRIBANOFRANCISCO JAVIER;MARTIN JIMENEZ FERNANDO. Apo.Man.Soli: LATOVA MU脩OZ JOAQUIN;SAEZ BARRIO FRANCISCOJOSE;ESTEBAN MARTINEZ PABLO;RECTON DIDIER ERIC;LATOVA MU脩OZ JOAQUIN;RUIZ POZA JOSEP ORIOL. Apo.Sol.:MARTIN JIMENEZ FERNANDO. Datos registrales. T 35119 , F 199, S 8, H M 569517, I/A 44 (20.04.21).
15 de Enero de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.001,00 Euros. Datos registrales. T 35119 , F 198, S 8, H M569517, I/A 43 ( 8.01.21).
26 de Noviembre de 2020Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Fe de erratas: Se omiti贸por error en la Inscripci贸n 40陋 el cambio de estructura del 贸rgano de administraci贸n, pasando la sociedad a tener administradoressolidarios. Datos registrales. T 35119 , F 197, S 8, H M 569517, I/A 40 (18.05.20).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: HUMPHREYS SAMUEL WILLIAM;TAYLOR BRUCE NEIL. Nombramientos. Adm. Unico: DEPRADO LOPEZ YOLANDA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 35119 , F 198, S 8, H M 569517, I/A 42 (19.11.20).
31 de Agosto de 2020Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 35119 , F 197, S 8, H M 569517, I/A 41 (24.08.20).
25 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CAPARICA NETO GILBERTO. Nombramientos. Adm. Solid.: HUMPHREYS SAMUELWILLIAM;TAYLOR BRUCE NEIL. Modificaciones estatutarias. CREACION DEL ARTICULO 7 BIS DE LOS ESTATUTOSSOCIALES-. Datos registrales. T 35119 , F 197, S 8, H M 569517, I/A 40 (18.05.20).
20 de Marzo de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: PONCE DE LEON CU脩AT ALMUDENA;LUCAS CALDERON EDUARDO;OCA脩A LOPEZMARTA;GARCIA MARTIN LAURA MARIA;DE PRADO LOPEZ YOLANDA;VILASECA GRAU JOAN. Datos registrales. T 35119 , F197, S 8, H M 569517, I/A 39 (15.03.20).
28 de Noviembre de 2019Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 35119 , F 196, S 8, H M 569517, I/A 38 (21.11.19).
24 de Junio de 2019Otros conceptos: RECTIFICACION DEL DNI DEL APODERADO NOMBRADO DON I脩IGO RODRIGUEZ LIZUNDIA. Datosregistrales. T 35119 , F 196, S 8, H M 569517, I/A 37 (17.06.19).
20 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESTEBAN MARTINEZ PABLO;RECTON DIDIER ERIC;BADIA LIBERAL IGNACIO;GARCIA MARTINLAURA MARIA;DE PRADO LOPEZ YOLANDA;VILASECA GRAU JOAN;GOMEZ ZAMORA AINARA;LOPEZ GARCIA ANAMARIA;RICO MORA ANA MARIA;GARCIA RUIZ ANTONIO;ALVAREZ FERNANDEZ BEGO脩A;GARCIA ORTIZ ESTIBALIZ;LATOVAMU脩OZ JOAQUIN;TERCERO BRAO EMILIO;RODRIGUEZ LIZUNDIA I脩IGO ROBERTO;RUIZ POZA JOSEP ORIOL;ROMEROPEDROCHE ANTONIO JOSE;GARCIA MORGADO ANA ISABEL. Apo.Sol.: MARTIN JIMENEZ FERNANDO;LOPEZ PALACIOSALFONSO. Datos registrales. T 35119 , F 189, S 8, H M 569517, I/A 36 (10.05.19).
15 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: LAYUS CAZCARRO CARLOS. Apoderado: JOHNSON GRAHAM THOMAS. Datos registrales. T35119 , F 187, S 8, H M 569517, I/A 34 ( 7.06.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA MARTIN LAURA MARIA. Datos registrales. T 35119 , F 187, S 8, H M 569517, I/A 35 (7.06.18).
23 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAEZ BARRIO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 35119 , F 184, S 8, H M 569517, I/A 33(16.05.18).
15 de Marzo de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: CUESTA SACRISTAN JULIO. Datos registrales. T 35119 , F 184, S 8, H M 569517, I/A 32 ( 8.03.18).
22 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 35119 , F 184, S 8, H M 569517, I/A 31 (14.02.18).
15 de Febrero de 2018Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 29陋 EL NOMBRAMIENTO DE CAPARICA NIETO GILBERTO,SIENDO LO CORRECTO CAPARICA NETO GILBERTO. Datos registrales. T 35119 , F 181, S 8, H M 569517, I/A 29 ( 7.12.17).
19 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JOHNSON GRAHAM THOMAS;BADIA LIBERAL IGNACIO. Nombramientos. Adm. Unico:CAPARICA NIETO GILBERTO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 35119 , F 181, S 8, H M 569517, I/A 29 ( 7.12.17).
Nombramientos. Apoderado: JOHNSON GRAHAM THOMAS. Datos registrales. T 35119 , F 182, S 8, H M 569517, I/A 30 (7.12.17).
23 de Marzo de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: VARAS ALVAREZ LAURA FATIMA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CUESTA SACRISTAN JULIO.Datos registrales. T 35119 , F 181, S 8, H M 569517, I/A 28 ( 9.03.17).
24 de Febrero de 2017Otros conceptos: Se subsana la Escritura que causo la Inscripci贸n 25陋 en cuanto al segundo apellido de la apoderada do帽a EstibalizGarc铆a, siendo el correcto ORTIZ , y no Ruiz , como equ铆vocamente se consign贸. Datos registrales. T 35119 , F 181, S 8, H M569517, I/A 27 (17.02.17).
28 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apoderado: MARTOS PRAT RODRIGO;GALLEGO LARRUBIA JAVIER;DE LA QUADRA SALCEDO JANINIANDRES;DANEO CERRO JOSE JAVIER. Apo.Man.Soli: GARCIA GUTIERREZ MARIANO;LAYUS CAZCARRO CARLOS. Apo.Manc.:LOPEZ RANZ ANA. Apoderado: VILASECA GRAU JUAN;DE PRADO LOPEZ YOLANDA;GARCIA MORGADO ANA ISABEL.Apo.Man.Soli: SAEZ BARRIO FRANCISCO JOSE;RECTON DIDIER ERIC. Datos registrales. T 35119 , F 180, S 8, H M 569517, I/A26 (20.12.16).
27 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: BERRUEZO MARQUEZ ALEJANDRO;GARCIA GUTIERREZ MARIANO. Nombramientos.Apo.Man.Soli: RUIZ POZA JOSEP ORIOL;GARCIA RUIZ ANTONIO;GARCIA RUIZ ESTIBALIZ;LATOVA MU脩OZ JOAQUIN;VARASALVAREZ LAURA FATIMA. Otros conceptos: Modificaci贸n de la forma de actuaci贸n de los apoderados nombrados en virtud deescritura que caus贸 la inscripci贸n 23陋 de la sociedad. Datos registrales. T 35119 , F 180, S 8, H M 569517, I/A 25 (19.12.16).
24 de Octubre de 2016Cambio de domicilio social. VIA DE LOS POBLADOS 1 2 - EDIFICIO D (MADRID). Datos registrales. T 31649 , F 225, S 8, H M569517, I/A 24 (14.10.16).
16 de Agosto de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: RECTON DIDIER ERIC;LAYUS CAZCARRO CARLOS;BADIA LIBERAL IGNACIO;DE PRADOLOPEZ YOLANDA;VILASECA GRAU JOAN;BERRUEZO MARQUEZ ALEJANDRO;SAEZ BARRIO FRANCISCO JOSE;GARCIAGUTIERREZ MARIANO;TERCERO BRAO EMILIO;RODRIGUEZ LIZUNDIA I脩IGO ROBERTO;RICO MORA ANA MARIA;GOMEZZAMORA AINARA;ALVAREZ FERNANDEZ BEGO脩A;LOPEZ GARCIA ANA MARIA;GARCIA MORDAGO ANA ISABEL;ROMEROPEDROCHE ANTONIO JOSE. Apo.Sol.: ROMERO PEDROCHE ANTONIO JOSE;REBOTO ESCRIBANO FRANCISCOJAVIER;MARTIN JIMENEZ FERNANDO;LOPEZ PALACIOS ALFONSO. Datos registrales. T 31649 , F 219, S 8, H M 569517, I/A 23( 8.08.16).
08 de Marzo de 2016Revocaciones. Apoderado: LOPEZ RANZ ANA. Apo.Sol.: LOPEZ RANZ ANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RECTON DIDIERERIC. Datos registrales. T 31649 , F 216, S 8, H M 569517, I/A 22 (25.02.16).
01 de Febrero de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAEZ BARRIO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 31649 , F 215, S 8, H M 569517, I/A 21(22.01.16).
29 de Enero de 2016Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CONNECTIS CONSULTING SERVICES SA. Datos registrales. T 31649 , F 210, S8, H M 569517, I/A 20 (22.01.16).
06 de Noviembre de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CONNECTIS ICT SERVICES SPANISH HOLDING SL. Datosregistrales. T 31649 , F 210, S 8, H M 569517, I/A 19 (30.10.15).
10 de Julio de 2015Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 31649 , F 210, S 8, H M 569517, I/A 18 ( 3.07.15).
14 de Abril de 2015Otros conceptos: RECTIFICADA LA ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 16& DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T31649 , F 209, S 8, H M 569517, I/A 17 ( 6.04.15).
17 de Febrero de 2015Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: KIWI IT SERVICES HOLDING SL. Datos registrales. T 31649 , F 206, S 8, H M569517, I/A 16 ( 9.02.15).
01 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: VILASECA GRAU JUAN;DE PRADO LOPEZ YOLANDA. Datos registrales. T 31649 , F 204, S 8, H M569517, I/A 14 (21.11.14).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MORGADO ANA ISABEL. Datos registrales. T 31649 , F 206, S 8, H M 569517, I/A 15(21.11.14).
13 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ RANZ ANA. Datos registrales. T 31649 , F 203, S 8, H M 569517, I/A 12 ( 4.06.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAYUS CAZCARRO CARLOS. Apo.Manc.: LOPEZ RANZ ANA. Datos registrales. T 31649 , F 203,S 8, H M 569517, I/A 13 ( 4.06.14).
23 de Mayo de 2014Cambio de domicilio social. C/ VIA DE LOS POBLADOS 3 - PLANTA 5, PARQUE EMPRE (MADRID). Datos registrales. T 31649 ,
16 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA GUTIERREZ MARIANO. Datos registrales. T 31649 , F 202, S 8, H M 569517, I/A 10 (7.05.14).
21 de Abril de 2014Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: KIWI IT SERVICES HOLDING SL. Ceses/Dimisiones. Consejero:HELBERT CYRILLE;RODRIGUEZ CARRION CARMEN;TAGGER ALEXANDRE. Presidente: TAGGER ALEXANDRE. SecreNoConsj:GARCIA PAEZ LIDIA. Nombramientos. Adm. Solid.: JOHNSON GRAHAM THOMAS;BADIA LIBERAL IGNACIO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T31649 , F 112, S 8, H M 569517, I/A 7 ( 9.04.14).
Revocaciones. Apoderado: TAGGER ALEXANDER;DOMENECH MONTES HELENA;FERNANDEZ CANSECO MARTA.Nombramientos. Apoderado: MARTOS PRAT RODRIGO;GALLEGO LARRUBIA JAVIER;DE LA QUADRA SALCEDO JANINIANDRES;DANEO CERRO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 31649 , F 112, S 8, H M 569517, I/A 8 ( 9.04.14).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ RANZ ANA. Datos registrales. T 31649 , F 200, S 8, H M 569517, I/A 9 ( 9.04.14).
01 de Abril de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 96.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Otros conceptos: Sociedad Beneficiariade la Segregaci贸n de Rama de Actividad de al entidad TELVENT GLOBAL SERVICES, S.A. Datos registrales. T 31649 , F 109, S 8,H M 569517, I/A 6 (24.03.14).
21 de Febrero de 2014Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: TELVENT GLOBAL SERVICES SA. Cambio de objeto social. Laproducci贸n, desarrollo, seguimiento, gesti贸n, integraci贸n, formaci贸n, soporte, comercializaci贸n y distribuci贸n de servicios, herramientasy productos en el campo de los sistemas de informaci贸n y las comunicaciones. La realizaci贸n de cualquier servicio de consultor铆at茅cnica de negocio, de sistem. Datos registrales. T 31649 , F 108, S 8, H M 569517, I/A 5 (13.02.14).
03 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: DOMENECH MONTES HELENA;FERNANDEZ CANSECO MARTA. Datos registrales. T 31649 , F108, S 8, H M 569517, I/A 4 (27.01.14).
14 de Enero de 2014Nombramientos. Apoderado: TAGGER ALEXANDER. Datos registrales. T 31649 , F 106, S 8, H M 569517, I/A 3 ( 3.01.14).
26 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANTIAGO PEREZ ANTONIO. Nombramientos. Consejero: HELBERT CYRILLE;RODRIGUEZCARRION CARMEN. SecreNoConsj: GARCIA PAEZ LIDIA. Consejero: TAGGER ALEXANDRE. Presidente: TAGGER ALEXANDRE.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Cambio dedomicilio social. C/ VALGRANDE 6 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 31649 , F 105, S 8, H M 569517, I/A 2 (18.12.13).
05 de Diciembre de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 20.11.13. Objeto social: 1. La adquisici贸n, administraci贸n y gesti贸n de patrimonio mobiliario,cartera de valores e inversiones, todo ello por cuenta propia. Este objeto social no podr谩 ser desarrollado cuando incida en lalegislaci贸n de inversiones colectivas. CNAE 6832. 2. Domicilio: C/ PRADILLO 5 - BAJO EXTERIOR, DERECHA (MADRID). Capital:3.600,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL. Nombramientos.Adm. Unico: SANTIAGO PEREZ ANTONIO. Datos registrales. T 31649 , F 104, S 8, H M 569517, I/A 1 (28.11.13).