Actos BORME de Global Vambru Sl
06 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Representan: VERA VAZQUEZ FRANCISCO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 261/2018. FIRME:Si, Fecha de resoluci贸n 14/07/2021. Auto de conclusi贸n del concurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DELO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS. Resoluciones: CONCURSO ORDINARIO:CONCLUSION CANCELACION DE LA HOJA DE LA SOCIEDAD. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 261/2018. Fechade resoluci贸n 22/06/2018. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID.Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 14/07/2021, NIF/CIF B65793879. DATA CONCURSAL SLP.Extinci贸n. Datos registrales. T 31707 , F 52, S 8, H M 491116, I/A 43 (30.07.21).
31 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ GONZALEZ JUAN ANDRES. Apo.Man.Soli: ALVAREZ GONZALEZ JUAN ANDRES. Datosregistrales. T 31707 , F 52, S 8, H M 491116, I/A 42 (24.05.19).
29 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN FRANCISCO DAMIAN DOROTEO. Datos registrales. T 31707 , F 52, S 8, H M 491116, I/A 41(22.05.19).
24 de Diciembre de 2018Cambio de domicilio social. AVDA MANOTERAS 18 (MADRID). Datos registrales. T 31707 , F 52, S 8, H M 491116, I/A 40(13.12.18).
08 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: REINA PINTO JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: ACACIO COLLADO VICENTE.Datos registrales. T 31707 , F 51, S 8, H M 491116, I/A 39 (31.10.18).
07 de Noviembre de 2018Nombramientos. Representan: VERA VAZQUEZ FRANCISCO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 261/2018. FIRME:No, Fecha de resoluci贸n 22/06/2018. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTILDE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: La deudora conservar谩 las facultades de administraci贸n y disposici贸nsobre su patrimonio, quedando sometida el ejercicio de 茅stas a la intervenci贸n de la administraci贸n concursal mediante su autorizaci贸no conformidad. En todo caso, la deudora (y trat谩ndose de persona jur铆dica, sus administradores o. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 261/2018. Fecha de resoluci贸n 22/06/2018. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADODE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 22/06/2018, NIF/CIFB65793879. DATA CONCURSAL SLP. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 261/2018. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n22/06/2018. Resoluci贸n judicial de acumulaci贸n de concurso. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez:CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: Se acuerda la acumulaci贸n del presente concurso al que se tramita en este Juzgado bajolos autos de concurso voluntario n煤m. 700/2017 con relaci贸n a GRUPO ISOLUX CORSAN, S.A. Y OTRAS, para su tramitaci贸ncoordinada bajo el r茅gimen de los concursos conexos. Datos registrales. T 31707 , F 50, S 8, H M 491116, I/A A (30.10.18).
20 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BARREIRO NOGALEDO ENRIQUE;REINA PINTO JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm.Unico: REINA PINTO JUAN CARLOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 31707 , F 50, S 8, H M 491116, I/A 38 ( 8.11.17).
19 de Agosto de 2015Nombramientos. Apoderado: DELSO RAMIREZ DEL MOLINO ALVARO;ALVAREZ DIAZ DE CERIO CARLOS;CRUZ CRUZ
28 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Nombramientos. Adm. Mancom.: BARREIRO NOGALEDOENRIQUE. Datos registrales. T 31707 , F 49, S 8, H M 491116, I/A 36 (20.04.15).
10 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MARTINEZ BORALLO ANTONIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: REINA PINTO JUANCARLOS. Datos registrales. T 31707 , F 49, S 8, H M 491116, I/A 35 ( 3.06.14).
12 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: BENITO RICHARD DAVID;REINA PINTO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 31707 , F 48, S 8, H M491116, I/A 34 ( 5.05.14).
15 de Enero de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: MONTES MONTES ALBERTO. Apo.Manc.: MONTES MONTES ALBERTO. Datos registrales. T 31707 , F48, S 8, H M 491116, I/A 33 ( 3.01.14).
23 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVAREZ GONZALEZ JUAN ANDRES. Apo.Manc.: VALENZUELA CONTRERASCOSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 27714 , F 19,S 8, H M 491116, I/A 32 (16.12.13).
11 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;VALENZUELA CONTRERASCOSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A;MARTINEZ BORRALLO ANTONIO. Datos registrales. T 27714 , F 17,S 8, H M 491116, I/A 31 ( 3.06.13).
13 de Marzo de 2013Segregaci贸n. Beneficiarios de la segregaci贸n: AGUAS DE GATA SL. Datos registrales. T 27714 , F 14, S 8, H M 491116, I/A 30 (5.03.13).
14 de Enero de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: VARELA ULLASTRES SANTIAGO. Datos registrales. T 27714 , F 14, S 8, H M 491116, I/A 28 (4.01.13).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ PEREZ ROBERTO. Datos registrales. T 27714 , F 14, S 8, H M 491116, I/A 29 ( 4.01.13).
07 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ SANZ MARIA. Datos registrales. T 27714 , F 14, S 8, H M 491116, I/A 27 (28.08.12).
20 de Junio de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: GRACIA CEBOLLADA ANTONIO. Datos registrales. T 27714 , F 13, S 8, H M 491116, I/A 25 (6.06.12).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABALLERO FERNANDEZ FERNANDO. Datos registrales. T 27714 , F 13, S 8, H M 491116, I/A 26( 6.06.12).
14 de Junio de 2012Otros conceptos: SUBSANACION DE LA INSCRIPCION 19& DE SEGREGACION. Datos registrales. T 27714 , F 13, S 8, H M491116, I/A 24 ( 4.06.12).
23 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ROMERO JAVIER. Datos registrales. T 27714 , F 13, S 8, H M 491116, I/A 23 (11.05.12).
16 de Mayo de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: MESTRE MORALES-ALBO JOSE-DEMETRIO. Datos registrales. T 27714 , F 13, S 8, H M 491116,I/A 22 ( 3.05.12).
04 de Mayo de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA CREUS RUIZ BERDEJO PEDRO. Datos registrales. T 27714 , F 12, S 8, H M 491116, I/A 21
26 de Abril de 2012Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27714 , F 12, S 8, H M 491116,I/A 20 (16.04.12).
04 de Abril de 2012Otros conceptos: SEGREGADO PARTE DEL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA CORRESPONDIENTE A LA RAMADE ACTIVIDAD DE GESTION DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, A FAVOR DE LA SOCIEDADRESIDUOS AMBIENTALES DE GALICIA SL, DOMICILIADA EN MADRID. Datos registrales. T 27714 , F 11, S 8, H M 491116, I/A 19(26.03.12).
03 de Abril de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: SALMERON UNTURBE JESUS. Datos registrales. T 27714 , F 11, S 8, H M 491116, I/A 18(22.03.12).
27 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN. Datos registrales. T 27714 , F 10, S 8, H M 491116, I/A 17(15.02.12).
28 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ ROJAS JUAN DE DIOS;HERNANDEZ MU脩OZ ANTONIO JESUS;SAGASTIZABALCARDELUS ALFONSO MARIA. Datos registrales. T 27714 , F 10, S 8, H M 491116, I/A 16 (16.11.11).
13 de Mayo de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVAREZ GONZALEZ JUAN ANDRES;MASID BANDE JULIO ARMANDO;LOPEZ MONTERO JOSE.Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO. Datos registrales. T 27714 , F 10, S 8, H M 491116, I/A 15 ( 3.05.11).
07 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ GONZALEZ JUAN ANDRES;MASID BANDE JULIO ARMANDO;ESCRIBANO MORAENRIQUE;LOPEZ MONTERO JOSE;GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE;DE EGA脩A HUERTA ALFONSO MIGUEL;VALENZUELACONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 27714 , F 9, S 8, H M 491116, I/A14 (23.02.11).
24 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SANZ MARIA. Datos registrales. T 27714 , F 8, S 8, H M 491116, I/A 12 (15.02.11).
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ ABELAIRAS ALBERTO. Datos registrales. T 27714 , F 9, S 8, H M 491116, I/A 13 (15.02.11).
02 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: GIL CIVANTOS JOSE IGNACIO;ESCRIBANO MORA ENRIQUE. Datos registrales. T 27714 , F 8, S8, H M 491116, I/A 11 (20.10.10).
18 de Octubre de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALBERTE SENDIN CESAR ENRIQUE. Apo.Manc.: GARCIA MATEOS MANUEL-JOSE;VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 27714 , F 6,S 8, H M 491116, I/A 9 ( 5.10.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVAREZ GONZALEZ JUAN ANDRES;MASID BANDE JULIO ARMANDO;LOPEZ MONTEROJOSE. Apo.Manc.: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO. Datos registrales. T 27714 , F 7, S 8, H M 491116, I/A 10 ( 5.10.10).
31 de Mayo de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: MONTES MONTES ALBERTO. Apo.Manc.: MONTES MONTES ALBERTO;VALENZUELA CONTRERASCOSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datos registrales. T 27259 , F 77,S 8, H M 491116, I/A 7 (19.05.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ BORRALLO ANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE;CABALLERO FERNANDEZFERNANDO;SALMERON UNTURBE JESUS;GRACIA CEBOLLADA ANTONIO;MESTRE MORALES-ALBO JOSE-DEMETRIO;PIREABARCA FERNANDO JAVIER;VIA OZALLA OSCAR;VARELA ULLASTRES SANTIAGO;VALENZUELA CONTRERASCOSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Apo.Sol.: MIGUEL GONZALEZ LUIS ESTEBAN;MARTIN CASTELLOFELIX;MARTIN FRANCISCO DAMIAN DOROTEO;GONZALEZ DURAN BARBARA;FOJO ARIAS LINO;HERNANDEZ MU脩OZANTONIO JESUS;SANCHEZ ROJAS JUAN DE DIOS;CALVO REY MANUEL;MARTINEZ LARRAD DANIEL EUSEBIO;ORTIZ DE LATABLA GONZALEZ JOSE;CODES DIAZ QUETCUTI MANUEL;MINGUITO MARTIN JESUS. Apo.Man.Soli: LAYOS PARDO JOSEANTONIO. Apo.Sol.: ARIAS GONZALEZ FERNANDO;ATIENZA LA ORDEN JORGE;GOMEZ MARTINEZ CRISTIAN;RUIZ DECASTA脩EDA RODRIGUEZ HENAR;MARTINEZ ABELAIRAS ALBERTO;JURISTO CONTRERAS BRUNO;PRADOS MATEOSFRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ DE CLERCK ELIZALDE RAFAEL;GONZALO HERNANDO MIGUEL;GARCIA CREUS RUIZBERDEJO PEDRO. Datos registrales. T 27259 , F 78, S 8, H M 491116, I/A 8 (19.05.10).
14 de Mayo de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALENZUELA CONTRERAS COSME;SANCHEZ TELLO ANTONIO;CRUZ CRUZ BEGO脩A. Datosregistrales. T 27259 , F 77, S 8, H M 491116, I/A 5 ( 4.05.10).
Nombramientos. Apoderado: LAYOS PARDO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 27259 , F 77, S 8, H M 491116, I/A 6 (4.05.10).
12 de Mayo de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 103.600,00 Euros. Otros conceptos: ADQUISICION DEPARTE DEL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD PARCIALMENTE ESCINDIDA DENOMINADA " ISOLUX CORSAN SERVICIOS SA".Datos registrales. T 27259 , F 73, S 8, H M 491116, I/A 4 (28.04.10).
18 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANTIAGO PEREZ ANTONIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: MARTINEZ BORALLOANTONIO;GARCIA MATEOS MANUEL JOSE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador煤nico a Administradores mancomunados. Cambio de domicilio social. C/ CABALLERO ANDANTE 8 (MADRID). Cambio de objetosocial. RECOGIDA, TRANSPORTE, COMPATACION, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS URBANOS, INDUSTRALESO CUALESQUIERA OTROS. Datos registrales. T 27259 , F 72, S 8, H M 491116, I/A 2 ( 6.02.10).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ISOLUX CORSAN SERVICIOS SA. Datos registrales. T 27259 , F73, S 8, H M 491116, I/A 3 ( 6.02.10).
30 de Diciembre de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 10.12.09. Objeto social: EL ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA, CONTABLE.Domicilio: C/ PRADILLO 5 - BAJO EXTERIOR, DERECHA (MADRID). Capital: 3.600,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad.Socio 煤nico: LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL. Nombramientos. Adm. Unico: SANTIAGO PEREZ ANTONIO. Datosregistrales. T 27259 , F 69, S 8, H M 491116, I/A 1 (16.12.09).