Buscador CIF Logo

Actos BORME Goiko Grill Group Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Goiko Grill Group Sl

Actos BORME Goiko Grill Group Sl - B87771945

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Goiko Grill Group Sl con CIF B87771945

馃敊 Perfil de Goiko Grill Group Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Goiko Grill Group Sl

04 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: TRIBUIANI MARIO. Apoderado: PONCE HERRERO JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZDEL RIO RICO-VILLADEMOROS CRISTINA. Datos registrales. T 44011 , F 30, S 8, H M 645523, I/A 25 (28.07.23).

24 de Julio de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: LABORA CASTRO IVAN. Apo.Sol.: LABORA CASTRO IVAN. Nombramientos. Apoderado: CAMACHOPEDRAZA SANTIAGO. Datos registrales. T 44011 , F 28, S 8, H M 645523, I/A 24 (17.07.23).

16 de Septiembre de 2022
Otros conceptos: la sociedad es beneficiaria del patrimonio escindido parcialmente por la entidad domiciliada en Madrid denominada" Goiko Gourmet SL ".- Datos registrales. T 41139 , F 83, S 8, H M 645523, I/A 22 ( 9.09.22).

17 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA SAN JOSE MARIA JESUS. Nombramientos. Representan: KREMER HAMERMESZAMIR. Datos registrales. T 41139 , F 83, S 8, H M 645523, I/A 21 (10.06.22).

28 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ HUERTA MANUEL;ALVAREZ HUERTA MANUEL;CASTAN RODRIGUEZ HECTOR-JOSE.Apo.Manc.: CASTAN RODRIGUEZ HECTOR-JOSE;MARTIN IZQUIERDO ALBERTO. Apo.Sol.: MARTIN IZQUIERDOALBERTO;MARTIN IZQUIERDO ALBERTO. Datos registrales. T 41139 , F 80, S 8, H M 645523, I/A 20 (21.02.22).

17 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: BARQUIN ORBEA ELENA. Apo.Manc.: BARQUIN ORBEA ELENA. Datos registrales. T 41139 , F 80, S 8,H M 645523, I/A 19 (10.11.21).

12 de Noviembre de 2021
Otros conceptos: SE SUBSANA LA CERTIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EL 24 DE JUNIO DE 2021 QUE CAUSOLA INSCRIPCION 18陋. Datos registrales. T 41139 , F 80, S 8, H M 645523, I/A 18M ( 3.11.21).

29 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 41139 , F 80, S 8, H M 645523, I/A 18 (22.09.21).

29 de Junio de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: NASCIMENTO RODRIGUEZ MIGUELANGEL. Apo.Sol.: NASCIMENTO RODRIGUEZ MIGUELANGEL.Datos registrales. T 41139 , F 77, S 8, H M 645523, I/A 16 (22.06.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ GOMEZ FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 41139 , F 78, S 8, H M 645523, I/A 17(22.06.21).

09 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: BURGOS LASO MARIA TERESA. Apo.Manc.: BURGOS LASO MARIA TERESA;GONZALEZ RAMIREZALVARO. Datos registrales. T 41139 , F 77, S 8, H M 645523, I/A 15 (31.03.21).

05 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apoderado: PONCE HERRERO JOSE. Datos registrales. T 35926 , F 205, S 8, H M 645523, I/A 14 (29.01.21).

30 de Diciembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: LABORA CASTRO IVAN;CAMI脩A AROCHA EDUARDO JOSE;MAIOLINO MANZANO HECTORJOSE;NASCIMENTO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL;PERUCHINE JESUS ANTONIO FERREIRA;RAMIREZ FERNANDEZ LUISALBERTO. Apo.Sol.: MARQUES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Apo.Sol.: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONIJAVIER;BURGOS LASO MARIA TERESA;BURGOS LASO MARIA TERESA. Apo.Manc.: BURGOS LASO MARIA TERESA;BURGOS

Ampliacion del objeto social. LA EXPLOTACION, GESTION, COMERCIALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESPROPIAS DE HOSTELERIA Y LA RESTAURACION EN GENERAL. Datos registrales. T 35926 , F 205, S 8, H M 645523, I/A 13(22.12.20).

23 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Representan: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER. Nombramientos. Representan: GARCIA SAN JOSEMARIA JESUS. Datos registrales. T 35926 , F 201, S 8, H M 645523, I/A 11 (16.12.20).

21 de Febrero de 2020
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Otros conceptos: Se revoca por causa justa el nombramiento de "PKF ATTEST

03 de Octubre de 2019
Cambio de domicilio social. C/ MAESTRO ANGEL LLORCA 6 5 - BAJO (MADRID). Datos registrales. T 35926 , F 201, S 8, H M645523, I/A 9 (26.09.19).

01 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: MARQUES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 35926 , F 200, S 8, H M 645523, I/A8 (24.06.19).

10 de Junio de 2019
Nombramientos. Apoderado: LABORA CASTRO IVAN. Datos registrales. T 35926 , F 199, S 8, H M 645523, I/A 5 ( 3.06.19).

Nombramientos. Apoderado: PERUCHINE JESUS ANTONIO FERREIRA. Datos registrales. T 35926 , F 199, S 8, H M 645523, I/A6 ( 3.06.19).

Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 35926 , F 200, S 8, H M 645523, I/A 7 (3.06.19).

07 de Junio de 2019
Nombramientos. Apoderado: CAMI脩A AROCHA EDUARDO JOSE;MAIOLINO MANZANO HECTOR JOSE;NASCIMENTORODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 35926 , F 198, S 8, H M 645523, I/A 4 ( 2.06.19).

13 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER;VIVAR GOZALVEZ FERNANDO;MONTES O'CONNORFERNANDO;KINDELAN EVERETT ULTANO;GONZALEZ HUMBERTO JOSE. Presidente: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER.Vicepresid.: GONZALEZ HUMBERTO JOSE. Secretario: VIVAR GOZALVEZ FERNANDO. Con.Delegado: GOICOECHEA ARRAIZANDONI JAVIER. Nombramientos. Representan: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER. Adm. Unico:INTERNATIONALBURGERCO SL. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULO 8 y 18 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 35926 , F 197, S 8, H M 645523, I/A 2 ( 6.09.18).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: INTERNATIONALBURGERCO SL. Datos registrales. T 35926 , F198, S 8, H M 645523, I/A 3 ( 6.09.18).

12 de Mayo de 2017
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 3.03.17. Objeto social: La gesti贸n, tenencia y administraci贸n de valores representativos delos fondos propios de entidades residentes o no residentes en territorio espa帽ol, mediante la correspondiente organizaci贸n de mediosmateriales y personales. Domicilio: C/ RAFAEL CALVO 30 - 1陋 PLANTA (MADRID). Capital: 100.000,00 Euros. Declaraci贸n deunipersonalidad. Socio 煤nico: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER. Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOSEMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Consejero: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER;VIVAR GOZALVEZFERNANDO;MONTES O'CONNOR FERNANDO;KINDELAN EVERETT ULTANO;GONZALEZ HUMBERTO JOSE. Presidente:GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER. Vicepresid.: GONZALEZ HUMBERTO JOSE. Secretario: VIVAR GOZALVEZ FERNANDO.Con.Delegado: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER. Datos registrales. T 35926 , F 191, S 8, H M 645523, I/A 1 ( 5.05.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n