Actos BORME de Goiko Grill Group Sl
04 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: TRIBUIANI MARIO. Apoderado: PONCE HERRERO JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZDEL RIO RICO-VILLADEMOROS CRISTINA. Datos registrales. T 44011 , F 30, S 8, H M 645523, I/A 25 (28.07.23).
24 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: LABORA CASTRO IVAN. Apo.Sol.: LABORA CASTRO IVAN. Nombramientos. Apoderado: CAMACHOPEDRAZA SANTIAGO. Datos registrales. T 44011 , F 28, S 8, H M 645523, I/A 24 (17.07.23).
16 de Septiembre de 2022Otros conceptos: la sociedad es beneficiaria del patrimonio escindido parcialmente por la entidad domiciliada en Madrid denominada" Goiko Gourmet SL ".- Datos registrales. T 41139 , F 83, S 8, H M 645523, I/A 22 ( 9.09.22).
17 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA SAN JOSE MARIA JESUS. Nombramientos. Representan: KREMER HAMERMESZAMIR. Datos registrales. T 41139 , F 83, S 8, H M 645523, I/A 21 (10.06.22).
28 de Febrero de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ HUERTA MANUEL;ALVAREZ HUERTA MANUEL;CASTAN RODRIGUEZ HECTOR-JOSE.Apo.Manc.: CASTAN RODRIGUEZ HECTOR-JOSE;MARTIN IZQUIERDO ALBERTO. Apo.Sol.: MARTIN IZQUIERDOALBERTO;MARTIN IZQUIERDO ALBERTO. Datos registrales. T 41139 , F 80, S 8, H M 645523, I/A 20 (21.02.22).
17 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: BARQUIN ORBEA ELENA. Apo.Manc.: BARQUIN ORBEA ELENA. Datos registrales. T 41139 , F 80, S 8,H M 645523, I/A 19 (10.11.21).
12 de Noviembre de 2021Otros conceptos: SE SUBSANA LA CERTIFICACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EL 24 DE JUNIO DE 2021 QUE CAUSOLA INSCRIPCION 18陋. Datos registrales. T 41139 , F 80, S 8, H M 645523, I/A 18M ( 3.11.21).
29 de Septiembre de 2021Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 41139 , F 80, S 8, H M 645523, I/A 18 (22.09.21).
29 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: NASCIMENTO RODRIGUEZ MIGUELANGEL. Apo.Sol.: NASCIMENTO RODRIGUEZ MIGUELANGEL.Datos registrales. T 41139 , F 77, S 8, H M 645523, I/A 16 (22.06.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ GOMEZ FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 41139 , F 78, S 8, H M 645523, I/A 17(22.06.21).
09 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: BURGOS LASO MARIA TERESA. Apo.Manc.: BURGOS LASO MARIA TERESA;GONZALEZ RAMIREZALVARO. Datos registrales. T 41139 , F 77, S 8, H M 645523, I/A 15 (31.03.21).
05 de Febrero de 2021Nombramientos. Apoderado: PONCE HERRERO JOSE. Datos registrales. T 35926 , F 205, S 8, H M 645523, I/A 14 (29.01.21).
30 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: LABORA CASTRO IVAN;CAMI脩A AROCHA EDUARDO JOSE;MAIOLINO MANZANO HECTORJOSE;NASCIMENTO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL;PERUCHINE JESUS ANTONIO FERREIRA;RAMIREZ FERNANDEZ LUISALBERTO. Apo.Sol.: MARQUES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Apo.Sol.: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONIJAVIER;BURGOS LASO MARIA TERESA;BURGOS LASO MARIA TERESA. Apo.Manc.: BURGOS LASO MARIA TERESA;BURGOS
Ampliacion del objeto social. LA EXPLOTACION, GESTION, COMERCIALIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESPROPIAS DE HOSTELERIA Y LA RESTAURACION EN GENERAL. Datos registrales. T 35926 , F 205, S 8, H M 645523, I/A 13(22.12.20).
23 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER. Nombramientos. Representan: GARCIA SAN JOSEMARIA JESUS. Datos registrales. T 35926 , F 201, S 8, H M 645523, I/A 11 (16.12.20).
21 de Febrero de 2020Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Otros conceptos: Se revoca por causa justa el nombramiento de "PKF ATTEST
03 de Octubre de 2019Cambio de domicilio social. C/ MAESTRO ANGEL LLORCA 6 5 - BAJO (MADRID). Datos registrales. T 35926 , F 201, S 8, H M645523, I/A 9 (26.09.19).
01 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MARQUES GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 35926 , F 200, S 8, H M 645523, I/A8 (24.06.19).
10 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: LABORA CASTRO IVAN. Datos registrales. T 35926 , F 199, S 8, H M 645523, I/A 5 ( 3.06.19).
Nombramientos. Apoderado: PERUCHINE JESUS ANTONIO FERREIRA. Datos registrales. T 35926 , F 199, S 8, H M 645523, I/A6 ( 3.06.19).
Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 35926 , F 200, S 8, H M 645523, I/A 7 (3.06.19).
07 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: CAMI脩A AROCHA EDUARDO JOSE;MAIOLINO MANZANO HECTOR JOSE;NASCIMENTORODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 35926 , F 198, S 8, H M 645523, I/A 4 ( 2.06.19).
13 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER;VIVAR GOZALVEZ FERNANDO;MONTES O'CONNORFERNANDO;KINDELAN EVERETT ULTANO;GONZALEZ HUMBERTO JOSE. Presidente: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER.Vicepresid.: GONZALEZ HUMBERTO JOSE. Secretario: VIVAR GOZALVEZ FERNANDO. Con.Delegado: GOICOECHEA ARRAIZANDONI JAVIER. Nombramientos. Representan: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER. Adm. Unico:INTERNATIONALBURGERCO SL. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULO 8 y 18 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 35926 , F 197, S 8, H M 645523, I/A 2 ( 6.09.18).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: INTERNATIONALBURGERCO SL. Datos registrales. T 35926 , F198, S 8, H M 645523, I/A 3 ( 6.09.18).
12 de Mayo de 2017Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 3.03.17. Objeto social: La gesti贸n, tenencia y administraci贸n de valores representativos delos fondos propios de entidades residentes o no residentes en territorio espa帽ol, mediante la correspondiente organizaci贸n de mediosmateriales y personales. Domicilio: C/ RAFAEL CALVO 30 - 1陋 PLANTA (MADRID). Capital: 100.000,00 Euros. Declaraci贸n deunipersonalidad. Socio 煤nico: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER. Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOSEMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Consejero: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER;VIVAR GOZALVEZFERNANDO;MONTES O'CONNOR FERNANDO;KINDELAN EVERETT ULTANO;GONZALEZ HUMBERTO JOSE. Presidente:GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER. Vicepresid.: GONZALEZ HUMBERTO JOSE. Secretario: VIVAR GOZALVEZ FERNANDO.Con.Delegado: GOICOECHEA ARRAIZ ANDONI JAVIER. Datos registrales. T 35926 , F 191, S 8, H M 645523, I/A 1 ( 5.05.17).