Buscador CIF Logo

Actos BORME Golf Novo Sancti Petri Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Golf Novo Sancti Petri Sa

Actos BORME Golf Novo Sancti Petri Sa - A11655966

Tenemos registrados 39 Actos BORME del Registro Mercantil de Cadiz para Golf Novo Sancti Petri Sa con CIF A11655966

🔙 Perfil de Golf Novo Sancti Petri Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Cadiz

Actos BORME de Golf Novo Sancti Petri Sa

14 de Junio de 2023
Nombramientos. Apoderado: OLIVIA BONIS CALVO. Datos registrales. T 2489 , F 68, S 8, H CA 583, I/A 66 ( 6.06.23).

01 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROYAL CUPIDO SA;RAFAEL ROSSELLO CERDA;ALBERTO LLOMPART SOLER. Presidente:ROYAL CUPIDO SA. Secretario: ALBERTO LLOMPART SOLER. Nombramientos. Consejero: ROYAL CUPIDO SA. Presidente:ROYAL CUPIDO SA. Consejero: RAFAEL ROSSELLO CERDA;ALBERTO LLOMPART SOLER. Secretario: ALBERTO LLOMPARTSOLER. Datos registrales. T 2489 , F 67, S 8, H CA 583, I/A 64 (24.05.23).

Revocaciones. Auditor: KPMG PEAT MARWICK AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: ERNST YOUNG SA. Datosregistrales. T 2489 , F 67, S 8, H CA 583, I/A 65 (24.05.23).

22 de Junio de 2022
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 14º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. INCLUIDO EL ARTICULO 14ºBIS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 2330 , F 140, S 8, H CA 583, I/A 63 (14.06.22).

29 de Marzo de 2022
Nombramientos. Auditor: KPMG PEAT MARWICK AUDITORES SL. Datos registrales. T 2330 , F 139, S 8, H CA 583, I/A 62(21.03.22).

07 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ ALCALA JOSE RAFAEL. Vicepresid.: HERNANDEZ ALCALA JOSE RAFAEL.Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ ALCALA JOSE RAFAEL. Vicepresid.: HERNANDEZ ALCALA JOSE RAFAEL. Auditor:ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2330 , F 139, S 8, H CA 583, I/A 61 (28.06.21).

30 de Junio de 2021
Nombramientos. VsecrNoConsj: LOPEZ GURRUCHAGA AMAIA. Datos registrales. T 2330 , F 134, S 8, H CA 583, I/A 59(21.06.21).

Nombramientos. Apoderado: ZAMORA AGUIRRE LUIS MANUEL;GINARD ROMERO RAMON;PALOU GUAL JAIME;REJONGALERA MARIA JESUS. Datos registrales. T 2330 , F 134, S 8, H CA 583, I/A 60 (22.06.21).

11 de Enero de 2021
Revocaciones. Apoderado: COSTOYA BARREIRO JUAN CARLOS. Apo.Sol.: COSTOYA BARREIRO JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 2330 , F 136, S 8, H CA 583, I/A 58 (22.12.20).

14 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: BAS ESPARGARO KRISHNA. Revocaciones. Apo.Sol.: BAS ESPARGARO KRISHNA. Datosregistrales. T 2330 , F 136, S 8, H CA 583, I/A 57 ( 1.12.20).

11 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VAZQUEZ VILLA AURELIO MANUEL;VERA DOLS ANTONIO;BENNASAR MARROIG BARTOLOME.Apo.Manc.: VAZQUEZ VILLA AURELIO MANUEL. Apo.Man.Soli: BIBILONI CALAFELL BERNARDINO;ARNAU SIERRAJOSE;CIBEIRA MOREIRAS ROBERTO. Apo.Manc.: VERA DOLS ANTONIO;BIBILONI CALAFELL BERNARDINO;VILA CRUZRAMON;LLOMPART SOLER FERRAN;LLOMPART BERNARDINO MARGARITA;PONS DOMINGO JOSE. Apoderado: VAZQUEZVILLA AURELIO MANUEL. Apo.Sol.: VERA DOLS ANTONIO. Apo.Manc.: LLOBERA BARCELO JAUME. Nombramientos.Apo.Man.Soli: LLOMPART SOLER ALBERTO;ROSELLO CERDA RAFAEL;MOSCARDO COVO RODRIGO;PONS DOMINGO JOSE.Apo.Manc.: LLOMPART SOLER FERRAN;LLOMPART BERNARDINO MARGARITA;BIBILONI CALAFELL BERNARDINO;VILA CRUZRAMON;ALOMAR AMOROS FRANCISCO JAVIER;FIOL BISQUERRA JAIME;LLOMPART SOLER ALBERTO;ROSELLO CERDARAFAEL;MOSCARDO COVO RODRIGO;PONS DOMINGO JOSE. Datos registrales. T 2272 , F 156, S 8, H CA 583, I/A 56(26.11.19).

01 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: LLOMPART SOLER FERRAN;LLOMPART BERNARDINO MARGARITA. Datos registrales. T 2272 , F155, S 8, H CA 583, I/A 53 (25.07.19).

Nombramientos. Apoderado: COSTOYA BARREIRO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 2272 , F 156, S 8, H CA 583, I/A 54(25.07.19).

Otros conceptos: Cambio Representante Persona Física de "ROYAL CUPIDO SL", en los cargos que ostenta en "GOLF NOVOSANCTI PETRI SA", designándose a DON LUIS MIGUEL MOTA OTERO, con DNI: 77.593.728-P, en sustitución de Don AurelioManuel Vázquez Villa.- Datos registrales. T 2272 , F 156, S 8, H CA 583, I/A 55 (25.07.19).

23 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ALCARAZ IBAÑEZ MARIA VICTORIA. Nombramientos. Apoderado: LLOMPART SOLERALBERTO;ROSELLO CERDA RAFAEL. Apo.Sol.: MOSCARDO COVO RODRIGO;VERA DOLS ANTONIO. Apo.Manc.: BIBILONICALAFELL BERNARDINO;VILA CRUZ RAMON;LLOMPART SOLER FERRAN;LLOMPART BERNARDINO MARGARITA;PONSDOMINGO JOSE. Apo.Sol.: MARTINEZ PENALVA ANTONIO;SANGUINO MORA IGNACIO;ALCARAZ IBAÑEZ MARIAVICTORIA;SUREDA CERDA MARTA;BAS ESPARGARO KRISHNA. Apoderado: VAZQUEZ VILLA AURELIO MANUEL.VsecrNoConsj: BAS ESPARGARO KRISHNA. Datos registrales. T 2272 , F 150, S 8, H CA 583, I/A 52 (15.10.18).

29 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROYAL CUPIDO SA;LLOMPART SOLER ALBERTO;ROSELLO CERDA RAFAEL. Presidente:ROYAL CUPIDO SA. Secretario: LLOMPART SOLER ALBERTO. Nombramientos. Consejero: ROYAL CUPIDO SA;ROSELLOCERDA RAFAEL. Presidente: ROYAL CUPIDO SA. Consejero: LLOMPART SOLER ALBERTO. Secretario: LLOMPART SOLERALBERTO. Datos registrales. T 2019 , F 10, S 8, H CA 583, I/A 50 (21.05.18).

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2019 , F 11, S 8, H CA 583, I/A 51 (21.05.18).

21 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO CERDA RAFAEL. Datos registrales. T 2019 , F 10, S 8, H CA 583, I/A 49 (15.06.17).

04 de Mayo de 2017
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2019 , F 10, S 8, H CA 583, I/A 48 (21.04.17).

28 de Junio de 2016
Reducción de capital. Importe reducción: 6.359.896,55 Euros. Resultante Suscrito: 2.640.105,54 Euros. Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T2019 , F 8, S 8, H CA 583, I/A 47 (16.06.16).

02 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2019 , F 8, S 8, H CA 583, I/A 45 (23.10.15).

Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ ALCALA JOSE RAFAEL. Vicepresid.: HERNANDEZ ALCALA JOSE RAFAEL.VsecrNoConsj: ALCARAZ IBAÑEZ MARIA VICTORIA. Apo.Sol.: HERNANDEZ ALCALA JOSE RAFAEL. Datos registrales. T 2019 ,F 8, S 8, H CA 583, I/A 46 (23.10.15).

28 de Octubre de 2015
Página web de la sociedad. Modificación de la página web corporativa.Nueva página web: www.clubgolfnovosanctipetri.com. Datosregistrales. T 2019 , F 7, S 8, H CA 583, I/A 44 (20.10.15).

20 de Agosto de 2015
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL;DELOITTE SL. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: MODIFICADO ELARTICULO 19º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 2019 , F 6, S 8, H CA 583, I/A 43 (12.08.15).

04 de Abril de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARAGON GUZMAN MONTSERRAT;HERNANDEZ ALCALA RAFAEL;JONGENBURGER SACHAMARJOLEIN. Apoderado: JONGENBURGER SACHA MARJOLEIN;HERNANDEZ ALCALA RAFAEL;DELGADO MORA RAFAEL.Apo.Man.Soli: ARAGON GUZMAN MONTSERRAT. Nombramientos. Apo.Manc.: LLOBERA BARCELO JAUME. Datos registrales.T 2019 , F 6, S 8, H CA 583, I/A 42 (25.03.13).

19 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROYAL CUPIDO SA;JONGENBURGER SACHA MARJOLEIN;MULLER HANS HERBERT WALTER.Presidente: ROYAL CUPIDO SA. SecreNoConsj: LLOMPART SOLER ALBERTO. Nombramientos. Consejero: ROYAL CUPIDOSA;ROSELLO CERDA RAFAEL;LLOMPART SOLER ALBERTO. Presidente: ROYAL CUPIDO SA. Secretario: LLOMPART SOLERALBERTO. Datos registrales. T 2019 , F 5, S 8, H CA 583, I/A 41 (11.03.13).

05 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BAÑUELOS BERASATEGUI MARIA ESTIBALIZ. Consejero: LIENHARD BERN;CUNTZ JURGENH. Presidente: JONGENBURGER SACHA MARJOLEIN. Nombramientos. SecreNoConsj: LLOMPART SOLER ALBERTO.Presidente: ROYAL CUPIDO SA. Apo.Man.Soli: VAZQUEZ VILLA AURELIO MANUEL;VERA DOLS ANTONIO;BENNASAR MARROIGBARTOLOME;BIBILONI CALAFELL BERNARDINO;ARNAU SIERRA JOSE;CIBEIRA MOREIRAS ROBERTO. Apo.Sol.: COSTOYABARREIRO JUAN CARLOS. Apo.Manc.: VAZQUEZ VILLA AURELIO MANUEL;VERA DOLS ANTONIO;MOSCARDO COVO

15 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: GRUND THOMAS. Datos registrales. T 2019 , F 1, S 8, H CA 583, I/A 38 ( 2.11.11).

Nombramientos. Apoderado: DELGADO MORA RAFAEL. Datos registrales. T 2019 , F 2, S 8, H CA 583, I/A 39 ( 2.11.11).

03 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: JONGENBURGER SACHA. Presidente: JONGENBURGER SACHA. Consejero: LIENHARD BERN.Nombramientos. Consejero: JONGENBURGER SACHA MARJOLEIN;LIENHARD BERN;CUNTZ JURGEN H.;MULLER HANSHERBERT WALTER. Presidente: JONGENBURGER SACHA MARJOLEIN. Modificaciones estatutarias. Refundición de losestatutos sociales.. Datos registrales. T 1898 , F 121, S 8, H CA 583, I/A 37 (22.07.11).

10 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JONGENBURGER SACHA MARJOLEIN;ARAGON GUZMAN MONTSERRAT;HERNANDEZALCALA RAFAEL. Datos registrales. T 1898 , F 120, S 8, H CA 583, I/A 34 (31.01.11).

Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ ALCALA RAFAEL;JONGENBURGER SACHA MARJOLEIN. Datos registrales. T 1898 ,F 120, S 8, H CA 583, I/A 35 (31.01.11).

21 de Enero de 2011
Revocaciones. Apo.Manc.: RUIZ CORTINA SIERRA ALEJANDRO. Apo.Sol.: RUIZ CORTINA SIERRA ALEJANDRO. Apo.Man.Soli:BORN UWE R. Apo.Manc.: BORN UWE R. Apoderado: JONGENBURGER SACHA. Apo.Manc.: BORN UWE R;BORN UWER;JONGERBURGER SACHA. Apo.Man.Soli: ARAGON GUZMAN MONTSERRAT. Datos registrales. T 1898 , F 119, S 8, H CA 583,I/A 33 (11.01.11).

20 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: HANNELORE SOKELAN GISELA. Datos registrales. T 1898 , F 119, S 8, H CA 583, I/A 31 (9.12.10).

11 de Junio de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARAGON GUZMAN MONTSERRAT. Apo.Manc.: BORN UWE R. Datos registrales. T 1898 , F 119,S 8, H CA 583, I/A 30 (31.05.10).

21 de Abril de 2010
Nombramientos. SecreNoConsj: BAÑUELOS BERASATEGUI MARIA ESTIBALIZ. Datos registrales. T 1898 , F 118, S 8, H CA583, I/A 30 ( 8.04.10).

19 de Enero de 2010
Ceses/Dimisiones. Secretario: ORY CRISTELLY ADRIANO. Datos registrales. T 1898 , F 118, S 8, H CA 583, I/A 29 (22.12.09).

05 de Enero de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: RUIZ CORTINA SIERRA ALEJANDRO. Datos registrales. T 1898 , F 118, S 8, H CA 583, I/A 28(18.12.09).

09 de Octubre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ BUENO BEGOÑA;SANTOS CARRASCO IGNACIO. Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SA. Datos registrales. T 1898 , F 118, S 8, H CA 583, I/A 27 (29.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información