Actos BORME de Goma Camps Sociedad Anonima
14 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apoderado: GOM.-CAMPS LLADO LAIA. Datos registrales. T 3203 , F 100, S 8, H T 4511, I/A 100 ( 7.09.23).
09 de Mayo de 2023Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 4.634.052,57 Euros. Desembolsado: 4.634.052,57 Euros. Resultante Suscrito: 6.905.075,31 Euros.Resultante Desembolsado: 6.905.075,31 Euros. Datos registrales. T 3203 , F 99, S 8, H T 4511, I/A 99 (27.04.23).
29 de Noviembre de 2022Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. Nombramientos. Auditor:AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP. Datos registrales. T 3203 , F 99, S 8, H T 4511, I/A 98 (22.11.22).
30 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: GOM.-CAMPS LLADO LAIA. Datos registrales. T 3203 , F 98, S 8, H T 4511, I/A 96 (22.08.22).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SALELLES FRANCISCO XAVIER. Datos registrales. T 3203 , F 99, S 8, H T 4511, I/A 97(22.08.22).
18 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: LATRE LUNA MIGUEL ANTONIO. Datos registrales. T 3203 , F 98, S 8, H T 4511, I/A 94 ( 4.05.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BAIGES SANCHEZ NEREA;JIMENEZ SANCHEZ JENIFER. Datos registrales. T 3203 , F 98, S 8,H T 4511, I/A 95 ( 4.05.22).
10 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: GOMA CAMPS LLORENS FERRAN;GOMA-CAMPS TRAVE JORDI;OLLE TENAS JOSEP. Datosregistrales. T 3203 , F 98, S 8, H T 4511, I/A 93 ( 2.03.22).
22 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GOMA CAMPS REBOLTOS MATIAS. Nombramientos. Adm. Unico: GOMA-CAMPS REBOLTOSMATIES. Datos registrales. T 3203 , F 98, S 8, H T 4511, I/A 92 (13.07.21).
22 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: LATRE LUNA MIGUEL ANTONIO. Datos registrales. T 3012 , F 47, S 8, H T 4511, I/A 91 (15.06.20).
24 de Febrero de 2020Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITE SL. Nombramientos. Auditor: AUDRIA AUDITORIA YCONSULTORIA SLP. Datos registrales. T 3012 , F 47, S 8, H T 4511, I/A 90 (17.02.20).
14 de Agosto de 2019Nombramientos. Apoderado: GOMA-CAMPS LLORENS JORDI. Datos registrales. T 3012 , F 46, S 8, H T 4511, I/A 89 ( 7.08.19).
27 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: PASCUAL CLARAMUNT JUAN MARCOS. Datos registrales. T 3012 , F 45, S 8, H T 4511, I/A 88(17.05.19).
01 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: VALENZUELA JIMENEZ JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 3012 , F 44, S 8, H T 4511, I/A 87(22.02.19).
16 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ BASTERO LUIS ALFONSO. Datos registrales. T 3012 , F 44, S 8, H T 4511, I/A 86 (9.11.18).
09 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALDEGUER JAVIER. Datos registrales. T 3012 , F 44, S 8, H T 4511, I/A 84 ( 2.07.18).
Nombramientos. Apoderado: PASCUAL CLARAMUNT JUAN MARCOS. Datos registrales. T 3012 , F 44, S 8, H T 4511, I/A 85 (2.07.18).
09 de Febrero de 2018Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ PEREZ DAVID;GUTIERREZ PEREZ DAVID;CANALES OLIVERAS JORDI. Datosregistrales. T 3012 , F 43, S 8, H T 4511, I/A 83 ( 2.02.18).
26 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ PEREZ DAVID. Datos registrales. T 1987 , F 154, S 8, H T 4511, I/A 72 (18.04.17).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CASANOVAS ALBERT JOSEP. Datos registrales. T 3012 , F 42, S 8, H T 4511, I/A 73(18.04.17).
Nombramientos. Apoderado: FORASTER ADSERA NURIA. Datos registrales. T 3012 , F 42, S 8, H T 4511, I/A 74 (18.04.17).
Nombramientos. Apoderado: RUBIO GOMEZ OLGA ROSA. Datos registrales. T 3012 , F 42, S 8, H T 4511, I/A 75 (18.04.17).
Nombramientos. Apoderado: GOMA-CAMPS OLLE ORIOL. Datos registrales. T 3012 , F 42, S 8, H T 4511, I/A 76 (18.04.17).
Nombramientos. Apoderado: GOMA-CAMPS TRAVE JORDI. Datos registrales. T 3012 , F 42, S 8, H T 4511, I/A 77 (18.04.17).
Nombramientos. Apoderado: GOMA-CAMPS LLADO LAIA. Datos registrales. T 3012 , F 42, S 8, H T 4511, I/A 78 (18.04.17).
Nombramientos. Apoderado: FALCON NAVARRO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3012 , F 43, S 8, H T 4511, I/A 79(18.04.17).
Nombramientos. Apoderado: CANALES OLIVERAS JORDI. Datos registrales. T 3012 , F 43, S 8, H T 4511, I/A 80 (18.04.17).
Nombramientos. Apoderado: OLLE TENAS JOSEP. Datos registrales. T 3012 , F 43, S 8, H T 4511, I/A 81 (18.04.17).
Nombramientos. Apoderado: CISA MERCADE MARIA TERESA. Datos registrales. T 3012 , F 43, S 8, H T 4511, I/A 82 (18.04.17).
16 de Diciembre de 2016Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: RSM GASSO AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: DELOITE SL.Datos registrales. T 1987 , F 154, S 8, H T 4511, I/A 71 ( 7.12.16).
02 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMA-CAMPS OLLE ORIOL;GOMA CAMPS LLORENS JORDI. Presidente: GOMA CAMPSLLORENS JORDI. Consejero: GOMA CAMPS REBOLTOS JOSEP. Vicepresid.: GOMA CAMPS REBOLTOS JOSEP. Consejero:POMAROL CLOTET JORDI;GOMA CAMPS LLORENS FERRAN. Vicesecret.: GOMA CAMPS LLORENS FERRAN. Secretario:
10 de Mayo de 2016Revocaciones. Apoderado: SOLE ROVIRA MAGI. Datos registrales. T 1987 , F 153, S 8, H T 4511, I/A 69 (25.04.16).
21 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ BASTERO LUIS ALFONSO. Datos registrales. T 1987 , F 151, S 8, H T 4511, I/A 68(13.04.16).
24 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CHAGAS DA SILVA PERETRA JOAO MANUEL. Datos registrales. T 1987 , F 151, S 8, H T 4511,I/A 67 (17.11.15).
06 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Secretario: SORRIBAS MARGELI SILVIA. Nombramientos. Secretario: RODRIGUEZ SANCHEZ SUSANA.Datos registrales. T 1987 , F 151, S 8, H T 4511, I/A 66 (28.07.14).
19 de Septiembre de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: GASSO AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: RSM GASSOAUDITORES SLP. Datos registrales. T 1987 , F 150, S 8, H T 4511, I/A 65 ( 9.09.13).
05 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMA CAMPS LLORENS JORDI. Presidente: GOMA CAMPS LLORENS JORDI. Consejero: GOMACAMPS REBOLTOS JOSEP. Vicepresid.: GOMA CAMPS REBOLTOS JOSEP. Consejero: GOMA CAMPS REBULTOSMATIES;POMAROL CLOTET JORDI;CHAGAS DA SILVA PERETRA JOAO MANUEL;GOMA CAMPS LLORENS FERRAN.Vicesecret.: GOMA CAMPS LLORENS FERRAN. Nombramientos. Consejero: GOMA CAMPS LLORENS JORDI. Presidente:GOMA CAMPS LLORENS JORDI. Consejero: GOMA CAMPS REBOLTOS JOSEP. Vicepresid.: GOMA CAMPS REBOLTOS JOSEP.Consejero: POMAROL CLOTET JORDI;CHAGAS DA SILVA PERETRA JOAO MANUEL;GOMA CAMPS LLORENS FERRAN.Vicesecret.: GOMA CAMPS LLORENS FERRAN. Datos registrales. T 1987 , F 150, S 8, H T 4511, I/A 64 (29.08.13).
20 de Marzo de 2013Nombramientos. Apoderado: BOADA AGUADE ANTON;LOPEZ CASANOVAS ALBERTO JOSE. Datos registrales. T 1987 , F 138,S 8, H T 4511, I/A 62 ( 4.03.13).
Revocaciones. Apoderado: BOADA AGUADE ANTON. Datos registrales. T 1987 , F 150, S 8, H T 4511, I/A 63 ( 4.03.13).
22 de Enero de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.200.040,74 Euros. Desembolsado: 1.200.040,74 Euros. Resultante Suscrito: 2.271.022,74 Euros.Resultante Desembolsado: 2.271.022,74 Euros. Datos registrales. T 1987 , F 137, S 8, H T 4511, I/A 61 (14.01.13).
21 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: GOMA CAMPS REBOLTOS MATIES. Nombramientos. Secretario: SORRIBAS MARGELI SILVIA.Datos registrales. T 1987 , F 137, S 8, H T 4511, I/A 59 (12.12.12).
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: GASSO AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: GASSO AUDITORESSL. Datos registrales. T 1987 , F 137, S 8, H T 4511, I/A 60 (12.12.12).
26 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: OLLE RIBE MONTSERRAT. SecreNoConsj: ESPARTERO VELASCO BORJA MONTESINO.Nombramientos. Secretario: GOMA CAMPS REBOLTOS MATIES. Consejero: GOMA-CAMPS OLLE ORIOL. Datos registrales. T1987 , F 136, S 8, H T 4511, I/A 58 (14.03.12).
04 de Octubre de 2011Revocaciones. Apoderado: MIRO VIU SALVADOR;MIRO VIU SALVADOR;SANCHEZ PEREZ FRANCISCO. Datos registrales. T1987 , F 136, S 8, H T 4511, I/A 57 (26.09.11).
17 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: GOMA CAMPS REBOLTOS JOSEP. Datos registrales. T 1987 , F 136, S 8, H T 4511, I/A 56 (3.05.11).
24 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ PEREZ DAVID. Datos registrales. T 1987 , F 135, S 8, H T 4511, I/A 55 (10.01.11).