Buscador CIF Logo

Actos BORME Gomez Acebo & Pombo Abogados Slp

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gomez Acebo & Pombo Abogados Slp

Actos BORME Gomez Acebo & Pombo Abogados Slp - B81089328

Tenemos registrados 66 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gomez Acebo & Pombo Abogados Slp con CIF B81089328

馃敊 Perfil de Gomez Acebo & Pombo Abogados Slp
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gomez Acebo & Pombo Abogados Slp

08 de Marzo de 2023
Nombramientos. Soc.Prof.: PI脩EL RUBIO AUGUSTO ADRIAN;RIOPEREZ GALLEGOS DAVID;AREVALO GONZALEZ IRENEMAITE;DIAZ-MORO PARAJA MARIANA;DEL FRAILE LOPEZ IGNACIO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.770,00 Euros. ResultanteSuscrito: 36.346,00 Euros. Datos registrales. T 33783 , F 193, S 8, H M 368387, I/A 98 ( 1.03.23).

16 de Agosto de 2022
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALESSL. Datos registrales. T 33783 , F 191, S 8, H M 368387, I/A 96 ( 8.08.22).

Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 10,11,13,14 y 16. Datos registrales. T 33783 , F 191, S 8, H M368387, I/A 97 ( 8.08.22).

28 de Julio de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALAN SILBERSTEIN RICHARD. Apoderado: ALAN SILBERSTEIN RICHARD. Apo.Man.Soli: MARINMORENO DANIEL. Apo.Manc.: MARTIN MARTIN MANUEL;ULLOA SUELVES GONZALO;IGARTUA ARREGUI FERNANDO;PE脩AGONZALEZ FRANCISCO;ROMANI SANCHO VERONICA;RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS JOAQUIN;SARMENTOALBANO;VARELA VARAS ANGEL. Apoderado: CHICOTE DIAZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 33783 , F 191, S 8, H M368387, I/A 95 (20.07.22).

29 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARRETO SILVA TAVARES MAFALDA ISABEL. Secretario: ERLAIZ COTELO I脩IGO.Nombramientos. Consejero: ROMANI SANCHO VERONICA;MARIN MORENO DANIEL. Con.Delegado: ERLAIZ COTELO I脩IGO.Secretario: WEIMANN GOMEZ MONICA. Consejero: MATEO SIXTO ALVARO. Reelecciones. Consejero: LAMO DE ESPINOSAABARCA MIGUEL;ERLAIZ COTELO I脩IGO;WEIMANN GOMEZ MONICA;MARTIN MARTIN MANUEL JOSE;RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS. Presidente: RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS. Con.Delegado: RUEDA GOMEZ-CALCERRADACARLOS. Datos registrales. T 33783 , F 190, S 8, H M 368387, I/A 94 (22.04.22).

16 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Soc.Prof.: ARPON DE MENDIVIL Y DE ALDAMA ALMUDENA;FERNANDEZ LLEDO VANESSA;HERREROSUAREZ FERNANDO;DE AVILLEZ PEREIRA MIGUEL;CASTRO PEREIRA MIGUEL. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.534,00

22 de Noviembre de 2021
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.888,00 Euros. Resultante Suscrito: 33.042,00 Euros. Datos registrales. T 33783 , F 187, S 8, H M368387, I/A 92 (15.11.21).

27 de Agosto de 2021
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALESSL. Datos registrales. T 33783 , F 187, S 8, H M 368387, I/A 91 (20.08.21).

04 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apoderado: SANTOS OLIETE CRISTINA. Datos registrales. T 33783 , F 186, S 8, H M 368387, I/A 89 (28.07.21).

Revocaciones. Apoderado: URIARTE PEREZ MOREIRAS MARIA TERESA. Datos registrales. T 33783 , F 187, S 8, H M 368387,I/A 90 (28.07.21).

24 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALESSL. Datos registrales. T 33783 , F 186, S 8, H M 368387, I/A 88 (17.11.20).

06 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALESSL. Datos registrales. T 33783 , F 186, S 8, H M 368387, I/A 87 (29.10.19).

04 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN MARTIN MANUEL JOSE;WEIMANN GOMEZ MONICA;LAMO DE ESPINOSA ABARCAMIGUEL. Secretario: ERLAIZ COTELO I脩IGO. Consejero: ERLAIZ COTELO I脩IGO;MARIN MORENO DANIEL. Cons.Del.Man: MARINMORENO DANIEL;ERLAIZ COTELO I脩IGO;RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS. Cons.Del.Sol: MARTIN MARTIN MANUELJOSE. Presidente: MARTIN MARTIN MANUEL JOSE. Cons.Del.Sol: RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS. Cons.Del.Man:MARTIN MARTIN MANUEL JOSE;WEIMANN GOMEZ MONICA;LAMO DE ESPINOSA ABARCA MIGUEL. Nombramientos.Presidente: RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS. Con.Delegado: RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS. Secretario: ERLAIZCOTELO I脩IGO. Datos registrales. T 33783 , F 185, S 8, H M 368387, I/A 86 (28.05.19).

30 de Mayo de 2019
Nombramientos. Consejero: BARRETO SILVA TAVARES MAFALDA ISABEL;LAMO DE ESPINOSA ABARCA MIGUEL;ERLAIZCOTELO I脩IGO;WEIMANN GOMEZ MONICA;MARTIN MARTIN MANUEL JOSE. Reelecciones. Consejero: RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS. Datos registrales. T 33783 , F 185, S 8, H M 368387, I/A 85 (22.05.19).

14 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: WEIMANN GOMEZ MONICA. Nombramientos. Apoderado: FOIX MIRALLES FERRAN. Datosregistrales. T 33783 , F 183, S 8, H M 368387, I/A 83 ( 6.11.18).

Nombramientos. Apoderado: BARRETO SILVA TABARES MAFALDA ISABEL. Datos registrales. T 33783 , F 184, S 8, H M368387, I/A 84 ( 6.11.18).

14 de Septiembre de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BELLIDO MENGUAL MANUEL;BRAVO DE LAGUNA JOSE MIGUEL;VARELA VARASANGEL;ALVAREZ ARJONA JOSE MARIA;PALMA FERNANDEZ JOSE LUIS;IGARTUA ARREGUI I脩IGO. Apoderado: IGARTUAARREGUI I脩IGO;VARELA VARAS ANGEL;PALMA FERNANDEZ JOSE LUIS;BRAVO DE LAGUNA JOSE MIGUEL;GARCIACALLEJA CONRADO;SAN ANDRES GARCIA JUAN FRANCISCO;SAN ANDRES GARCIA JUAN. Datos registrales. T 33783 , F182, S 8, H M 368387, I/A 81 (30.08.18).

Reelecciones. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALESSL. Datos registrales. T 33783 , F 182, S 8, H M 368387, I/A 82 (30.08.18).

28 de Julio de 2017
Nombramientos. Apoderado: URIARTE PEREZ MOREIRAS MARIA TERESA. Datos registrales. T 33783 , F 182, S 8, H M 368387,I/A 80 (20.07.17).

30 de Enero de 2017
Nombramientos. Aud.C.Con.: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 33783 , F181, S 8, H M 368387, I/A 79 (23.01.17).

10 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN MARTIN MANUEL;PE脩A GONZALEZ FRANCISCO;ROMANI SANCHO VERONICA;RUEDAGOMEZ-CALCERRADA CARLOS JOAQUIN;SARMENTO ALBANO NUNES DE ALMEIDA;VARELA VARAS ANGEL. Co.De.Ma.So:MARTIN MARTIN MANUEL JOSE. Cons.Del.Man: PE脩A GONZALEZ FRANCISCO;VARELA VARAS ANGEL;ROMANI SANCHOVERONICA;RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS JOAQUIN. Presidente: DE ULLOA Y SUELVES GONZALO. Consejero: DEULLOA Y SUELVES GONZALO;ERLAIZ COTELO I脩IGO;LAMO DE ESPINOSA ABARCA MIGUEL. Secretario: ERLAIZ COTELO

22 de Febrero de 2016
Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 33783 , F 180, S 8, H M 368387,I/A 77 (12.02.16).

28 de Diciembre de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 944,00 Euros. Resultante Suscrito: 35.636,00 Euros. Datos registrales. T 29825 , F 110,S 8, H M 368387, I/A 75 (16.12.15).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.482,00 Euros. Resultante Suscrito: 31.154,00 Euros. Datos registrales. T 29825 , F 110,S 8, H M 368387, I/A 76 (16.12.15).

04 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: IGARTUA ARREGUI FERNANDO. Reelecciones. Consejero: IGARTUA ARREGUI FERNANDO.Vicepresid.: IGARTUA ARREGUI FERNANDO. Datos registrales. T 29825 , F 110, S 8, H M 368387, I/A 74 (23.04.15).

29 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LAMO DE ESPINOSA ABARCA MIGUEL. Nombramientos. Apoderado: WEIMANN GOMEZMONICA. Datos registrales. T 29825 , F 108, S 8, H M 368387, I/A 73 (17.04.15).

29 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Secretario: RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS JOAQUIN. Nombramientos. Consejero: ERLAIZCOTELO I脩IGO;LAMO DE ESPINOSA ABARCA MIGUEL. Secretario: ERLAIZ COTELO I脩IGO. Modificaciones estatutarias. -Modificaci贸n del art铆culo 15潞 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 29825 , F 108, S 8, H M 368387, I/A 72 (19.01.15).

23 de Octubre de 2014
Nombramientos. R.L.C.Per.M.: RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS JOAQUIN. Apoderado: RUEDA GOMEZ-CALCERRADACARLOS JOAQUIN. Datos registrales. T 29825 , F 107, S 8, H M 368387, I/A 71 (16.10.14).

30 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: CHICOTE DIAZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 29825 , F 106, S 8, H M 368387, I/A 68(21.07.14).

Nombramientos. Apoderado: SAIZ ESTEBAN JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 29825 , F 106, S 8, H M 368387, I/A 69(21.07.14).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: DE ULLOA Y SUELVES GONZALO. Cons.Del.Man: DE ULLOA Y SUELVES GONZALO.Reelecciones. Presidente: DE ULLOA Y SUELVES GONZALO. Consejero: DE ULLOA Y SUELVES GONZALO. Datos registrales.T 29825 , F 107, S 8, H M 368387, I/A 70 (21.07.14).

11 de Julio de 2014
Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 61& LA PUBLICACION DEL CESE DEL CONSEJERO MARTINMARTIN MANUEL JOSE NOMBRADO EN LA INSCRIPCION 43&. Datos registrales. T 29825 , F 102, S 8, H M 368387, I/A 61(19.03.13).

30 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: SAIZ ESTEBAN JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 29825 , F 105, S 8, H M 368387, I/A 67(18.06.14).

04 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARIN MORENO DANIEL. Apo.Manc.: MARTIN MARTIN MANUEL;ULLOA SUELVESGONZALO;IGARTUA ARREGUI FERNANDO;PE脩A GONZALEZ FRANCISCO;ROMANI SANCHO VERONICA;RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS JOAQUIN;SARMENTO ALBANO;VARELA VARAS ANGEL. Datos registrales. T 29825 , F 104, S 8, H M368387, I/A 66 (23.01.14).

30 de Septiembre de 2013
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los articulos 5潞. Capital social, 7潞 Transmisi贸n de participaciones o del derecho deasunci贸n preferente, 9潞 Voto. . Datos registrales. T 29825 , F 104, S 8, H M 368387, I/A 65 (23.09.13).

21 de Junio de 2013
Nombramientos. Apoderado: SAN ANDRES GARCIA JUAN. Datos registrales. T 29825 , F 103, S 8, H M 368387, I/A 64(13.06.13).

27 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA ROMANILLOS VALVERDE JOAQUIN;RUEDA GOMEZ CALCERRADA CARLOS. Secretario:RUEDA GOMEZ CALCERRADA CARLOS. Nombramientos. Consejero: MARTIN MARTIN MANUEL;PE脩A GONZALEZFRANCISCO;ROMANI SANCHO VERONICA;RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS JOAQUIN;SARMENTO ALBANO NUNES DEALMEIDA;VARELA VARAS ANGEL. Datos registrales. T 29825 , F 102, S 8, H M 368387, I/A 61 (19.03.13).

Nombramientos. Secretario: RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS JOAQUIN. Cons.Del.Sol: DE ULLOA Y SUELVESGONZALO. Cons.Del.Man: PE脩A GONZALEZ FRANCISCO;VARELA VARAS ANGEL;NUNES DE ALMEIDA SARMENTOALBANO;ROMANI SANCHO VERONICA;RUEDA GOMEZ-CALCERRADA CARLOS JOAQUIN. Reelecciones. Co.De.Ma.So:MARTIN MARTIN MANUEL JOSE. Cons.Del.Man: IGARTUA ARREGUI FERNANDO. Datos registrales. T 29825 , F 102, S 8, H M368387, I/A 62 (19.03.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA DE LA CONCHA MARIA. Apo.Sol.: GARCIA DE LA CONCHA MARIA. Datos registrales. T29825 , F 102, S 8, H M 368387, I/A 63 (20.03.13).

19 de Diciembre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.180,00 Euros. Resultante Suscrito: 39.236,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n:2.950,00 Euros. Resultante Suscrito: 36.286,00 Euros. Datos registrales. T 29825 , F 100, S 8, H M 368387, I/A 59 (11.12.12).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 294,00 Euros. Resultante Suscrito: 36.580,00 Euros. Datos registrales. T 29825 , F 101, S 8, H M368387, I/A 60 (11.12.12).

08 de Agosto de 2012
Nombramientos. Consejero: IGARTUA ARREGUI FERNANDO. Reelecciones. Consejero: GARCIA ROMANILLOS VALVERDEJOAQUIN;RUEDA GOMEZ CALCERRADA CARLOS. Datos registrales. T 27059 , F 54, S 8, H M 368387, I/A 57 (27.07.12).

Nombramientos. Vicepresid.: IGARTUA ARREGUI FERNANDO. Cons.Del.Man: IGARTUA ARREGUI FERNANDO. Reelecciones.Secretario: RUEDA GOMEZ CALCERRADA CARLOS. Datos registrales. T 29825 , F 100, S 8, H M 368387, I/A 58 (27.07.12).

30 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: POMBO GARCIA FERNANDO. Presidente: POMBO GARCIA FERNANDO. Co.De.Ma.So: POMBOGARCIA FERNANDO. Vicepresid.: DE ULLOA Y SUELVES GONZALO. Nombramientos. Presidente: DE ULLOA Y SUELVESGONZALO. Datos registrales. T 27059 , F 54, S 8, H M 368387, I/A 56 (20.03.12).

13 de Diciembre de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.066,00 Euros. Resultante Suscrito: 39.590,00 Euros. Datos registrales. T 27059 , F 52, S 8, H M368387, I/A 54 (29.11.11).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.534,00 Euros. Resultante Suscrito: 38.056,00 Euros. Datos registrales. T 27059 , F 53,S 8, H M 368387, I/A 55 (29.11.11).

07 de Junio de 2011
Nombramientos. Cons.Del.Sol: DE ULLOA Y SUELVES GONZALO. Datos registrales. T 27059 , F 52, S 8, H M 368387, I/A 53(26.05.11).

12 de Abril de 2011
Reelecciones. Auditor: A E A AUDITORES DE EMPRESAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 27059 , F 51, S 8, H M 368387,I/A 52 (31.03.11).

17 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: LUCAS MURILLO DE LA CUEVA ENRIQUE;AREITIO BASAGOITI ALFONSO. Datos registrales. T27059 , F 49, S 8, H M 368387, I/A 49 ( 7.03.11).

Nombramientos. Consejero: DE ULLOA Y SUELVES GONZALO. Datos registrales. T 27059 , F 50, S 8, H M 368387, I/A 50 (7.03.11).

Nombramientos. Vicepresid.: DE ULLOA Y SUELVES GONZALO. Datos registrales. T 27059 , F 51, S 8, H M 368387, I/A 51 (7.03.11).

02 de Febrero de 2011
Modificaciones estatutarias. 5. Capital.-. Datos registrales. T 27059 , F 48, S 8, H M 368387, I/A 47 (21.01.11).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.124,00 Euros. Resultante Suscrito: 37.524,00 Euros. Datos registrales. T 27059 , F 49, S 8, H M368387, I/A 48 (21.01.11).

03 de Enero de 2011
Reelecciones. Auditor: A E A AUDITORES DE EMPRESAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 27059 , F 48, S 8, H M 368387,I/A 46 (23.12.10).

05 de Noviembre de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 80,00 Euros. Resultante Suscrito: 35.320,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 80,00Euros. Resultante Suscrito: 35.400,00 Euros. Datos registrales. T 27059 , F 47, S 8, H M 368387, I/A 45 (25.10.10).

28 de Abril de 2010
Nombramientos. Consejero: NUNES DE ALMEIDA SARMENTO ALBANO. Datos registrales. T 27059 , F 47, S 8, H M 368387, I/A44 (16.04.10).

15 de Febrero de 2010
Nombramientos. Cons.Del.Man: GARCIA ROMANILLOS VALVERDE JOAQUIN;RUEDA GOMEZ CALCERRADA CARLOS.Reelecciones. Consejero: POMBO GARCIA FERNANDO;MARTIN MARTIN MANUEL JOSE. Presidente: POMBO GARCIAFERNANDO. Co.De.Ma.So: MARTIN MARTIN MANUEL JOSE;POMBO GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 27059 , F 46, S8, H M 368387, I/A 43 ( 3.02.10).

05 de Febrero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.838,00 Euros. Resultante Suscrito: 35.400,00 Euros. Datos registrales. T 27059 , F 45, S 8, H M368387, I/A 42 (26.01.10).

08 de Enero de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAMO DE ESPINOSA ABARCA MIGUEL. Datos registrales. T 27059 , F 44, S 8, H M 368387, I/A41 (28.12.09).

31 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: GARCIA CALLEJA CONRADO. Datos registrales. T 27059 , F 42, S 8, H M 368387, I/A 39 (18.12.09).

Nombramientos. Apoderado: SAN ANDRES GARCIA JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 27059 , F 43, S 8, H M 368387, I/A40 (18.12.09).

30 de Octubre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 25.212,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.562,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedadesabsorbidas: GAPO SL. Datos registrales. T 21604 , F 139, S 8, H M 368387, I/A 38 (20.10.09).

05 de Octubre de 2009
Reelecciones. Auditor: A E A AUDITORES DE EMPRESAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 21604 , F 139, S 8, H M 368387,I/A 37 (24.09.09).

23 de Abril de 2009
Revocaciones. Apoderado: GARCIA CASTILLO ANNA. Nombramientos. Apoderado: TRONCOSO FERRER MIGUEL. Datosregistrales. T 21604 , F 136, S 8, H M 368387, I/A 34 (13.04.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MU脩OZ DELGADO MERIDA JESUS;FITA TORTOSA FRANCISCO. Cons.Del.Man: FITA TORTOSAFRANCISCO. Secretario: MU脩OZ DELGADO MERIDA JESUS. Cons.Del.Man: MU脩OZ DELGADO MERIDA JESUS.Nombramientos. Consejero: GARCIA ROMANILLOS VALVERDE JOAQUIN;RUEDA GOMEZ CALCERRADA CARLOS. Datosregistrales. T 21604 , F 138, S 8, H M 368387, I/A 35 (13.04.09).

Nombramientos. Secretario: RUEDA GOMEZ CALCERRADA CARLOS. Datos registrales. T 21604 , F 138, S 8, H M 368387, I/A36 (13.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n