Buscador CIF Logo

Actos BORME Gonzalez Byass Distribucion Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Gonzalez Byass Distribucion Sl

Actos BORME Gonzalez Byass Distribucion Sl - B83631226

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Gonzalez Byass Distribucion Sl con CIF B83631226

🔙 Perfil de Gonzalez Byass Distribucion Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Gonzalez Byass Distribucion Sl

16 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ AGUILAR MANUEL;SANCHEZ MORAL CESAR TOMAS. Apo.Man.Soli: ZORIO CESARJUAN CARLOS. Datos registrales. T 42129 , F 7, S 8, H M 319112, I/A 52 ( 8.11.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: MATEOS POMAR SALVE;USERO ROBLES IRENE;ZORIO CESAR JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli:JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GOMEZ VILCHES FRANCISCO JAVIER;MEJIAS BERNAL JUAN DE DIOS;GARZON MORENOLORENZO. Apo.Sol.: ROSADO MOLINA CARMEN;CLAVIJO GARCIA MANUEL JESUS;MATEOS POMAR SALVE;USERO ROBLESIRENE. Datos registrales. T 42129 , F 7, S 8, H M 319112, I/A 53 ( 8.11.23).

01 de Septiembre de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 42129 , F 6, S 8, H M 319112, I/A51 (25.08.23).

21 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GOMEZ VILCHES FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: MEJIASBERNAL JUAN DE DIOS;GARZON MORENO LORENZO. Apo.Sol.: ROSADO MOLINA CARMEN;CLAVIJO GARCIA MANUELJESUS;ACEDO MOLINA JOSE;MATEOS POMAR SALVE;USERO ROBLES IRENE. Datos registrales. T 42129 , F 5, S 8, H M319112, I/A 49 (14.04.23).

17 de Marzo de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: GROSSE MAC DOUGALL JORGE ALBERTO. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ MORALCESAR TOMAS. Datos registrales. T 42129 , F 3, S 8, H M 319112, I/A 47 (10.03.23).

Revocaciones. Apoderado: GROSSE MAC DOUGALL JORGE ALBERTO. Apo.Man.Soli: GROSSE MAC DOUGALL JORGEALBERTO. Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ MORAL CESAR TOMAS. Datos registrales. T 42129 , F 3, S 8, H M 319112, I/A48 (10.03.23).

26 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO GARCIA DELGADO MARIA;GRANADOS CORONA CRISTINA;GOMEZ VILCHESFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 42129 , F 2, S 8, H M 319112, I/A 46 (19.10.22).

22 de Julio de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 42129 , F 2, S 8, H M 319112, I/A45 (15.07.22).

13 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: GROSSE MAC DOUGALL JORGE ALBERTO. Apo.Man.Soli: MARTIN MATEOS MIGUEL. Apo.Manc.:SUAREZ PERDIGONES PEDRO;VALLEJO SAURA GUILLERMO;GARZON MORENO LORENZO;GUERRERO CALDAS IGNACIO.Apoderado: MURILLO SANROMA ENRIQUE;SUAREZ PERDIGONES PEDRO;VALLEJO SAURA GUILLERMO;GARZON MORENOLORENZO;GUERRERO CALDAS IGNACIO. Apo.Man.Soli: MURILLO SANROMA ENRIQUE;SUAREZ PERDIGONES PEDRO.Apo.Manc.: VALLEJO SAURA GUILLERMO;GARZON MORENO LORENZO. Apo.Sol.: CLAVIJO GARCIA MANUEL JESUS.Apoderado: SUAREZ PERDIGONES PEDRO. Apo.Man.Soli: JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Apo.Manc.: SUAREZ PERDIGONESPEDRO;MEJIAS BERNAL JUAN DE DIOS;GARZON MORENO LORENZO. Datos registrales. T 42129 , F 1, S 8, H M 319112, I/A 44( 6.06.22).

09 de Julio de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 42129 , F 1, S 8, H M 319112, I/A43 ( 2.07.21).

23 de Junio de 2021
Nombramientos. Consejero: ZORIO CESAR JUAN CARLOS. Reelecciones. Consejero: GONZALEZ-GORDON LOPEZ DECARRIZOSA MAURICIO;REBUELTA DEL PEDREDO GONZALEZ PEDRO;GROSSE MAC DOUGALL JORGE ALBERTO. Presidente:

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GROSSE MAC DOUGALL JORGE ALBERTO;JIMENEZ AGUILAR MANUEL;GOMEZ VILCHESFRANCISCO JAVIER;MEJIAS BERNAL JUAN DE DIOS;GARZON MORENO LORENZO. Apo.Sol.: ROSADO MOLINACARMEN;CLAVIJO GARCIA MANUEL JESUS;MATEOS POMAR SALVE;USERO ROBLES IRENE. Datos registrales. T 23027 , F18, S 8, H M 319112, I/A 42 (16.06.21).

10 de Septiembre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23027 , F 17, S 8, H M 319112, I/A40 ( 3.09.20).

14 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23027 , F 17, S 8, H M 319112, I/A39 ( 7.10.19).

05 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23027 , F 17, S 8, H M 319112, I/A38 (25.10.18).

06 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ AGUILAR MANUEL. Apo.Sol.: ZORIO CESAR JUAN CARLOS. Apo.Manc.: SUAREZPERDIGONES PEDRO;MEJIAS BERNAL JUAN DE DIOS;GARZON MORENO LORENZO. Datos registrales. T 23027 , F 14, S 8, HM 319112, I/A 37 (25.08.17).

01 de Junio de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23027 , F 14, S 8, H M 319112, I/A36 (25.05.17).

10 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ-GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA MAURICIO. Presidente: GONZALEZ-GORDONLOPEZ DE CARRIZOSA MAURICIO. Consejero: REBUELTA DEL PEDREDO GONZALEZ PEDRO;GROSSE MAC DOUGALL JORGEALBERTO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ-GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA MAURICIO;REBUELTA DEL PEDREDOGONZALEZ PEDRO;GROSSE MAC DOUGALL JORGE ALBERTO. Presidente: GONZALEZ-GORDON LOPEZ DE CARRIZOSAMAURICIO. Datos registrales. T 23027 , F 14, S 8, H M 319112, I/A 35 ( 1.06.16).

31 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: SUAREZ PERDIGONES PEDRO. Datos registrales. T 23027 , F 13, S 8, H M 319112, I/A 34(23.07.14).

07 de Mayo de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23027 , F 13, S 8, H M 319112, I/A33 (25.04.14).

29 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ MARTIN JUAN MANUEL;BELLIDO PEREZ FRANCISCA. Datos registrales. T 23027 , F 12,S 8, H M 319112, I/A 32 (14.08.13).

26 de Abril de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23027 , F 12, S 8, H M 319112, I/A31 (18.04.13).

25 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MURILLO SANROMA ENRIQUE;SUAREZ PERDIGONES PEDRO. Apo.Manc.: VALLEJO SAURAGUILLERMO;GARZON MORENO LORENZO. Apo.Sol.: CLAVIJO GARCIA MANUEL JESUS;MATEOS POMAR SALVE;USEROROBLES IRENE. Datos registrales. T 23027 , F 11, S 8, H M 319112, I/A 30 (15.02.13).

14 de Enero de 2013
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MARTIN JUAN MANUEL. Datos registrales. T 23027 , F 11, S 8, H M 319112, I/A 29 (3.01.13).

03 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ HERRERO SOLEDAD;DOMINGUEZ DELGADO ANA. Datos registrales. T 23027 , F 11, S 8, HM 319112, I/A 28 (23.07.12).

06 de Julio de 2012
Nombramientos. Apoderado: GROSSE MAC DOUGALL JORGE ALBERTO;MURILLO SANROMA ENRIQUE;SUAREZPERDIGONES PEDRO;VALLEJO SAURA GUILLERMO;GARZON MORENO LORENZO;GUERRERO CALDAS IGNACIO. Datosregistrales. T 23027 , F 8, S 8, H M 319112, I/A 27 (26.06.12).

27 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA MAURICIO;REBUELTA DEL PEDREDO GONZALEZPEDRO;GROSSE MAC DOUGALL JORGE ALBERTO. Presidente: GONZALEZ GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA MAURICIO.Nombramientos. Consejero: GONZALEZ-GORDON LOPEZ DE CARRIZOSA MAURICIO. Presidente: GONZALEZ-GORDON LOPEZDE CARRIZOSA MAURICIO. Consejero: REBUELTA DEL PEDREDO GONZALEZ PEDRO;GROSSE MAC DOUGALL JORGEALBERTO. Datos registrales. T 23027 , F 8, S 8, H M 319112, I/A 26 (15.06.11).

10 de Mayo de 2011
Cambio de domicilio social. C/ ALCALA 21 6& (MADRID). Datos registrales. T 23027 , F 8, S 8, H M 319112, I/A 25 (27.04.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información