Actos BORME de Goya Reo Holding Sl
21 de Agosto de 2020Revocaciones. Apoderado: DIAZ ALVAREZ MAGDALENA ISABEL. Datos registrales. T 33931 , F 168, S 8, H M 610645, I/A 11(14.08.20).
05 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: OSACAR IBARROLA ALBERTO. Nombramientos. Adm. Solid.: SPV SPAIN 5 SL. Representan:OSACAR IBARROLA ALBERTO. Datos registrales. T 33931 , F 168, S 8, H M 610645, I/A 10 (29.01.20).
13 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Nombramientos. Representan: ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIAGUADALUPE. Datos registrales. T 33931 , F 167, S 8, H M 610645, I/A 9 ( 5.12.18).
13 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apoderado: INTERTRUST (SPAIN) SL;ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIA GUADALUPE;ALVAREZ LLORCAMERCEDES;PUIG RUANO URSULA. Datos registrales. T 33931 , F 167, S 8, H M 610645, I/A 8 ( 5.09.18).
12 de Marzo de 2018Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 41 4ª (MADRID). Datos registrales. T 33931 , F 166, S 8, H M 610645, I/A 7 ( 5.03.18).
13 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RUMBAO REAL JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Solid.: INTERTRUST (SPAIN) SL.Representan: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Datos registrales. T 33931 , F 166, S 8, H M 610645, I/A 6 ( 5.01.17).
05 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CORTINA URDAMPILLETA EVENCIO;HORRIDGE ALASTAIR GILES SPENCER. Nombramientos.Adm. Solid.: OSACAR IBARROLA ALBERTO;RUMBAO REAL JOSE LUIS. Datos registrales. T 33931 , F 166, S 8, H M 610645, I/A5 (28.01.16).
26 de Noviembre de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GOYA DEBTCO DAC. Datos registrales. T 33931 , F 165, S 8, H M610645, I/A 4 (18.11.15).